DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01244813 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?
- Sonstige Telekommunikationsaktivitäten (61900) / Information und Kommunikation
- Beratung im Bereich Informationstechnologie (62020) / Information und Kommunikation
Wo befindet sich DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| NEXTIRAONE SERVICES LIMITED | 01. Nov. 2005 | 01. Nov. 2005 |
| GFI INFORMATICS LIMITED | 02. Jan. 2001 | 02. Jan. 2001 |
| ECS LIMITED | 20. März 1991 | 20. März 1991 |
| ENGINEERING COMPUTER SERVICES LIMITED | 31. Dez. 1976 | 31. Dez. 1976 |
| LOGELTA LIMITED | 17. Feb. 1976 | 17. Feb. 1976 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 24. Okt. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Ms Anne Colette Jacqueline Thonon am 29. Aug. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Paul Francis Cooper als Direktor am 21. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Calvin Paul Wesley Goom als Geschäftsführer am 21. März 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Okt. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||||||
Kapitalaufstellung am 30. Sept. 2015
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2014 bis 30. Sept. 2014 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Paul Francis Cooper als Sekretär am 02. Feb. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Calvin Paul Wesley Goom als Direktor am 02. Feb. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Murray Skakel als Geschäftsführer am 02. Feb. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven Murray Skakel als Sekretär am 02. Feb. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 24. Okt. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed nextiraone services LIMITED\certificate issued on 24/04/14 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Ernennung von Anne Colette Thonon als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Andrew David Coulsen als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Winn als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| COOPER, Paul Francis | Sekretär | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | 194607110001 | |||||||
| COOPER, Paul Francis | Geschäftsführer | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | England | British | 206909290001 | |||||
| COULSEN, Andrew David | Geschäftsführer | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | Switzerland | British | 87390090003 | |||||
| THONON, Anne Colette Jacqueline | Geschäftsführer | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | Luxembourg | Belgian | 146053560002 | |||||
| JUGGINS, John Kenneth | Sekretär | Sherbourne Old Forge Gardens Inn Lane DY11 7TA Hartlebury Worcestershire | British | 29806590001 | ||||||
| PENTER, Nicholas Trevor | Sekretär | 8 Cotsalls Fair Oak SO50 7HP Eastleigh Hampshire | British | 81327550001 | ||||||
| SKAKEL, Steven Murray | Sekretär | 29 Earlswood Road Dorridge B93 8RD Solihull West Midlands | British | 29806610004 | ||||||
| DOWNIE, Ian Michael Stuart | Geschäftsführer | Beech Hill Easton SO21 1ED Winchester Hampshire | United Kingdom | British | 81327720001 | |||||
| DUNACHIE, Robert | Geschäftsführer | 32 Torrance Close Branston DE14 3GX Burton On Trent Staffordshire | British | 55063250001 | ||||||
| FOSTER, David | Geschäftsführer | Hillside Farm Hoggrills End Coleshill B46 2DD Birmingham West Midlands | British | 6796160001 | ||||||
| GIBBS, Simon Spencer | Geschäftsführer | Weedon Lodge Farm House East End HP22 4NJ Weedon Buckinghamshire | England | British | 90259420001 | |||||
| GOOM, Calvin Paul Wesley | Geschäftsführer | Darwin House Lichfield South Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Staffordshire | United Kingdom | British | 194584790001 | |||||
| JUGGINS, John Kenneth | Geschäftsführer | Sherbourne Old Forge Gardens Inn Lane DY11 7TA Hartlebury Worcestershire | United Kingdom | British | 29806590001 | |||||
| LAMB, Stephen Albert | Geschäftsführer | 91a Milby Drive CV11 6GD Nuneaton Warwickshire | England | British | 21645020002 | |||||
| MUFFAT-ES-JACQUES, Philippe | Geschäftsführer | 18 Chemin De La Faucillee 1291 Commueny Switzerland | French | 64733550002 | ||||||
| PARKINSON, Andrew Michael Reay | Geschäftsführer | Tadlow House Tadlow SG8 0EL Royston Hertfordshire | British | 3098750001 | ||||||
| PENTER, Nicholas Trevor | Geschäftsführer | 8 Cotsalls Fair Oak SO50 7HP Eastleigh Hampshire | United Kingdom | British | 81327550001 | |||||
| ROE, Colin | Geschäftsführer | 4 Axminster Close CV11 6YP Nuneaton Warwickshire | British | 55060400001 | ||||||
| SKAKEL, Steven Murray | Geschäftsführer | 29 Earlswood Road Dorridge B93 8RD Solihull West Midlands | England | British | 29806610004 | |||||
| SKAKEL, Steven Murray | Geschäftsführer | 29 Earlswood Road Dorridge B93 8RD Solihull West Midlands | England | British | 29806610004 | |||||
| THOMAS, Aubrey John Christopher | Geschäftsführer | Stirtloe House Stirtloe PE18 9XW Huntingdon Cambridgeshire | British | 3747410001 | ||||||
| TORDJMAN, Jacques | Geschäftsführer | 55 Avenue Simon Bolivar FOREIGN Paris 75019 France | French | 64733720001 | ||||||
| WINN, David Charles | Geschäftsführer | NL1016 Ex Amsterdam Keizersgracht 302 1v Netherlands | The Netherlands | Irish | 150733800001 | |||||
| NEXTIRAONE EUROPE HOLDINGS BV | Geschäftsführer | Laan Van's-Gravenmade 24 2495 Aj's Gravenhage Netherlands | 114409680001 | |||||||
| RKO MANAGEMENT AND INVESTMENT B.V. | Geschäftsführer | Laan Van `S-Gravenmade 24 `S-Gravenhage 2495 Aj Netherlands | 117640790001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Dimension Data Communications Uk Limited | 06. Apr. 2016 | Lichfield South, Birmingham Road WS14 0QP Lichfield Darwin House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat DIMENSION DATA COMMUNICATIONS (SERVICES) UK LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 22. Dez. 2005 Geliefert am 29. Dez. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the security trustee or any of the other secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The real property any goodwill the shares all dividends interest and other monies the proceeds of insurance floating charge the companys undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Security deposit deed | Erstellt am 12. März 2002 Geliefert am 16. März 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The sum of £10,000.00 (including any replacement thereof or accretion thereto). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Dez. 2000 Geliefert am 27. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Mai 1994 Geliefert am 25. Mai 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. März 1994 Geliefert am 17. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 02. März 1992 Geliefert am 06. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. Nov. 1986 Geliefert am 24. Nov. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital. Buildings & fixtues. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 15. Juli 1986 Geliefert am 24. Juli 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of charge | Erstellt am 19. März 1985 Geliefert am 09. Apr. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account of the company with the bank designated client account - teeside automation services limited no. 60354007. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental charge | Erstellt am 08. Sept. 1982 Geliefert am 24. Sept. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the existanc, security docs. Specified in the second schedule to the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge on the book and other debts due and owing to the company both present & future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 18. Jan. 1980 Geliefert am 07. Feb. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge upon the 60 shares of £1 each in the capital of engineering computer services (fe) limited with the bonus shares which may be alloted to the holder thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Jan. 1980 Geliefert am 21. Jan. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts, stock, uncalled capital, work in progress, pre payments investments and cash of the company together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery (please see doc m 23). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0