SWINTON (SOUTH) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SWINTON (SOUTH) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01247540 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SWINTON (SOUTH) LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich SWINTON (SOUTH) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Swinton House 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SWINTON (SOUTH) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ANTHONY GOVER LIMITED | 31. Dez. 1979 | 31. Dez. 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SWINTON (SOUTH) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SWINTON (SOUTH) LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für SWINTON (SOUTH) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Georges Desray als Geschäftsführer am 08. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Christian Charles Plumer als Sekretär am 08. Juli 2014 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Georges Desray als Sekretär am 08. Juli 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Christian Charles Plumer als Direktor am 08. Juli 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Georges Desray am 28. Aug. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Georges Desray als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Sally Hargreaves als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Georges Desray als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
second-filing-of-form-with-form-type | 4 Seiten | RP04 | ||||||||||
| ||||||||||||
second-filing-of-form-with-form-type | 4 Seiten | RP04 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Charles Bellringer als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Charles Albert John Bellringer als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Christophe Marie Fred Bardet als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Halpin als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony Clare als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juni 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SWINTON (SOUTH) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| PLUMER, Christian Charles | Sekretär | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | 189565640001 | |||||||
| BARDET, Christophe Marie Fred | Geschäftsführer | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | French | 165770320001 | |||||
| PLUMER, Christian Charles | Geschäftsführer | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | British | 130813500001 | |||||
| DESRAY, Georges | Sekretär | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | 169861190001 | |||||||
| HARGREAVES, Sally Anne | Sekretär | Swinton House 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester | English | 1778900007 | ||||||
| HARGREAVES, Sally Anne | Sekretär | 27 Broad Lane Hale WA15 0DG Altrincham Cheshire | English | 1778900007 | ||||||
| YOUNG, Bernadette Clare | Sekretär | 21 Kent View Avenue SS9 1HE Leigh On Sea Essex | British | 52675260002 | ||||||
| BELLRINGER, Charles Albert John | Geschäftsführer | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | British | 132720300001 | |||||
| CLARE, Anthony Peter | Geschäftsführer | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | United Kingdom | British | 51441260002 | |||||
| DESRAY, Georges | Geschäftsführer | 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester Swinton House United Kingdom | England | French | 167333040002 | |||||
| HALPIN, Peter Joseph | Geschäftsführer | Swinton House 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester | United Kingdom | British | 38789050002 | |||||
| HARGREAVES, Sally Anne | Geschäftsführer | 27 Broad Lane Hale WA15 0DG Altrincham Cheshire | United Kingdom | English | 1778900007 | |||||
| JONES, Glyn Elfed | Geschäftsführer | 15 Cottage Lawns Hayes Lane SK9 7NF Alderley Edge Cheshire | British | 48028270002 | ||||||
| SCOWCROFT, Brian Kenneth | Geschäftsführer | 155 The Green Worsley M28 2PA Manchester Lancashire | British | 1778920001 | ||||||
| SCOWCROFT, Janet | Geschäftsführer | Ladyhill Old Hall Lane Worsley M28 2FG Manchester | British | 3783100001 | ||||||
| SCOWCROFT, Kenneth, Exors Of | Geschäftsführer | Rosthwaite Farm Storrs Park Ghyll Head, Bowness On Windermere LA23 3LX Windermere Cumbria | England | British | 74407030001 | |||||
| SMITH, Patrick Joseph Edward | Geschäftsführer | Swinton House 6 Great Marlborough Street M1 5SW Manchester | England | British | 157973240001 | |||||
| NON-DESTRUCTIVE TESTERS LIMITED | Geschäftsführer | St Mark's Court Chart Way RH12 1XL Horsham West Sussex | 44011160002 |
Hat SWINTON (SOUTH) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 24. Feb. 1987 Geliefert am 07. März 1987 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 28, northumberland square, north shields. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 17. Sept. 1986 Geliefert am 17. Sept. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over the companys f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof including fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 05. Juli 1985 Geliefert am 11. Juli 1985 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 285,Kilburn high road, brent, london NW6, title no. Mx 267291, and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 02. Jan. 1985 Geliefert am 09. Jan. 1985 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 39 cambridge road hasting sussex. And or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Dez. 1984 Geliefert am 21. Dez. 1984 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 300 cheriton road folkestone kent. Title no. K 335948 and or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 05. Nov. 1984 Geliefert am 15. Nov. 1984 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 196, court road, mottingham eltham. And the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 24. Aug. 1984 Geliefert am 06. Sept. 1984 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 136 london road north end portsmouth hampshire title no hp 124777 and or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 23. März 1984 Geliefert am 05. Apr. 1984 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 35 roundwood road willesdon brent title no mx 24623 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 23. März 1984 Geliefert am 05. Apr. 1984 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 653 high road leyton waltham forest title no ngl 63251 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 13. Juni 1983 Geliefert am 04. Juli 1983 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 196 court road mottingham eltham london SE9 title no sgl 303385 and or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 11. Feb. 1983 Geliefert am 16. Feb. 1983 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 151 milton road, gravesend kent, title no K242109 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 11. Feb. 1983 Geliefert am 16. Feb. 1983 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 29 london road, croydon greater london. Title no. Sgl 349193 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 11. Feb. 1983 Geliefert am 16. Feb. 1983 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 70 high street, chatham kent, title no. K 176798 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 22. März 1982 Geliefert am 22. März 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Montague buildings southchurch road southend on sea essex title no. Ex 175750. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Feb. 1982 Geliefert am 24. Feb. 1982 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 4 duke st chelmsford essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Feb. 1982 Geliefert am 24. Feb. 1982 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 283 london rd westcliff on sea southend on sea essex title no ex 101117. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Feb. 1982 Geliefert am 24. Feb. 1982 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 363 ripple road barking greater london. Title no egl 55449.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Feb. 1982 Geliefert am 24. Feb. 1982 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 665 high rd benfleet essex. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Feb. 1982 Geliefert am 24. Feb. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The old fortune of war, wash road, laindon, basildon, essex title no. EX194892. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Feb. 1982 Geliefert am 24. Feb. 1982 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 199 chingford mount rd chingford waltham forest greater london title no egl 25526.. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Feb. 1982 Geliefert am 24. Feb. 1982 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 35 southend road, grays thurrock, essex title no. EX234683. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Dez. 1981 Geliefert am 07. Dez. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 199 chingford mount road chingford waltham forest road london title no. Egl 25526. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Sept. 1981 Geliefert am 18. Sept. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 363 ripple road barking london title no. Egl 55449. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Sept. 1981 Geliefert am 18. Sept. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 35 southend road grays, essex title no. Ex 234683. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Sept. 1981 Geliefert am 18. Sept. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 4 duke street chelmsford, essex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0