BAXCO1305 LIMITED
Überblick
Unternehmensname | BAXCO1305 LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01249134 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BAXCO1305 LIMITED?
- Herstellung von Maschinen für die Textil-, Bekleidungs- und Lederherstellung (28940) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich BAXCO1305 LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | New Chartford House Centurion Way BD19 3QB Cleckheaton West Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von BAXCO1305 LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
COBBLE BLACKBURN LIMITED | 31. Dez. 1976 | 31. Dez. 1976 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BAXCO1305 LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BAXCO1305 LIMITED?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für BAXCO1305 LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation | 19 Seiten | 4.72 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Nov. 2014 | 13 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 2 Seiten | 2.34B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Nov. 2013 | 28 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger | 1 Seiten | 2.34B | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Anthony Steel als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ergebnis der Gläubigerversammlung | 54 Seiten | 2.23B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 22 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 54 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Gate Street Blackburn Lancashire BB1 3AH England* am 24. Juni 2013 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed cobble blackburn LIMITED\certificate issued on 06/06/13 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 012491340011 | 39 Seiten | MR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Raymond Brown am 26. Feb. 2013 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Jason James Kent am 25. Feb. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Geoffrey Hemingway am 20. Feb. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | MG01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Brent William Knowles als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Laven als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Anthony Deakin als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BAXCO1305 LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN, Raymond | Sekretär | Centurion Way BD19 3QB Cleckheaton New Chartford House West Yorkshire | British | 150352710001 | ||||||
BROWN, Raymond | Geschäftsführer | 4 Church Lane Shepley HD8 8AF Huddersfield West Yorkshire | England | British | Director | 48884640001 | ||||
DEAKIN, Anthony | Geschäftsführer | Centurion Way BD19 3QB Cleckheaton New Chartford House West Yorkshire | United Kingdom | British | Production Director | 167482720001 | ||||
HEMINGWAY, Geoffrey | Geschäftsführer | Centurion Way BD19 3QB Cleckheaton New Chartford House West Yorkshire | England | British | President Spencer Wright Industries Inc. | 25502470001 | ||||
KENT, Jason James | Geschäftsführer | Centurion Way BD19 3QB Cleckheaton New Chartford House West Yorkshire | England | British | Manager | 139919790001 | ||||
KNOWLES, Brent William | Geschäftsführer | Centurion Way BD19 3QB Cleckheaton New Chartford House West Yorkshire | England | English | Sales Director | 174679230001 | ||||
HARDS, David Harry, Mr. | Sekretär | Seler LL16 4LR Llangynhafal Denbighshire | British | Operations Director | 151745090001 | |||||
HOWARTH, George Raymond | Sekretär | Blundells Durton Lane Broughton PR3 5LE Preston Lancashire | British | 14697560001 | ||||||
JONES, Caroline Marie | Sekretär | 60 Lyndon Avenue Great Harwood BB6 7TP Blackburn Lancashire | British | Financial Controller | 33914060001 | |||||
LOCKYER, Michael | Sekretär | 110 Albert Road West Heaton BL1 5EB Bolton Lancashire | British | 102479590001 | ||||||
MARSDEN, David | Sekretär | 23 Hoddlesden Road BB3 3LR Darwen Lancashire | British | Managment Acct | 100357800001 | |||||
ALLEN, Michael Thomas | Geschäftsführer | White Barn Cottage 85a Ribby Road Wrea Green PR4 2PA Preston Lancashire | British | Sales Director | 30218520001 | |||||
BARDSLEY, Harold Brian | Geschäftsführer | 43 Meadowcroft Church Park Euxton PR7 6BU Chorley Lancashire | British | Engineering Director | 30218530001 | |||||
BENNETT, Neale Kenneth | Geschäftsführer | 15 Loxwood Close Walton Park PR5 4NQ Walton Le Dale Lancashire | British | Technical Director | 79988160001 | |||||
BEVERLY, Ian | Geschäftsführer | 3 The Hawthorns BB1 9JW Blackburn | British | Company Director | 53115150001 | |||||
BLOMMAERT, Luc Jean-Pierre Marcel | Geschäftsführer | Charles De Gaullestraat 13 9600 Ronse Belgium | Belgian | Director | 65109710001 | |||||
HARDS, David Harry, Mr. | Geschäftsführer | Seler LL16 4LR Llangynhafal Denbighshire | Wales | British | Operations Director | 151745090001 | ||||
HOSTETTER, Gary Wayne | Geschäftsführer | 334 A Tanager Circle 37412 East Ridge Tennessee Usa | American | Company Director | 30200320002 | |||||
HOWARTH, George Raymond | Geschäftsführer | Blundells Durton Lane Broughton PR3 5LE Preston Lancashire | British | Company Director | 14697560001 | |||||
LAVEN, Ian Paul | Geschäftsführer | Blackburn BB1 3AH Lancashire Gate Street | England | British | None | 132243090001 | ||||
LIVESEY, Geoffrey Ralph | Geschäftsführer | 12 Norford Way Bamford OL11 5QS Rochdale Lancashire | British | Company Director | 30200330001 | |||||
STEEL, Anthony Kenneth | Geschäftsführer | Centurion Way BD19 3QB Cleckheaton New Chartford House West Yorkshire | United Kingdom | British | Director | 90465310001 | ||||
WRIGHT, Spencer Harvey | Geschäftsführer | 32 Oliver Court Signal Mountain Tennessee 37377 United States Usa | American | Company Director | 30200340002 |
Hat BAXCO1305 LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 17. Apr. 2013 Geliefert am 23. Apr. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung All that l/h property kown as 350 melton road leicester t/no LT38630. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security agreement | Erstellt am 24. Dez. 2012 Geliefert am 08. Jan. 2013 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the scheme on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a paradise mills gate street blackburn t/no. Absolute LA863583, land and buildings forming part of albert mill eden street blackburn t/no. Absolute LA698, land on the north side of gate street t/no. Absolute LA604559 and cobble blackburn limited gate street blackburn t/no. Absolute LA863584 all claims of insurance and rental income all buildings fixtures fittings and fixed plant and machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 11. Sept. 2008 Geliefert am 19. Sept. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Seventh supplemental debenture | Erstellt am 05. März 1990 Geliefert am 07. März 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the principal debenture dated 18/1/1977 and supplemental debenture thereto | |
Kurze Angaben F/H unit 3A wentworth industrial park, wentworth way tankersley, barnsley south yorkshire south yorkshire title no syk 611 title no syk 277846. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fifth supplemental mortgage | Erstellt am 05. Sept. 1984 Geliefert am 06. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Paradise mills, gate street, blackburn title no P187882 albert mill, eden street, & paradise mill title no P179122 albert mill, eden street, blackburn title no LA698 north east side of haslingden road, blackburn title no la 397728 west end works, oswaldtwistle, lancashire. See doc M21 for details. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 07. Apr. 1981 Geliefert am 21. Apr. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money which now is or at any time hereafter may be due or owing to the bank for which the company may be or become liable in accordance with the terms of fnb cobble loan agreements, the fnb cobble supplementary loan agreement agreements and the facility agreement. | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital. (See doc M20). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 23. Okt. 1978 Geliefert am 26. Okt. 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies which now are or at any time hereafter may be due or owing to the bank for which the company may be or become liable in accordance with the terms of the fnb cobble loan agreement and the fnb cobble supplemental loan agreements. | |
Kurze Angaben The property charged by a debenture dated 18 jan 1977. and registered on the 18 jan 1977 more particularly described in a debenture dated 20 oct 1978. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 20. Okt. 1978 Geliefert am 26. Okt. 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee secured by a debenture dated 18.1.77. as amended by a supplemental debenture dated 29.9.77. | |
Kurze Angaben All that property charged by the debenture dated 18.1.77 of which particulars were filed on 18.1.77 and in particular but without limitation (for property see doc M18). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental debenture | Erstellt am 29. Sept. 1977 Geliefert am 14. Okt. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dtd 29-9-77 supplemental to a charge dated 18-1-77. | |
Kurze Angaben All that property charged by the debenture dated 18TH january 1977 of which particulars were filed on 18TH january 1977. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 18. Jan. 1977 Geliefert am 07. Feb. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of various agreements all dated 18 jan 1977 as detailed in the charge | |
Kurze Angaben Fixed charge on all book debts currently due to the company in the U.k and all bookdebts which may become due after the date hereof to the company in the U.k in respect of which documents evidencing the same are deposited. Freehold and leasehold property present and future in the U.k with fixed plant machinery and fixtures including trade fixtures present and future. Goodwill present and future. Floating charge on the undertaking and all other property and assets present and future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee | Erstellt am 18. Jan. 1977 Geliefert am 01. Feb. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from spencer wright industries inc. To f n b financial company under the letter of the charge. | |
Kurze Angaben All sums received by the company from spencer wright industries inc by reason of the operation of clause 7 (2) and all debts and liabilities due or owing to the company at the time of a demand by the chargee & the bankruptcy or liquidation of the company by reason of clause 8 of the said guarantee. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat BAXCO1305 LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| In Verwaltung |
| ||||||||||||||||||||||
2 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0