BAXCO1305 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBAXCO1305 LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01249134
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BAXCO1305 LIMITED?

    • Herstellung von Maschinen für die Textil-, Bekleidungs- und Lederherstellung (28940) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich BAXCO1305 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    New Chartford House
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von BAXCO1305 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    COBBLE BLACKBURN LIMITED31. Dez. 197631. Dez. 1976

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BAXCO1305 LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für BAXCO1305 LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für BAXCO1305 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    19 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 07. Nov. 2014

    13 Seiten4.68

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    2 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 08. Nov. 2013

    28 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Beendigung der Bestellung von Anthony Steel als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    54 Seiten2.23B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    22 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    54 Seiten2.17B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Gate Street Blackburn Lancashire BB1 3AH England* am 24. Juni 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed cobble blackburn LIMITED\certificate issued on 06/06/13
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name06. Juni 2013

    Beschluss zur Änderung der Firma am 24. Mai 2013

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Erfüllung der Belastung 10 vollständig

    4 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 012491340011

    39 SeitenMR01

    Änderung der Details des Sekretärs für Raymond Brown am 26. Feb. 2013

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Jason James Kent am 25. Feb. 2013

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Geoffrey Hemingway am 20. Feb. 2013

    2 SeitenCH01

    legacy

    8 SeitenMG01

    Ernennung von Mr Brent William Knowles als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Ian Laven als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Sept. 2012

    Kapitalaufstellung am 12. Sept. 2012

    • Kapital: GBP 150,000
    SH01

    Konzernabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    27 SeitenAA

    Ernennung von Mr Anthony Deakin als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von BAXCO1305 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BROWN, Raymond
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    Sekretär
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    British150352710001
    BROWN, Raymond
    4 Church Lane
    Shepley
    HD8 8AF Huddersfield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    4 Church Lane
    Shepley
    HD8 8AF Huddersfield
    West Yorkshire
    EnglandBritishDirector48884640001
    DEAKIN, Anthony
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    United KingdomBritishProduction Director167482720001
    HEMINGWAY, Geoffrey
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    EnglandBritishPresident Spencer Wright Industries Inc.25502470001
    KENT, Jason James
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    EnglandBritishManager139919790001
    KNOWLES, Brent William
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    EnglandEnglishSales Director174679230001
    HARDS, David Harry, Mr.
    Seler
    LL16 4LR Llangynhafal
    Denbighshire
    Sekretär
    Seler
    LL16 4LR Llangynhafal
    Denbighshire
    BritishOperations Director151745090001
    HOWARTH, George Raymond
    Blundells Durton Lane
    Broughton
    PR3 5LE Preston
    Lancashire
    Sekretär
    Blundells Durton Lane
    Broughton
    PR3 5LE Preston
    Lancashire
    British14697560001
    JONES, Caroline Marie
    60 Lyndon Avenue
    Great Harwood
    BB6 7TP Blackburn
    Lancashire
    Sekretär
    60 Lyndon Avenue
    Great Harwood
    BB6 7TP Blackburn
    Lancashire
    BritishFinancial Controller33914060001
    LOCKYER, Michael
    110 Albert Road West
    Heaton
    BL1 5EB Bolton
    Lancashire
    Sekretär
    110 Albert Road West
    Heaton
    BL1 5EB Bolton
    Lancashire
    British102479590001
    MARSDEN, David
    23 Hoddlesden Road
    BB3 3LR Darwen
    Lancashire
    Sekretär
    23 Hoddlesden Road
    BB3 3LR Darwen
    Lancashire
    BritishManagment Acct100357800001
    ALLEN, Michael Thomas
    White Barn Cottage 85a Ribby Road
    Wrea Green
    PR4 2PA Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    White Barn Cottage 85a Ribby Road
    Wrea Green
    PR4 2PA Preston
    Lancashire
    BritishSales Director30218520001
    BARDSLEY, Harold Brian
    43 Meadowcroft
    Church Park Euxton
    PR7 6BU Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    43 Meadowcroft
    Church Park Euxton
    PR7 6BU Chorley
    Lancashire
    BritishEngineering Director30218530001
    BENNETT, Neale Kenneth
    15 Loxwood Close
    Walton Park
    PR5 4NQ Walton Le Dale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    15 Loxwood Close
    Walton Park
    PR5 4NQ Walton Le Dale
    Lancashire
    BritishTechnical Director79988160001
    BEVERLY, Ian
    3 The Hawthorns
    BB1 9JW Blackburn
    Geschäftsführer
    3 The Hawthorns
    BB1 9JW Blackburn
    BritishCompany Director53115150001
    BLOMMAERT, Luc Jean-Pierre Marcel
    Charles De Gaullestraat 13
    9600 Ronse
    Belgium
    Geschäftsführer
    Charles De Gaullestraat 13
    9600 Ronse
    Belgium
    BelgianDirector65109710001
    HARDS, David Harry, Mr.
    Seler
    LL16 4LR Llangynhafal
    Denbighshire
    Geschäftsführer
    Seler
    LL16 4LR Llangynhafal
    Denbighshire
    WalesBritishOperations Director151745090001
    HOSTETTER, Gary Wayne
    334 A Tanager Circle
    37412 East Ridge
    Tennessee
    Usa
    Geschäftsführer
    334 A Tanager Circle
    37412 East Ridge
    Tennessee
    Usa
    AmericanCompany Director30200320002
    HOWARTH, George Raymond
    Blundells Durton Lane
    Broughton
    PR3 5LE Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Blundells Durton Lane
    Broughton
    PR3 5LE Preston
    Lancashire
    BritishCompany Director14697560001
    LAVEN, Ian Paul
    Blackburn
    BB1 3AH Lancashire
    Gate Street
    Geschäftsführer
    Blackburn
    BB1 3AH Lancashire
    Gate Street
    EnglandBritishNone132243090001
    LIVESEY, Geoffrey Ralph
    12 Norford Way
    Bamford
    OL11 5QS Rochdale
    Lancashire
    Geschäftsführer
    12 Norford Way
    Bamford
    OL11 5QS Rochdale
    Lancashire
    BritishCompany Director30200330001
    STEEL, Anthony Kenneth
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    New Chartford House
    West Yorkshire
    United KingdomBritishDirector90465310001
    WRIGHT, Spencer Harvey
    32 Oliver Court Signal Mountain
    Tennessee 37377
    United States
    Usa
    Geschäftsführer
    32 Oliver Court Signal Mountain
    Tennessee 37377
    United States
    Usa
    AmericanCompany Director30200340002

    Hat BAXCO1305 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 17. Apr. 2013
    Geliefert am 23. Apr. 2013
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    All that l/h property kown as 350 melton road leicester t/no LT38630. Notification of addition to or amendment of charge.
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Steve Southern Trustees Limited as Sole Trustee of the Cobble Group Pension and Life Assurance Scheme
    Transaktionen
    • 23. Apr. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    Security agreement
    Erstellt am 24. Dez. 2012
    Geliefert am 08. Jan. 2013
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the scheme on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a paradise mills gate street blackburn t/no. Absolute LA863583, land and buildings forming part of albert mill eden street blackburn t/no. Absolute LA698, land on the north side of gate street t/no. Absolute LA604559 and cobble blackburn limited gate street blackburn t/no. Absolute LA863584 all claims of insurance and rental income all buildings fixtures fittings and fixed plant and machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Steve Southern Trustees Limited as Sole Trustee of the Cobble Group Pension and Life Assurance Scheme
    Transaktionen
    • 08. Jan. 2013Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 31. Mai 2013Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 11. Sept. 2008
    Geliefert am 19. Sept. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Seventh supplemental debenture
    Erstellt am 05. März 1990
    Geliefert am 07. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to the principal debenture dated 18/1/1977 and supplemental debenture thereto
    Kurze Angaben
    F/H unit 3A wentworth industrial park, wentworth way tankersley, barnsley south yorkshire south yorkshire title no syk 611 title no syk 277846.
    Berechtigte Personen
    • The First National Bank of Boston
    Transaktionen
    • 07. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 17. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fifth supplemental mortgage
    Erstellt am 05. Sept. 1984
    Geliefert am 06. Sept. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Paradise mills, gate street, blackburn title no P187882 albert mill, eden street, & paradise mill title no P179122 albert mill, eden street, blackburn title no LA698 north east side of haslingden road, blackburn title no la 397728 west end works, oswaldtwistle, lancashire. See doc M21 for details. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • The First National Bank of Boston
    Transaktionen
    • 06. Sept. 1984Registrierung einer Belastung
    • 17. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 07. Apr. 1981
    Geliefert am 21. Apr. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All money which now is or at any time hereafter may be due or owing to the bank for which the company may be or become liable in accordance with the terms of fnb cobble loan agreements, the fnb cobble supplementary loan agreement agreements and the facility agreement.
    Kurze Angaben
    Undertaking and all property and assets present and future including goodwill & uncalled capital. (See doc M20).
    Berechtigte Personen
    • The First National Bank of Boston
    Transaktionen
    • 21. Apr. 1981Registrierung einer Belastung
    • 17. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Okt. 1978
    Geliefert am 26. Okt. 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies which now are or at any time hereafter may be due or owing to the bank for which the company may be or become liable in accordance with the terms of the fnb cobble loan agreement and the fnb cobble supplemental loan agreements.
    Kurze Angaben
    The property charged by a debenture dated 18 jan 1977. and registered on the 18 jan 1977 more particularly described in a debenture dated 20 oct 1978.
    Berechtigte Personen
    • The First National Bank of Boston
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1978Registrierung einer Belastung
    • 17. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 20. Okt. 1978
    Geliefert am 26. Okt. 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee secured by a debenture dated 18.1.77. as amended by a supplemental debenture dated 29.9.77.
    Kurze Angaben
    All that property charged by the debenture dated 18.1.77 of which particulars were filed on 18.1.77 and in particular but without limitation (for property see doc M18).
    Berechtigte Personen
    • The First National Bank of Boston
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1978Registrierung einer Belastung
    • 17. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 29. Sept. 1977
    Geliefert am 14. Okt. 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dtd 29-9-77 supplemental to a charge dated 18-1-77.
    Kurze Angaben
    All that property charged by the debenture dated 18TH january 1977 of which particulars were filed on 18TH january 1977.
    Berechtigte Personen
    • First National Bank of Boston
    Transaktionen
    • 14. Okt. 1977Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 18. Jan. 1977
    Geliefert am 07. Feb. 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of various agreements all dated 18 jan 1977 as detailed in the charge
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all book debts currently due to the company in the U.k and all bookdebts which may become due after the date hereof to the company in the U.k in respect of which documents evidencing the same are deposited. Freehold and leasehold property present and future in the U.k with fixed plant machinery and fixtures including trade fixtures present and future. Goodwill present and future. Floating charge on the undertaking and all other property and assets present and future.
    Berechtigte Personen
    • The Singer Company
    • First National Bank of Boston
    • Fnb Financial Company
    • The Singer Company (UK) Limited
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1977Registrierung einer Belastung
    • 17. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee
    Erstellt am 18. Jan. 1977
    Geliefert am 01. Feb. 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from spencer wright industries inc. To f n b financial company under the letter of the charge.
    Kurze Angaben
    All sums received by the company from spencer wright industries inc by reason of the operation of clause 7 (2) and all debts and liabilities due or owing to the company at the time of a demand by the chargee & the bankruptcy or liquidation of the company by reason of clause 8 of the said guarantee.
    Berechtigte Personen
    • F N B Financial Company
    Transaktionen
    • 01. Feb. 1977Registrierung einer Belastung
    • 17. Feb. 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BAXCO1305 LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    24. Mai 2013Beginn der Verwaltung
    08. Nov. 2013Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher Wood
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    Praktiker
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    Fiona Yvonne Rae
    22 Greenwood Street
    WA14 1RZ Altrincham
    Cheshire
    Praktiker
    22 Greenwood Street
    WA14 1RZ Altrincham
    Cheshire
    2
    DatumTyp
    08. Nov. 2013Beginn der Liquidation
    18. Apr. 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Christopher Wood
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire
    Praktiker
    New Chartford House Centurion Way
    BD19 3QB Cleckheaton
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0