CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01256947 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Beendigung der Liquidation | 1 Seiten | L64.07 | ||||||||||
Mitteilung an das Handelsregister über die Ablehnung | 5 Seiten | F10.2 | ||||||||||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 2 Seiten | COCOMP | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 31. März 2013 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Nicholas Molyneux als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Hannan als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Sean Emmett als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mrs Joanna Boydell als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Chris Yates als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. März 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Cashman als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Hannan als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von William Rollason als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr David Cashman als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 22. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Nov. 2009 bis 31. Dez. 2009 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BOYDELL, Joanna | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 164373820001 | |||||
| EMMETT, Sean Robert | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire | United Kingdom | British | 152701300001 | |||||
| YATES, Chris Paul | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire | England | British | 152699330001 | |||||
| CRABTREE, John Nigel | Sekretär | 37 Redlake Drive Pedmore DY9 0RX Stourbridge West Midlands | British | 48224770001 | ||||||
| FISHER, Raymond Keith | Sekretär | 10 Tewkesbury Close Abbey Court CW10 9HT Middlewich Cheshire | British | 42200590001 | ||||||
| HOPE, Malcolm Peter | Sekretär | The Hollies Dodds Green Lane Aston CW5 8DP Nantwich Cheshire | British | 16903560001 | ||||||
| MOLYNEUX, Nicholas John | Sekretär | 168 Kenrick Road Mapperley NG3 6EX Nottingham Nottinghamshire | British | 93529300001 | ||||||
| CASHMAN, David Peter Charles | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire | England | British | 151553190001 | |||||
| CHURCHILL, Roger | Geschäftsführer | 61 Sapcote Road Burbage LE10 2AS Hinckley Leicestershire | British | 48957720002 | ||||||
| CRABTREE, John Nigel | Geschäftsführer | 37 Redlake Drive Pedmore DY9 0RX Stourbridge West Midlands | United Kingdom | British | 48224770001 | |||||
| FISHER, Raymond Keith | Geschäftsführer | 10 Tewkesbury Close Abbey Court CW10 9HT Middlewich Cheshire | United Kingdom | British | 42200590001 | |||||
| GIDDINGS, Michael John | Geschäftsführer | 3 Nailsworth Road Dorridge B93 8NS Solihull West Midlands | British | 105128310002 | ||||||
| HANNAN, Andrew | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester Leicestershire | England | British | 153976980001 | |||||
| HARRIS, Ian Michael Brian | Geschäftsführer | Meadowsteep Berry Lane WD3 5EY Chorleywood Hertfordshire | United Kingdom | British | 116885790001 | |||||
| HOPE, Eleanor Josephine | Geschäftsführer | The Hollies Dodds Green Lane Aston CW5 8DP Nantwich Cheshire | British | 26333700001 | ||||||
| HOPE, Malcolm Peter | Geschäftsführer | The Hollies Dodds Green Lane Aston CW5 8DP Nantwich Cheshire | British | 16903560001 | ||||||
| REDPATH, James | Geschäftsführer | 16 Bosworth Way NG10 1EA Long Eaton Nottinghamshire | England | British | 123915050001 | |||||
| RIORDAN, Peter Joseph | Geschäftsführer | 73 Fairfax Avenue Ewell KT17 2QQ Epsom Surrey | United Kingdom | British | 106574800001 | |||||
| ROLLASON, William Peter | Geschäftsführer | Jessop House 98 Scudamore Road LE3 1TZ Leicester | United Kingdom | British | 67354680003 | |||||
| YATES, Trevor | Geschäftsführer | 11 Abingdon Close Telford Estate SY2 5XF Shrewsbury Shropshire | United Kingdom | British | 25162190001 |
Hat CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Composite debenture | Erstellt am 30. Aug. 2007 Geliefert am 17. Sept. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Land investments equipment book debts credit balanaces intellectual property rights goodwill uncalled capital authorisations in surances and other assets. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A supplemental deed | Erstellt am 07. Juni 2007 Geliefert am 13. Juni 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Apr. 2007 Geliefert am 19. Apr. 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and jessops PLC to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Juli 1998 Geliefert am 28. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. Juli 1998 Geliefert am 28. Juli 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 08. Okt. 1982 Geliefert am 29. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of sale thereof fixed & floating charge on undertaking and all property andassets present and future including goodwill & book debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 13. Juli 1981 Geliefert am 24. Juli 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 265 edleston road, crewe, cheshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 13. Juli 1981 Geliefert am 24. Juli 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 263 edleston road, crewe, cheshire.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 13. Juli 1981 Geliefert am 24. Juli 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 76/78 prince's street stockport, greater manchester title no:- GM39143. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CREWE CAMERA EXCHANGE LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0