LONDON SPECIAL RISKS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | LONDON SPECIAL RISKS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01264149 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LONDON SPECIAL RISKS LIMITED?
- Tätigkeit von Versicherungsvertretern und -maklern (66220) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich LONDON SPECIAL RISKS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Skips Corner Farm Tysea Hill Stapleford Abbotts RM4 1JU Romford England |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LONDON SPECIAL RISKS LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ROBERT BARROW (REINSURANCE BROKERS) LIMITED | 21. Juni 1976 | 21. Juni 1976 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LONDON SPECIAL RISKS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LONDON SPECIAL RISKS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 1 Seiten | DS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard William Brown als Geschäftsführer am 10. Aug. 2023 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Aug. 2023 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Minster House 42 Mincing Lane London EC3A 7AE zum Skips Corner Farm Tysea Hill Stapleford Abbotts Romford RM4 1JU am 02. Aug. 2023 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2022 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Aug. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Aug. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Aug. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Aug. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Aug. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Aug. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 02. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 6 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 19 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 02. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
|
Wer sind die Geschäftsführer von LONDON SPECIAL RISKS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
BROWN, Richard William | Sekretär | Tysea Hill Stapleford Abbotts RM4 1JU Romford Skips Corner Farm England | British | Accountant | 75375570001 | |||||
EDWARDS, David Anthony | Geschäftsführer | Tysea Hill Stapleford Abbotts RM4 1JU Romford Skips Corner Farm England | England | British | Marine Broker | 5272910003 | ||||
NOTTAGE, Brian Ian | Sekretär | Melford Lodge Orchard Avenue CM11 1PH Ramsden Bellhouse Essex | British | Chartered Accountant | 29622370001 | |||||
AQUIL, Balal | Geschäftsführer | SW12 | United Kingdom | British | Solicitor | 91531250001 | ||||
ARDOLINO, Saverio William | Geschäftsführer | Minster House 42 Mincing Lane EC3A 7AE London | England | British | Insurance Broker | 45181770001 | ||||
BROWN, Richard William | Geschäftsführer | Tysea Hill Stapleford Abbotts RM4 1JU Romford Skips Corner Farm England | England | British | Certified Accountant | 75375570001 | ||||
BRYAN, Paul Ronald Peter | Geschäftsführer | West Lodge 185 Colchester Road CO6 3HJ West Bergholt | British | Insurance Broker | 38219850002 | |||||
CHIPCHASE, Stephen Godfrey | Geschäftsführer | 11 Harley Grove Bow E3 2AT London | British | Certified Accountant | 43269970001 | |||||
CRIPPS, Donald Harry Robert | Geschäftsführer | 15 Priests Lane CM15 8BJ Brentwood Essex | British | Lloyds Broker | 44016520001 | |||||
HARCOMBE, Paul David Anthony | Geschäftsführer | 29 Glentrammon Road BR6 6DE Orpington Kent | British | Insurance Brokers | 38220030001 | |||||
HARRISON, Simon Alwyn | Geschäftsführer | Twin Oaks 1c Westbury Road HA6 3DB Northwood Middlesex | British | Claims Director | 21987740001 | |||||
HUGHES, Geoffrey | Geschäftsführer | 24 Lodwick Shoeburyness SS3 9HW Southend On Sea Essex | English | Company Director | 54984040001 | |||||
MISSIMAN, David Charles | Geschäftsführer | 77 Flood Street SW3 5SU London | English | Insurance Broker | 29622400001 | |||||
NOTTAGE, Brian Ian | Geschäftsführer | Melford Lodge Orchard Avenue CM11 1PH Ramsden Bellhouse Essex | England | British | Chartered Acountant | 29622370001 | ||||
ROWLAND, Barry Anthony | Geschäftsführer | 102 New Crane Wharf Wapping High Street E1 9TU London | English | Insurance Broker | 29622380001 | |||||
SHREEVE, Mark William | Geschäftsführer | Long Barn Rectory Road Aldham CO6 3RS Colchester Essex | England | British | Insurance Broker | 29622390003 | ||||
SHREEVE, William John | Geschäftsführer | 301 Portland House Glacis Road FOREIGN Gibraltar | Spain | British | Consultant | 13560570001 | ||||
WATSON, Mark Leigh Stuart | Geschäftsführer | 2 Elton Road SG14 3DW Hertford Hertfordshire | British | Insurance Broker | 83229110001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LONDON SPECIAL RISKS LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
---|---|---|---|
Mr David Anthony Edwards | 06. Apr. 2016 | Tysea Hill Stapleford Abbotts RM4 1JU Romford Skips Corner Farm England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
|
Hat LONDON SPECIAL RISKS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Erstellt am 07. Juni 2010 Geliefert am 18. Juni 2010 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of variation (made in addition to and modifying the security and trust deed dated 29TH december 1989 (the "principal deed") the deeds being made pursuant to the lloyd's brokers byelaw (no. 5 of 1988)(the "byelaw"). (This registration is supplementary to the existing registration of the principal deed) | Erstellt am 08. Okt. 1999 Geliefert am 26. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in respect of insurance transactions and under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to the byelaw or otherwise required to be paid into an insurance broking account of the company and all approved iba assets of the company and all debts and obligations for the time being due owing or incurred to the company in respect of the insurance transactions. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Security & trust deed | Erstellt am 29. Dez. 1989 Geliefert am 09. Jan. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee a statutory corporation as trustee for the creditors for the time being of the company in respect of insurance transactions under the terms of the charge | |
Kurze Angaben All monies (including brokerage) for the time being standing to the credit of or pursuant to lloyd's brokers byelaw (nos of 1988). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0