LLOYDS BANK PENSION TRUST (NO. 2) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LLOYDS BANK PENSION TRUST (NO. 2) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01267231 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LLOYDS BANK PENSION TRUST (NO. 2) LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich LLOYDS BANK PENSION TRUST (NO. 2) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von LLOYDS BANK PENSION TRUST (NO. 2) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LLOYDS TSB GROUP PENSION TRUST (NO.2) LIMITED | 28. Juni 1999 | 28. Juni 1999 |
| TSB GROUP PENSION TRUST LIMITED | 16. Nov. 1982 | 16. Nov. 1982 |
| T.S.B. PENSION TRUST LIMITED | 31. Dez. 1976 | 31. Dez. 1976 |
| DIKAPPA (NUMBER 76) LIMITED | 06. Juli 1976 | 06. Juli 1976 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LLOYDS BANK PENSION TRUST (NO. 2) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2021 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LLOYDS BANK PENSION TRUST (NO. 2) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 10 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf Cawley House Chester Business Park Chester CH4 9FB geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 25 Gresham Street London EC2V 7HN zum 1 More London Place London SE1 2AF am 07. Feb. 2023 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2021 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. März 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. März 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Shirley Hughes als Direktor am 01. Apr. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roger Fawcett Boyes als Geschäftsführer am 31. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. März 2020 mit Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. März 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Harold Francis Baines am 17. Nov. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Peter Anthony Shepherd als Geschäftsführer am 29. Juli 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 22 Seiten | MA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LLOYDS BANK PENSION TRUST (NO. 2) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BAINES, Harold Francis | Geschäftsführer | EH1 1YZ Edinburgh The Mound United Kingdom | United Kingdom | British | 207382860001 | |||||
| HUGHES, Shirley | Geschäftsführer | 25 Gresham Street EC2V 7HN London Group Pensions United Kingdom | United Kingdom | British | 157676650002 | |||||
| CONNOR, Robert Austin | Sekretär | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | British | 36155900001 | ||||||
| GLEIG, Sheila | Sekretär | Craigowan Stortford Road Little Hadham SG11 2DX Ware Hertfordshire | British | 6709360001 | ||||||
| WHITE, Gavin Raymond | Sekretär | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | 167445820001 | |||||||
| ANDERSON, Gordon Alexander | Geschäftsführer | 120 George Street EH2 4TS Edinburgh | British | 329260002 | ||||||
| AYLIFFE, Peter George Edwin | Geschäftsführer | 214 Pacific Wharf 165 Rotherhithe Street SE16 5QF London | United Kingdom | British | 111882140001 | |||||
| BATTY, Alison | Geschäftsführer | Pierhead Street CF10 4PB Cardiff Alexander House United Kingdom | United Kingdom | British | 196923300001 | |||||
| BILLINGS, Stephen Vincent | Geschäftsführer | Elmsgarth 19 High Street Weston Favell NN3 3JS Northampton Northamptonshire | British | 102128300001 | ||||||
| BLACKWELL, Jocelyn Patricia | Geschäftsführer | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 170012470001 | |||||
| BOLTON, Lyndon | Geschäftsführer | Burcott Herrings Lane Burnham Market PE31 8DP Kings Lynn Norfolk | British | 45043300001 | ||||||
| BOYES, Roger Fawcett | Geschäftsführer | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 141063760001 | |||||
| BRIDGELAND, Sally | Geschäftsführer | 14 Frank Dixon Way SE21 7ET London Bridgeland Advisory Limited United Kingdom | England | British | 189493210001 | |||||
| BROWN, Ewan | Geschäftsführer | Queen Street EH2 3NR Edinburgh 48 Midlothian | Scotland | British | 63394750002 | |||||
| BROWN, Ewan | Geschäftsführer | Queen Street EH2 3NR Edinburgh 48 Midlothian | Scotland | British | 63394750002 | |||||
| BROWN, Paul Patrick | Geschäftsführer | Hamilton House 48 Middlefield Lane DY9 0PX Hagley West Midlands | British | 41765480001 | ||||||
| BURNS, John Anthony | Geschäftsführer | 60 Lombard Street EC3V 9DN London | British | 6081060002 | ||||||
| CAREFULL, Robert Charles | Geschäftsführer | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | United Kingdom | British | 1459410001 | |||||
| CLARE, Peter Allen | Geschäftsführer | Hatherley Court Road GL51 3AQ Cheltenham 15 Gloucestershire | British | 131865730001 | ||||||
| FAIREY, Michael Edward | Geschäftsführer | Churchfields House Hitchin Road SG4 8TH Codicote Hertfordshire | United Kingdom | British | 30447060003 | |||||
| FISHER, Colin Michael | Geschäftsführer | Flat 6 18 Wigmore Street W1H 9DE London | British | 66553680001 | ||||||
| FORBES, Sheila Mary | Geschäftsführer | Flat 4 11 Arundel Gardens W11 2LN London | United Kingdom | British | 27382580001 | |||||
| FURNER, William Montague | Geschäftsführer | 4 Donkey Lane Woodchurch Road TN26 2BD Appledore Kent | British | 99203590001 | ||||||
| GARDNER, Rodney Charles Guy | Geschäftsführer | Hartley End House RG27 8HY Hartley Wintney Hampshire | British | 26075110001 | ||||||
| GOZZARD, Adrian Barlow | Geschäftsführer | 1 Frognal Lane NW3 7DY London | British | 6709390001 | ||||||
| JONES, Michael John Probert | Geschäftsführer | School Lane Warmington OX17 1DE Warwickshire Hill Cottage | England | British | 133972790001 | |||||
| JOSEPH, Michael William | Geschäftsführer | The Hermitage St Leonards HP23 6NW Tring Hertfordshire | England | British | 44954410002 | |||||
| KENNEDY, David George | Geschäftsführer | 14 Brookfield Avenue Crosby L23 3DW Liverpool Merseyside | British | 82037690001 | ||||||
| MACPHERSON, John Hannah Forbes | Geschäftsführer | 16 Collylinn Road Bearsden G61 4PN Glasgow | British | 295710001 | ||||||
| MARSDEN, Howard | Geschäftsführer | Heath Lane Croft WA3 7DH Warrington 19 Cheshire | England | British | 131865640002 | |||||
| MCGUIRE, Stephen | Geschäftsführer | Station House, Ground Floor Mercury Court, Tithebarn Street L2 2QP Liverpool Lloyds Tsb Wealth Management England England | United Kingdom | British | 175159730001 | |||||
| MCQUADE, Michael Douglas | Geschäftsführer | 4 Meadow Way LE6 0EY Groby Leicestershire | United Kingdom | British | 172660320001 | |||||
| MITCHINSON, Norman John, Dr | Geschäftsführer | 3 Trin Mills Merchants Landing BS1 4RJ Bristol | England | British | 57813500001 | |||||
| MOORE, Alan Edward | Geschäftsführer | Flat 2, 20 Wigmore Street W1U 2RQ London | British | 71480200001 | ||||||
| MOOTHAM, Dolf Cecil | Geschäftsführer | 26 Lansdowne Road W11 3LL London | British | 61543680001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei LLOYDS BANK PENSION TRUST (NO. 2) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lloyds Bank Plc | 06. Apr. 2016 | Gresham Street EC2V 7HN London 25 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat LLOYDS BANK PENSION TRUST (NO. 2) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A supplemental debenture | Erstellt am 06. Dez. 2002 Geliefert am 13. Dez. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due form the obligors and the nominee to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The freehold land being land adjoining aberafan shopping centre port talbot and being part of title number WA102769 and t/n WA172801. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 16. Okt. 2002 Geliefert am 22. Okt. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the obligors and the nominee to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The benefit of the deed of settlement and the right to recover and receive all compensation which may be payable to it in respect of the deed of settlement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 07. Sept. 2001 Geliefert am 19. Sept. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities whether actual or contingent and whether owned jointly or severally or in any other capacity whatsoever of the obligors and the nominee to each finance party under each finance document. The term "finance document" includes all amendments and supplements (the "secured liabilities") all terms as defined | |
Kurze Angaben All rights of the chargor as general partner of the limited partnership carrying on business under the name of the chjarterhouse shopping centre fund under any hedging arrangement please refer to the form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture between the chargors (as defined) and the agent (as defined) | Erstellt am 11. Juli 2001 Geliefert am 26. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities whatsoever due or to become due from the obligors (as defined) and the nominee (as defined) to each finance party under each finance document (both terms as defined),lloyds tsb group pension trust (no.2) limited as a limited partner in the limited partnership dated 04.11.97,constituting "the charterhouse shopping centre fund" | |
Kurze Angaben All rights under each development document (as defined). See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 17. März 2000 Geliefert am 06. Apr. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from the obligors and/or the nominee to each finance party under each finance document (all defined therein) | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a the aberafan shopping centre port talbot wales t/n WA769757 and l/h land and buildings k/a market hall aberafan shopping centre port talbot wales t/NWA896167 by way of first fixed charge all plant and machinery, all moneys and the debts, all benefits of insurances, licences, its right under any hedging arrangements and any agreement relating to the purchase of the property by the chargors. By way of assignment all rental income, security all the rights under any insurance. By way of floating charge all its assets other than those assets otherwise effectively mortgaged or charged by way of fixed mortgage or charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 16. Aug. 1999 Geliefert am 25. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from the obligors and/or the nominee to each finance party under each finance document (all defined therein) | |
Kurze Angaben F/H land and buildings k/a kingsland shopping centre (previously k/a the former british rail goods yard, dalston and 64 and 66 kingsland high street) t/nos egl 188313 & egl 237456. by way of first fixed charge all plant and machinery, all moneys and the debts, all benefits of insurances, licences, its right under any hedging arrangements and any agreement relating to the purchase of the property by the chargors. By way of assignment all rental income, security all the rights under any insurance. By way of floating charge all its assets other than those assets otherwise effectively mortgaged orcharged by way of fixed mortgage or charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat LLOYDS BANK PENSION TRUST (NO. 2) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0