CITILITES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CITILITES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01272357 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CITILITES LIMITED?
- Herstellung anderer Bekleidungsstücke und Zubehör n.e.c. (14190) / Verarbeitendes Gewerbe
- Einzelhandel mit Bekleidung in spezialisierten Geschäften (47710) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich CITILITES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 79a High Road Willesden NW10 2SU London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CITILITES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Jan. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CITILITES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 01. März 2022 | 13 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 10-12 New College Parade Finchley Road London NW3 5EP zum 79a High Road Willesden London NW10 2SU am 07. Mai 2021 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 01. März 2021 | 12 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2020 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Aston House Cornwall Avenue London N3 1LF zum 10-12 New College Parade Finchley Road London NW3 5EP am 28. Apr. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2019 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Jan. 2019 bis 30. Jan. 2019 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juni 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Jan. 2018 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juni 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Swead als Geschäftsführer am 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Daniel Marc Simons als Geschäftsführer am 31. Dez. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 012723570012, erstellt am 27. Sept. 2017 | 22 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2017 | 33 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 18. Juni 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Notification of Stuart David Swead as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC01 | ||||||||||
Ein Teil des Eigentums oder Unternehmens wurde entlassen und ist nicht mehr Teil der Belastung 6 | 2 Seiten | MR05 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2016 | 33 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 18. Juni 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Jan. 2015 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CITILITES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SWEAD, Stuart David | Sekretär | High Road Willesden NW10 2SU London 79a England | British | 6996700001 | ||||||
| SWEAD, Arlene Melanie | Geschäftsführer | High Road Willesden NW10 2SU London 79a England | United Kingdom | British | 105975720001 | |||||
| SWEAD, Stuart David | Geschäftsführer | High Road Willesden NW10 2SU London 79a England | England | British | 6996700001 | |||||
| KNELL, Peter Frederick John | Geschäftsführer | 9 Grangewood EN6 1SH Potters Bar Hertfordshire | England | British | 108706390001 | |||||
| MONJACK, Ronald | Geschäftsführer | 10 Georgian Close HA7 3QT Stanmore Middlesex | British | 6996720001 | ||||||
| SIMONS, Daniel Marc | Geschäftsführer | Aston House Cornwall Avenue N3 1LF London | Scotland | British | 87628140002 | |||||
| SWEAD, Jonathan | Geschäftsführer | Aston House Cornwall Avenue N3 1LF London | United Kingdom | British | 188884720001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CITILITES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört |
|---|---|---|---|
| Mr Stuart David Swead | 06. Apr. 2016 | High Road Willesden NW10 2SU London 79a England | Nein |
Nationalität: British Staatsangehörigkeit: England | |||
Arten der Kontrolle
| |||
Hat CITILITES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 27. Sept. 2017 Geliefert am 16. Okt. 2017 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung The leasehold premises at unit 1 redburn industrial estate, enfield, middlesex and (by way of a floating charge) all the undertaking and assets of the company. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge over book debts and proceeds | Erstellt am 30. Juli 2002 Geliefert am 31. Juli 2002 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Sept. 2001 Geliefert am 18. Sept. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge over all assets | Erstellt am 13. Juli 2001 Geliefert am 18. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Okt. 2000 Geliefert am 31. Okt. 2000 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as unit 1 redburn industrial estate enfield midd'x; t/no egl 316437. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 20. Okt. 2000 Geliefert am 31. Okt. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold property known as 397/399 hornsey rd,london N.19 4EZ; t/nos LN192991,49469,460435,460375. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 23. Feb. 1995 Geliefert am 24. Feb. 1995 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property at 397/9 hornsey road london & l/h premises at unit 1 redburn industrial estate enfield middx and. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| General letter of pledge and charge | Erstellt am 04. Nov. 1994 Geliefert am 09. Nov. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Such bills of lading and other documents of title goods, all bills of exchange all dock warrants delivery orders warehouse warrents & receipts policies & certificates of insurance. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 22. Nov. 1991 Geliefert am 03. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben See form 395 ref M622C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A general letter of hypothecation and pledge dated 12/7/91 and created by citilites | Erstellt am 12. Juli 1991 Geliefert am 18. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben A pledge upon such bills of lading and other documents of title to goods as are from time to time deposited with the chargee or its agents upon the goods represented thereby and:- all bills of exchange, promissory notes and instruments of any description dock warrants, delivery orders wharehouse warrants and receipts certificates of insurance and other documents and other property which are now or at any time be in the possession with the chargee or its agents see form 395 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Dez. 1987 Geliefert am 17. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Nursery unit 26 woodall road redburn industrial estate enfield l/b of enfield. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Apr. 1983 Geliefert am 21. Apr. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 397/399 hornsey road N19 & 55 bavaria road N19 & land at rear london borough of islington t/n's 460435, 460375 46469, ln 192991. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat CITILITES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0