SESCOMATICS
Überblick
Unternehmensname | SESCOMATICS |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
Unternehmensnummer | 01272630 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SESCOMATICS?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich SESCOMATICS?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SESCOMATICS?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
TOBYSOUND LIMITED | 31. Dez. 1979 | 31. Dez. 1979 |
CAPTIONFINE LIMITED | 11. Aug. 1976 | 11. Aug. 1976 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SESCOMATICS?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SESCOMATICS?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 14 Seiten | AA | ||||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven John Holmes als Geschäftsführer am 22. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Stewart Frank Bradley Baker als Direktor am 21. Sept. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Sept. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 26. Nov. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 26. Sept. 2015 | 5 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 26. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Sept. 2014 | 4 Seiten | AA | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von James William O'halleran als Geschäftsführer am 02. Apr. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mr Steven John Holmes als Direktor am 24. März 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||||||
Ernennung von Mrs Carys Damon als Sekretär am 23. März 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven John Holmes als Sekretär am 23. März 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Sept. 2013 | 1 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
| ||||||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Sept. 2012 | 1 Seiten | AA | ||||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Sept. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SESCOMATICS?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
DAMON, Carys | Sekretär | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | 196178450001 | |||||||
BAKER, Stewart Frank Bradley | Geschäftsführer | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Chief Financial Officer | 230753770001 | ||||
ALBION, Susan | Sekretär | 7 Brownsfield Road WS13 6BT Lichfield Staffordshire | British | Solicitor | 80142740001 | |||||
HOLMES, Steven John | Sekretär | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | British | General Counsel | 80455940002 | |||||
OLDHAM, Annette | Sekretär | Edwards Farm Road Fradley WS13 8NR Lichfield 29 Staffordshire | British | 135120610001 | ||||||
PAGE, David | Sekretär | Rye Croft House 11 Outwoods Lane Anslow DE13 9UB Burton On Trent Staffordshire | British | 31059170002 | ||||||
THOMAS, Paul | Sekretär | 26 Risegate NG12 3JF Cotgrave Nottinghamshire | British | 29218800001 | ||||||
BEER, Brian Leslie | Geschäftsführer | 52 Meadow View Rolleston On Dove DE13 9AN Burton On Trent Staffordshire | British | Company Director | 61154670001 | |||||
BUTLER, Christopher | Geschäftsführer | 1 Richmond Court Repton DE65 6WS Derby Derbyshire | British | Director Of Operations | 64814300001 | |||||
CHILDS, Mervyn Peter | Geschäftsführer | Riverdale Lower High Street DE13 9LU Burton On Trent Staffordshire | British | Company Director | 4619870002 | |||||
CHINN, Neil | Geschäftsführer | 12 Newton Park Newton Solney DE15 0SX Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Company Director | 61154190002 | ||||
CUSKER, David Thomas | Geschäftsführer | Two Loos 5 Paddock Close Copmanthorpe YO2 3RX York North Yorkshire | British | Director Of Operations | 8118380001 | |||||
DARBY, Otto Charles | Geschäftsführer | 103 Harborne Road Edgbaston B15 3HG Birmingham | British | Chairman | 3928470001 | |||||
DAY, John Michael | Geschäftsführer | 27 Newfield Lane S17 3DB Sheffield South Yorkshire | England | British | Finance Director/Company Sec | 69255730001 | ||||
HARRISON, Gerald Edward | Geschäftsführer | 57 Furlong Lane Alrewas DE13 7EE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Director Of Operations | 47602430001 | ||||
HOLMES, Steven John | Geschäftsführer | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | United Kingdom | British | Solicitor | 195545010001 | ||||
HOYLE, Russell Blackburn | Geschäftsführer | 5 Orchard Rise TW10 5BX Richmond Surrey | England | British | Company Director | 52822380002 | ||||
LANGLEY, Paul | Geschäftsführer | 9 Besbury Close Dorridge B93 8NT Solihull | England | British | Sales Director | 99802010001 | ||||
MASSEY, Timothy John | Geschäftsführer | Chestnut Cottage Silver Lane Marchington ST14 8LL Uttoxeter Staffordshire | United Kingdom | British | Free Trade Sales Director | 100259370001 | ||||
NAPIER, Iain John Grant | Geschäftsführer | Loxley 5 Ladywood Road B74 2SN Sutton Coldfield West Midlands | British | Company Chairman | 68802120001 | |||||
O'HALLERAN, James William | Geschäftsführer | 3 The Maltings Wetmore Road DE14 1SE Burton On Trent Staffordshire | England | British | Company Director | 103876820003 | ||||
PAGE, David | Geschäftsführer | Rye Croft House 11 Outwoods Lane Anslow DE13 9UB Burton On Trent Staffordshire | England | British | Chartered Accountant (Acma) | 31059170002 | ||||
PORTNO, Antony David, Dr | Geschäftsführer | 91 Burley Lane Quarndon DE22 5JR Derby | British | Company Director | 58363120001 | |||||
SHERLOCK, Peter Charles | Geschäftsführer | The Grange Somersal Herbert DE6 5PD Ashbourne Derbyshire | British | Company Director | 27922900001 | |||||
SIMON, Christopher Neil | Geschäftsführer | 89 Ella Road West Bridgford NG2 5GZ Nottingham | England | British | Marketing Director | 95528490001 | ||||
SMITH, Keith Ian | Geschäftsführer | Wythtree Manor Park DE13 7JA Kings Bromley Staffordshire | United Kingdom | British | Operations Director | 40284060002 | ||||
THOMAS, Paul | Geschäftsführer | 26 Risegate NG12 3JF Cotgrave Nottinghamshire | British | Company Director | 29218800001 | |||||
THOMPSON, Michael Robert | Geschäftsführer | Park Road Alrewas DE13 7AG Burton On Trent 20 Staffordshire | British | Chartered Accountant | 134817070001 | |||||
WITHERS, Roger Dean | Geschäftsführer | Ivy Cottage The Green Dinton HP17 8UP Aylesbury Buckinghamshire | England | British | Company Director | 29586130001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SESCOMATICS?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Inspired Gaming (Uk) Limited | 06. Apr. 2016 | The Maltings, Wetmore Road DE14 1SE Burton-On-Trent 3 England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat SESCOMATICS Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Deed of amendment and restatement to a composite guarantee and debenture dated 3RD august 1998 (the "deed") | Erstellt am 26. März 1999 Geliefert am 10. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness and liabilities and obligations due owing or incurred pursuant to the revolving credit facility, the mezzanine loan facility and that part of the term loan facility not used to repay indebtedness due under the facilities agreement to the chargee by any group company whether actually or contingently, whether pursuant to the guarantee or otherwise | |
Kurze Angaben L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 (for further details see form 395). fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Composite guarantee and debenture | Erstellt am 03. Aug. 1998 Geliefert am 20. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due pursuant to the revolving credit facility to the security beneficiaries by any group company on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H unit 6B freshfields industrial estate stevenson road kemp town brighton t/n ESX56825 l/h unit 1 spring meadow trading estate lamby way cardiff t/n WA567171 39 woodall road redburn industrial estate enfield t/n NGL500091 for further details of property charged refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0