CROWN DIRECT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameCROWN DIRECT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01273094
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von CROWN DIRECT LIMITED?

    • (7499) /

    Wo befindet sich CROWN DIRECT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Gleadhill House Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Lancashire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von CROWN DIRECT LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CROWN LEISURE LIMITED31. Dez. 197631. Dez. 1976
    PASTAPALM LIMITED13. Aug. 197613. Aug. 1976

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CROWN DIRECT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis27. März 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für CROWN DIRECT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 15. März 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. März 2010

    Kapitalaufstellung am 18. März 2010

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr St John Stott am 18. März 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Dean Leonard Harding am 18. März 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr St John Stott am 18. März 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. März 2009

    8 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten225

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Dez. 2007

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten190

    Jahresabschluss erstellt bis zum 29. Dez. 2006

    8 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    8 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    8 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von CROWN DIRECT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STOTT, St John
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Sekretär
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    BritishAccountant83024660001
    HARDING, Dean Leonard
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector58933060001
    STOTT, St John
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Dawbers Lane
    Euxton
    PR7 6EA Chorley
    Gleadhill House
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector83024660001
    GEMSON, Joan
    Kingsway House 4 Kingsway
    Penwortham
    PR1 0AP Preston
    Lancashire
    Sekretär
    Kingsway House 4 Kingsway
    Penwortham
    PR1 0AP Preston
    Lancashire
    British363330001
    RODEN, Paul Andrew
    Crowshaw House Little Scotland
    Blackrod
    BL6 5JJ Bolton
    Greater Manchester
    Sekretär
    Crowshaw House Little Scotland
    Blackrod
    BL6 5JJ Bolton
    Greater Manchester
    British40949300001
    DIXON, Kenneth Paul
    61 Lowther Crescent
    Leyland
    PR5 3QA Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    61 Lowther Crescent
    Leyland
    PR5 3QA Preston
    Lancashire
    BritishOperations Director8768850001
    FIELDING, Thomas Peter
    Robins Lawn Woodhart Lane
    Eccleston
    PR7 5TB Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Robins Lawn Woodhart Lane
    Eccleston
    PR7 5TB Chorley
    Lancashire
    BritishFinance Director8275430001
    GEMSON, Michael
    Kingsway House 4 Kingsway
    Penwortham
    PR1 0AP Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Kingsway House 4 Kingsway
    Penwortham
    PR1 0AP Preston
    Lancashire
    BritishManaging Director363340001
    MOIR, Neil
    The White House
    Llanfoist
    NP7 9LR Abergavenny
    Monmouthshire
    Geschäftsführer
    The White House
    Llanfoist
    NP7 9LR Abergavenny
    Monmouthshire
    BritishDirector100847010001
    ROBERTS, Dennis George
    Hill Cottage
    Redmain
    CA13 0PZ Cockermouth
    Cumbria
    Geschäftsführer
    Hill Cottage
    Redmain
    CA13 0PZ Cockermouth
    Cumbria
    EnglandEnglishCompany Director363370001
    ROBINSON, Peter Ronald
    20 Shaftesbury Avenue
    New Longton
    PR4 4YA Preston
    Lancashire
    Geschäftsführer
    20 Shaftesbury Avenue
    New Longton
    PR4 4YA Preston
    Lancashire
    EnglandBritishTechnical Director8768870001
    RODEN, John Keith Dennis
    Crowshaws House The Barn
    Little Scotland Blackrod
    BL6 5JJ Bolton
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Crowshaws House The Barn
    Little Scotland Blackrod
    BL6 5JJ Bolton
    Lancashire
    BritishManaging Director1771410001
    RODEN, Paul Andrew
    Crowshaw House Little Scotland
    Blackrod
    BL6 5JJ Bolton
    Greater Manchester
    Geschäftsführer
    Crowshaw House Little Scotland
    Blackrod
    BL6 5JJ Bolton
    Greater Manchester
    EnglandBritishFinance Director40949300001
    TURNER, Kenneth Bryan
    Lynton Longsight Road
    Clayton Le Dale
    BB2 7JA Blackburn
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Lynton Longsight Road
    Clayton Le Dale
    BB2 7JA Blackburn
    Lancashire
    EnglandBritishCompany Director29183950001

    Hat CROWN DIRECT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Supplemental deed, supplemental to a debenture dated 18TH june 1999, issued by the company
    Erstellt am 22. Dez. 1999
    Geliefert am 12. Jan. 2000
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All or any monies and liabilities which will for the time being (and whether on or at any time after demand) be due, owing or incurred in whatsoever manner to the chargee by the company, whether actually or contingently, soley or jointly and whether as principal or surety and whether or not bos shall have been an original party to the relevant transaction, and including interest, discount, commission and other lawful charges or expenses which bos may in the course of its business charge or incur in respect of any of those matters or for keeping the company's account, and so that interest shall be computed and compounded according to the usual bos rates and practice as well after as well as before any demand made or decree obtained under the debenture ("the secured liabilities")
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland ("Bos")
    Transaktionen
    • 12. Jan. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 18. Juni 1999
    Geliefert am 29. Juni 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Juni 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 25. Okt. 1993
    Geliefert am 28. Okt. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Okt. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Prompt credit application
    Erstellt am 20. Juli 1992
    Geliefert am 30. Juli 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £20,358 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Kurze Angaben
    All its right, title and interest in and to all sums payable under the insurance, particulars whereof are set out on the reverse of the form 395.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 30. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Juli 1992
    Geliefert am 29. Juli 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the agreement dated 15 july 1992
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Cotswold Automatics Limited
    Transaktionen
    • 29. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Juli 1992
    Geliefert am 29. Juli 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the agreement dated 15 july 1992
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Rodstock Enterprises Limited
    Transaktionen
    • 29. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. Juli 1992
    Geliefert am 29. Juli 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the agreement dated 15 july 1992
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Rodstock Leisure Limited
    Transaktionen
    • 29. Juli 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 25. März 1992
    Geliefert am 01. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The benefit of all hire contracts including, without limitation, the right to receive the hire debts (for full details see form 395).
    Berechtigte Personen
    • Nmb Lease Limited
    Transaktionen
    • 01. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 18. März 1992
    Geliefert am 19. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's title rights and interest of whatever nature in and to all the hire contracts including, without limitation, the right to receive the hire debts (see form 395 and conts sheets for full details).
    Berechtigte Personen
    • Nmb Lease (U.K.) Limited
    Transaktionen
    • 19. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Aug. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 22. Juli 1981
    Geliefert am 27. Juli 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill book debts uncalled capital. Fixtures fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. Juli 1981Registrierung einer Belastung
    • 27. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 12. Sept. 1980
    Geliefert am 18. Sept. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital. Fixtures fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Sept. 1980Registrierung einer Belastung
    • 27. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0