SUPREME CARE HOMES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SUPREME CARE HOMES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01277340 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SUPREME CARE HOMES LIMITED?
- Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
Wo befindet sich SUPREME CARE HOMES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | c/o R P RENDLE & CO LIMITED 9 Hockley Court Stratford Road Hockley Heath B94 6NW Solihull West Midlands United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SUPREME CARE HOMES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| LARCHFIELD HOUSE NURSING SERVICES LIMITED | 15. Sept. 1976 | 15. Sept. 1976 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUPREME CARE HOMES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SUPREME CARE HOMES LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für SUPREME CARE HOMES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Dez. 2013 | 13 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 14 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Bescheinigung, dass die Gläubiger vollständig bezahlt wurden | 2 Seiten | 4.51 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 3-5 Swallow Place 4Th Floor London W1B 2AF* am 06. Dez. 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Anton David Curtis am 11. Okt. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Anton David Curtis am 11. Okt. 2012 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy Ungelson am 08. Okt. 2012 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * 12-14 St Christophers Place London W1U 1NB* am 05. März 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2009 bis 31. Dez. 2009 | 3 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2008 | 21 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SUPREME CARE HOMES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CURTIS, Anton David | Sekretär | c/o R P Rendle & Co Limited Hockley Court Stratford Road Hockley Heath B94 6NW Solihull 9 West Midlands United Kingdom | British | 115446010001 | ||||||
| CURTIS, Anton David | Geschäftsführer | c/o R P Rendle & Co Limited Hockley Court Stratford Road Hockley Heath B94 6NW Solihull 9 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 151245590002 | |||||
| UNGELSON, Jeremy | Geschäftsführer | c/o R P Rendle & Co Limited Hockley Court Stratford Road Hockley Heath B94 6NW Solihull 9 West Midlands United Kingdom | United Kingdom | British | 125304300002 | |||||
| FRANCIS, Hugh | Sekretär | 40 Topstreet Way AL5 5TT Harpenden | English | 40354440003 | ||||||
| MATTHEWS, Ian | Sekretär | Ffordd Bryngwyn Gwernymynydd CH7 5JW Nr Mold The Croft Flintshire | British | 143242660001 | ||||||
| MCLEISH, William David | Sekretär | 26 Newtyle Road Ralston PA1 3JX Paisley Renfrewshire | British | 168970640001 | ||||||
| MISTRY, Yogeshkumar Kanchanlal | Sekretär | 38 Fairford Avenue LU2 7ER Luton Bedfordshire | British | 73852970001 | ||||||
| PICKERSGILL, Glenn Michael | Sekretär | 187 Coniscliffe Road DL3 8DE Darlington County Durham | British | 112832150003 | ||||||
| FRANCIS, Hugh | Geschäftsführer | 40 Topstreet Way AL5 5TT Harpenden | England | English | 40354440003 | |||||
| MATTHEWS, Ian | Geschäftsführer | Ffordd Bryngwyn Gwernymynydd CH7 5JW Nr Mold The Croft Flintshire | United Kingdom | British | 143242660001 | |||||
| MURPHY, John | Geschäftsführer | 21 Montgreenan View KA13 7NL Kilwinning Ayrshire | British | 26177180002 | ||||||
| PICKERSGILL, Glenn Michael | Geschäftsführer | 187 Coniscliffe Road DL3 8DE Darlington County Durham | England | British | 112832150003 | |||||
| PICKERSGILL, James Lawrence | Geschäftsführer | 14 Farr Holme Blackwell DL3 8QZ Darlington County Durham | England | British | 62920210004 | |||||
| PICKERSGILL, Marion Elizabeth | Geschäftsführer | South View 28 Upsall Drive DL3 8RB Darlington County Durham | British | 75158080002 | ||||||
| SCOTT, Philip Henry | Geschäftsführer | The Old Vicarage Newgate DL12 8NW Barnard Castle County Durham | England | British | 174231320001 | |||||
| SIZER, Graham Kevin | Geschäftsführer | Old Salutation Barn Low Street Little Fencote DL7 9LR Northallerton | England | British | 77274540003 | |||||
| STROWBRIDGE, John Michael Barrie | Geschäftsführer | Keepers Lodge Hollowell Reservoir Hollowell NN6 8RL Northampton Northamptonshire | England | British | 157860840001 |
Hat SUPREME CARE HOMES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Deed of legal charge | Erstellt am 14. Nov. 2007 Geliefert am 23. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from citrus healthcare limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben F/H land k/a ventress hall trinity road darlington t/no DU155767,f/h land k/a stanton hall retirement home trinity road darlington t/no DU97842,f/h land k/a terrace care home maison dieu richmond t/no's NYK219912,NYK121647,MYK204036 and f/h land k/a the kings head hotel and 12 the market place barnards castle t/no DU143039TOGETHER with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 14. Nov. 2007 Geliefert am 23. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to becom due from citrus healthcare limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the leases in respect off/h land k/a ventress hall trinity road darlington t/no DU155767,f/h land k/a stanton hall retirement home trinity road darlington t/no DU97842,fh land k/a terrace care home maison dieu richmond t/no's NYK219912,NYK121647,NYK204036. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An amendment and restatement deed to a debenture dated 10 march 2006 and | Erstellt am 30. Juni 2006 Geliefert am 17. Juli 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture by deed of accession | Erstellt am 05. Apr. 2006 Geliefert am 19. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries or any of them or to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property k/a mill lodge care CENTRE1A moorside place, bradford, west yorkshire f/h t/no WYK677390 and good l/h t/no WYK730706, also the property k/a crabwall hall residential home, parkgate road, mollington, chester t/nos CH246622, CH3. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture by deed of accession | Erstellt am 05. Apr. 2006 Geliefert am 19. Apr. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries or any of them or to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The property k/a mill lodge care CENTRE1A moorside place, bradford, west yorkshire f/h t/no WYK677390 and good l/h t/no WYK730706, also the property k/a crabwall hall residential home, parkgate road, mollington, chester t/nos CH246622, CH3. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Accession deed | Erstellt am 10. März 2006 Geliefert am 24. März 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 12. Juli 2004 Geliefert am 14. Juli 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a ventress hall trinity road darlington. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Nov. 2002 Geliefert am 16. Nov. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a kings court care home barnard castle county durham t/no: DU143039. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Mai 1998 Geliefert am 28. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The land and buildings k/a the terrace care home,richmond,north yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Aug. 1997 Geliefert am 05. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The coach house maison dieu richmond north yorkshire t/n NYK121647. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 12. Dez. 1988 Geliefert am 20. Dez. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Okt. 1982 Geliefert am 02. Nov. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H stanton hall thornville hall, ventress hall darlington, durham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SUPREME CARE HOMES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0