SUPREME CARE HOMES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSUPREME CARE HOMES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01277340
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SUPREME CARE HOMES LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen

    Wo befindet sich SUPREME CARE HOMES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o R P RENDLE & CO LIMITED
    9 Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    West Midlands
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SUPREME CARE HOMES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    LARCHFIELD HOUSE NURSING SERVICES LIMITED15. Sept. 197615. Sept. 1976

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SUPREME CARE HOMES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SUPREME CARE HOMES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für SUPREME CARE HOMES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 11. Dez. 2013

    13 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    14 Seiten4.71

    Bescheinigung, dass die Gläubiger vollständig bezahlt wurden

    2 Seiten4.51

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 3-5 Swallow Place 4Th Floor London W1B 2AF* am 06. Dez. 2012

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Anton David Curtis am 11. Okt. 2012

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Mr Anton David Curtis am 11. Okt. 2012

    1 SeitenCH03

    Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy Ungelson am 08. Okt. 2012

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital20. Jan. 2012

    Kapitalaufstellung am 20. Jan. 2012

    • Kapital: GBP 4,000
    SH01

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    6 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    18 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * 12-14 St Christophers Place London W1U 1NB* am 05. März 2010

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Sept. 2009 bis 31. Dez. 2009

    3 SeitenAA01

    Jahresabschluss für ein mittelständisches Unternehmen erstellt bis zum 30. Sept. 2008

    21 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten363a

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    legacy

    3 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten190

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten287

    Wer sind die Geschäftsführer von SUPREME CARE HOMES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    CURTIS, Anton David
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    Sekretär
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    British115446010001
    CURTIS, Anton David
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish151245590002
    UNGELSON, Jeremy
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    c/o R P Rendle & Co Limited
    Hockley Court
    Stratford Road Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    9
    West Midlands
    United Kingdom
    United KingdomBritish125304300002
    FRANCIS, Hugh
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    Sekretär
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    English40354440003
    MATTHEWS, Ian
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    Sekretär
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    British143242660001
    MCLEISH, William David
    26 Newtyle Road
    Ralston
    PA1 3JX Paisley
    Renfrewshire
    Sekretär
    26 Newtyle Road
    Ralston
    PA1 3JX Paisley
    Renfrewshire
    British168970640001
    MISTRY, Yogeshkumar Kanchanlal
    38 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    Sekretär
    38 Fairford Avenue
    LU2 7ER Luton
    Bedfordshire
    British73852970001
    PICKERSGILL, Glenn Michael
    187 Coniscliffe Road
    DL3 8DE Darlington
    County Durham
    Sekretär
    187 Coniscliffe Road
    DL3 8DE Darlington
    County Durham
    British112832150003
    FRANCIS, Hugh
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    Geschäftsführer
    40 Topstreet Way
    AL5 5TT Harpenden
    EnglandEnglish40354440003
    MATTHEWS, Ian
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    Geschäftsführer
    Ffordd Bryngwyn
    Gwernymynydd
    CH7 5JW Nr Mold
    The Croft
    Flintshire
    United KingdomBritish143242660001
    MURPHY, John
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    Geschäftsführer
    21 Montgreenan View
    KA13 7NL Kilwinning
    Ayrshire
    British26177180002
    PICKERSGILL, Glenn Michael
    187 Coniscliffe Road
    DL3 8DE Darlington
    County Durham
    Geschäftsführer
    187 Coniscliffe Road
    DL3 8DE Darlington
    County Durham
    EnglandBritish112832150003
    PICKERSGILL, James Lawrence
    14 Farr Holme
    Blackwell
    DL3 8QZ Darlington
    County Durham
    Geschäftsführer
    14 Farr Holme
    Blackwell
    DL3 8QZ Darlington
    County Durham
    EnglandBritish62920210004
    PICKERSGILL, Marion Elizabeth
    South View
    28 Upsall Drive
    DL3 8RB Darlington
    County Durham
    Geschäftsführer
    South View
    28 Upsall Drive
    DL3 8RB Darlington
    County Durham
    British75158080002
    SCOTT, Philip Henry
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    Geschäftsführer
    The Old Vicarage
    Newgate
    DL12 8NW Barnard Castle
    County Durham
    EnglandBritish174231320001
    SIZER, Graham Kevin
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    Geschäftsführer
    Old Salutation Barn
    Low Street Little Fencote
    DL7 9LR Northallerton
    EnglandBritish77274540003
    STROWBRIDGE, John Michael Barrie
    Keepers Lodge
    Hollowell Reservoir Hollowell
    NN6 8RL Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Keepers Lodge
    Hollowell Reservoir Hollowell
    NN6 8RL Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish157860840001

    Hat SUPREME CARE HOMES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Deed of legal charge
    Erstellt am 14. Nov. 2007
    Geliefert am 23. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from citrus healthcare limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    F/H land k/a ventress hall trinity road darlington t/no DU155767,f/h land k/a stanton hall retirement home trinity road darlington t/no DU97842,f/h land k/a terrace care home maison dieu richmond t/no's NYK219912,NYK121647,MYK204036 and f/h land k/a the kings head hotel and 12 the market place barnards castle t/no DU143039TOGETHER with all buildings and erections and fixtures (including trade fixtures but excluding tenants fixtures) and fixed plant and machinery thereon, all improvements and additions thereto and all easements rights licences appurtenant thereto, subject to and with the benefit of all existing leases underleases tenancies agreements to lease rights covenants under conditions affecting the same but. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment
    Erstellt am 14. Nov. 2007
    Geliefert am 23. Nov. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to becom due from citrus healthcare limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the rights titles benefits and interests of the company to all monies from time to time due to the company under the leases in respect off/h land k/a ventress hall trinity road darlington t/no DU155767,f/h land k/a stanton hall retirement home trinity road darlington t/no DU97842,fh land k/a terrace care home maison dieu richmond t/no's NYK219912,NYK121647,NYK204036. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Norwich Union Mortgages (General) Limited
    Transaktionen
    • 23. Nov. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    An amendment and restatement deed to a debenture dated 10 march 2006 and
    Erstellt am 30. Juni 2006
    Geliefert am 17. Juli 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC, in Its Capacity as Security Trustee for and on Behalf of Thefinance Parties and Secured Parties (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 17. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture by deed of accession
    Erstellt am 05. Apr. 2006
    Geliefert am 19. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries or any of them or to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property k/a mill lodge care CENTRE1A moorside place, bradford, west yorkshire f/h t/no WYK677390 and good l/h t/no WYK730706, also the property k/a crabwall hall residential home, parkgate road, mollington, chester t/nos CH246622, CH3. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Graphite Capital Management LLP
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture by deed of accession
    Erstellt am 05. Apr. 2006
    Geliefert am 19. Apr. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company to the security beneficiaries or any of them or to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property k/a mill lodge care CENTRE1A moorside place, bradford, west yorkshire f/h t/no WYK677390 and good l/h t/no WYK730706, also the property k/a crabwall hall residential home, parkgate road, mollington, chester t/nos CH246622, CH3. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mr. John Strowbridge as Security Trustee for the Security Beneficiaries (Trustee)
    Transaktionen
    • 19. Apr. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Accession deed
    Erstellt am 10. März 2006
    Geliefert am 24. März 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each charging company to the finance parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 24. März 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Juni 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Juli 2004
    Geliefert am 14. Juli 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a ventress hall trinity road darlington.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Juli 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Nov. 2002
    Geliefert am 16. Nov. 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a kings court care home barnard castle county durham t/no: DU143039.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Nov. 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Mai 1998
    Geliefert am 28. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The land and buildings k/a the terrace care home,richmond,north yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 29. Aug. 1997
    Geliefert am 05. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The coach house maison dieu richmond north yorkshire t/n NYK121647.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1988
    Geliefert am 20. Dez. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Dez. 1988Registrierung einer Belastung
    • 05. Juli 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 24. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Okt. 1982
    Geliefert am 02. Nov. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H stanton hall thornville hall, ventress hall darlington, durham.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 1982Registrierung einer Belastung
    • 24. Mai 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SUPREME CARE HOMES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    14. Mai 2014Aufgelöst am
    12. Dez. 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Paul Rendle
    9 Hockley Court
    Hockley Heath
    B94 6NW Solihull
    Praktiker
    9 Hockley Court
    Hockley Heath
    B94 6NW Solihull

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0