ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01277502 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?
- Finanzleasing (64910) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Canada Square London E14 5HQ |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| FTMF LEASING MARCH (E) LIMITED | 01. Apr. 1997 | 01. Apr. 1997 |
| FORWARD MOTOR FINANCE LIMITED | 01. März 1995 | 01. März 1995 |
| GRIFFIN DISCOUNT LIMITED | 16. Sept. 1976 | 16. Sept. 1976 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Zweite Einreichung für die Ernennung von Crispin Robert John Irvin zum Geschäftsführer | 6 Seiten | RP04AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Richard Kent als Geschäftsführer am 31. Mai 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Rob Irvin als Direktor am 22. März 2017 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael Connelly Anderson als Geschäftsführer am 22. März 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 26 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robin Louis Henning Bencard als Geschäftsführer am 01. Aug. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Simon Einar Long als Direktor am 15. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David John Cavanna als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Connelly Anderson als Direktor am 16. Dez. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Ernennung von Ms Romana Lewis als Sekretär am 12. Juni 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 12. Juni 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tony Bhambhra als Sekretär am 05. Jan. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 05. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Tony Bhambhra als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katherine Dean als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, Romana | Sekretär | Canada Square 14th Floor Canary Wharf E14 5HQ London, Greater London 8 England England | 198529700001 | |||||||
| IRVIN, Crispin Robert John | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 228671160001 | |||||
| LONG, Simon Einar | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 206202590001 | |||||
| OWEN CONWAY, Gareth | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 82999960002 | |||||
| SUBRAMANIYAN, Jaya | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | Malaysian | 136924480002 | |||||
| BAYER, George William | Sekretär | Flat 1 Old Bank House, 110 Bermondsey Street SE1 3TX London | Other | 123920600002 | ||||||
| BHAMBHRA, Tony | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 188917860001 | |||||||
| DEAN, Katherine | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 180092010001 | |||||||
| GOTT, Sarah Caroline | Sekretär | Whitworth Street SE10 9EN London 13 United Kingdom | British | 136485400005 | ||||||
| MCKENZIE, John Hume | Sekretär | 37 Lime Trees Staplehurst TN12 0SS Tonbridge Kent | British | 67406010001 | ||||||
| MCQUILLAN, Pauline Louise | Sekretär | 1 Bolney Court Portsmouth Road KT6 4HX Surbiton Surrey | British | 109247130001 | ||||||
| MUSGROVE, Robert Hugh | Sekretär | 6 Barn Meadow Staplehurst TN12 0SY Tonbridge Kent | Other | 76913670001 | ||||||
| NIVEN, Frances Julie | Sekretär | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | 78670270001 | ||||||
| PEARCE, Mark Vivian | Sekretär | 55 Huntly Road Talbot Woods BH3 7HG Bournemouth Dorset | British | 26776940002 | ||||||
| READ, Alice | Sekretär | 188 Berglen Court 7 Branch Road E14 7JZ London | British | 106168980003 | ||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 194209440001 | |||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 154950760001 | |||||||
| WOOD, Hollie Rheanna | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 166967360001 | |||||||
| ANDERSON, Michael Connelly | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 269666390001 | |||||
| BARKER, Fiona Ann | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 151858510001 | |||||
| BENCARD, Robin Louis Henning | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 46782110002 | |||||
| CAVANNA, David John | Geschäftsführer | 8 Canada Square London E14 5HQ | United Kingdom | British | 180384720001 | |||||
| DEVENISH, William Frederick | Geschäftsführer | 12 Hyde Place OX2 7JB Oxford | British | 52830160002 | ||||||
| EVANS, Geoffrey William | Geschäftsführer | The Trumpet House Kington Lane Claverdon CV35 8PP Warwick | British | 42712190001 | ||||||
| GILMAN, David William | Geschäftsführer | 32 Riverside Drive Selly Oak B29 7ES Birmingham | British | 5681410002 | ||||||
| GILMAN, David William | Geschäftsführer | 32 Riverside Drive Selly Oak B29 7ES Birmingham | British | 5681410002 | ||||||
| HOLMES, Timothy Victor | Geschäftsführer | 18 The Badgers Mearse Lane Barnt Green B45 8QR Birmingham | British | 28497420002 | ||||||
| KELL, Christopher Raymond | Geschäftsführer | 6 Gorse Close WR9 7SG Droitwich Worcestershire | British | 87307470001 | ||||||
| KENNY, Mary Bridget | Geschäftsführer | 178 Empire Square West Long Lane SE1 4NL London | United Kingdom | British | 118995490002 | |||||
| KENT, John Richard | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 174308200001 | |||||
| LANE, Robert David | Geschäftsführer | 42 Bridgnorth Road WV5 0AA Wombourne Staffordshire | England | British | 150099050001 | |||||
| MEAD, David Harry | Geschäftsführer | Willowbank Pirton WR8 9ED Worcester Worcestershire | England | British | 254170760001 | |||||
| PICKEN, Graham Edward | Geschäftsführer | 60 Church Road Aspley Heath Woburn Sands MK17 8TA Milton Keynes | British | 144947830001 | ||||||
| QUINN, Noel Paul | Geschäftsführer | 10 Besford Grove Shirley B90 4YU Solihull West Midlands | British | 72093050001 | ||||||
| SENIOR, Carl Thomas | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 165728830001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Hsbc Asset Finance (Uk) Limited | 26. Okt. 2016 | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Specific legal mortgage (no 10) | Erstellt am 27. Feb. 2004 Geliefert am 11. März 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest in and to the equipment identified by the serial numbers described in or attached to schedule 1 to such first priority mortgage, the benefit of all insurances of the specific equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Specific legal mortgage (no 9) | Erstellt am 28. Nov. 2003 Geliefert am 02. Dez. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The equipment as specifid in first priority mortgage (specific equipment) , all insurances, compensation payable and warranties, contracts or other agreements relating to the specific equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Specific legal mortgage (no 8) | Erstellt am 31. Okt. 2003 Geliefert am 04. Nov. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The equipment identified by the serial numbers described in or attached to schedule 1 to such first priority mortgage; the benefit of all insurances of the specific equipment; any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment; and all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Specific legal mortgage (no 7) | Erstellt am 30. Sept. 2003 Geliefert am 02. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right, title and interest present and future in and to the equipment described in schedule 1 of the first priority mortgage (specific equipment) the benefit of all insurances of the specific equipment, any compensation payable in respect of the compulsory purchase or requisition for title of the specific equipment and all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Specific legal mortgage (no 6) | Erstellt am 29. Aug. 2003 Geliefert am 08. Sept. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right, title and interest present and future in and to the equipment described in schedule 1 of the charge (specific equipment) the benefits of all insurances of the specific equipment any compensation payable in respect of the compulsory acquisition for title of the specific equipment all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First priority mortgage | Erstellt am 31. Juli 2003 Geliefert am 05. Aug. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right title and interest present and future in and to the equipment, the benefit of all insurances of the specific equiptment, any compensation payable, all warranties, contracts or other agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A first priority mortgage | Erstellt am 30. Juni 2003 Geliefert am 01. Juli 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The equipment, the benefit of all insurances of the specific equipment, any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment and all warraties contracts or other agreements. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A first priority mortgage | Erstellt am 30. Mai 2003 Geliefert am 03. Juni 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the equipment (as further defined therein) the benefit of all insurances, any compensation payable and all warranties contracts or other agreements in respect of the said equioment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First priority mortgage | Erstellt am 30. Apr. 2003 Geliefert am 07. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The equipment and the benefit of all insurances of the specific equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A first priority mortgage | Erstellt am 31. März 2003 Geliefert am 04. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right, title and interest present and future in and to: (a) the equipment (b) the benefit of all insurances of the specific equipment (c) any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment, and (d) all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use of repair of the specific equipment or any part thereof. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| An account assignment | Erstellt am 28. März 2003 Geliefert am 04. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The company's right, title and interest present and future in and to: (a) the interest bearing dollar account of the company opened by the company with citibank international PLC designated "p&o re asset finance december (w) limited (lessor proceeds ACCOUNT0" and with account number 0020482508 and with swift address "CITTGB2LELA" (the "account") and any re-designation and sub-accounts of the account (b) the moneys, interest and other amounts from time to time credited to, and for the time being standing to the credit of, the account, and (c) any certificates of deposits, deposit receipt or other instruments or securities relating to the items described above. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A first priority mortgage | Erstellt am 28. März 2003 Geliefert am 04. Apr. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben All the company's right, title, interest and benefit (if any) present and future in and to: (a) the equipment (b) the benefit of all insurances of the equipment, and (c) any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0