ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED

ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01277502
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?

    • Finanzleasing (64910) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen

    Wo befindet sich ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    FTMF LEASING MARCH (E) LIMITED01. Apr. 199701. Apr. 1997
    FORWARD MOTOR FINANCE LIMITED01. März 199501. März 1995
    GRIFFIN DISCOUNT LIMITED16. Sept. 197616. Sept. 1976

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Zweite Einreichung für die Ernennung von Crispin Robert John Irvin zum Geschäftsführer

    6 SeitenRP04AP01

    Beendigung der Bestellung von John Richard Kent als Geschäftsführer am 31. Mai 2017

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 01. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Ernennung von Rob Irvin als Direktor am 22. März 2017

    3 SeitenAP01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    07. Juni 2017Clarification A second filed AP01 was registered on 07/06/2017.

    Beendigung der Bestellung von Michael Connelly Anderson als Geschäftsführer am 22. März 2017

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    26 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Robin Louis Henning Bencard als Geschäftsführer am 01. Aug. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    9 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 05. Mai 2016

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Ernennung von Mr Simon Einar Long als Direktor am 15. März 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von David John Cavanna als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Michael Connelly Anderson als Direktor am 16. Dez. 2015

    2 SeitenAP01

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014

    18 SeitenAA

    Rücktritt des Auditors

    1 SeitenAUD

    Ernennung von Ms Romana Lewis als Sekretär am 12. Juni 2015

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 12. Juni 2015

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    8 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 08. Mai 2015

    • Kapital: GBP 2
    SH01

    Beendigung der Bestellung von Tony Bhambhra als Sekretär am 05. Jan. 2015

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 05. Jan. 2015

    2 SeitenAP03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    18 SeitenAA

    Ernennung von Tony Bhambhra als Sekretär

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Katherine Dean als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Wer sind die Geschäftsführer von ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LEWIS, Romana
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E14 5HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    Sekretär
    Canada Square
    14th Floor Canary Wharf
    E14 5HQ London, Greater London
    8
    England
    England
    198529700001
    IRVIN, Crispin Robert John
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish228671160001
    LONG, Simon Einar
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish206202590001
    OWEN CONWAY, Gareth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish82999960002
    SUBRAMANIYAN, Jaya
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomMalaysian136924480002
    BAYER, George William
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Sekretär
    Flat 1
    Old Bank House, 110 Bermondsey Street
    SE1 3TX London
    Other123920600002
    BHAMBHRA, Tony
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    188917860001
    DEAN, Katherine
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    180092010001
    GOTT, Sarah Caroline
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    Sekretär
    Whitworth Street
    SE10 9EN London
    13
    United Kingdom
    British136485400005
    MCKENZIE, John Hume
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    Sekretär
    37 Lime Trees
    Staplehurst
    TN12 0SS Tonbridge
    Kent
    British67406010001
    MCQUILLAN, Pauline Louise
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    Sekretär
    1 Bolney Court
    Portsmouth Road
    KT6 4HX Surbiton
    Surrey
    British109247130001
    MUSGROVE, Robert Hugh
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Sekretär
    6 Barn Meadow
    Staplehurst
    TN12 0SY Tonbridge
    Kent
    Other76913670001
    NIVEN, Frances Julie
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    Sekretär
    73 Celestial Gardens
    SE13 5RU London
    British78670270001
    PEARCE, Mark Vivian
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    Sekretär
    55 Huntly Road
    Talbot Woods
    BH3 7HG Bournemouth
    Dorset
    British26776940002
    READ, Alice
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    Sekretär
    188 Berglen Court
    7 Branch Road
    E14 7JZ London
    British106168980003
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    194209440001
    SHEPHERD, Hannah Elizabeth
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    154950760001
    WOOD, Hollie Rheanna
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Sekretär
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    166967360001
    ANDERSON, Michael Connelly
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    EnglandBritish269666390001
    BARKER, Fiona Ann
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish151858510001
    BENCARD, Robin Louis Henning
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish46782110002
    CAVANNA, David John
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    Geschäftsführer
    8 Canada Square
    London
    E14 5HQ
    United KingdomBritish180384720001
    DEVENISH, William Frederick
    12 Hyde Place
    OX2 7JB Oxford
    Geschäftsführer
    12 Hyde Place
    OX2 7JB Oxford
    British52830160002
    EVANS, Geoffrey William
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    Geschäftsführer
    The Trumpet House Kington Lane
    Claverdon
    CV35 8PP Warwick
    British42712190001
    GILMAN, David William
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    Geschäftsführer
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    British5681410002
    GILMAN, David William
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    Geschäftsführer
    32 Riverside Drive
    Selly Oak
    B29 7ES Birmingham
    British5681410002
    HOLMES, Timothy Victor
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    Geschäftsführer
    18 The Badgers
    Mearse Lane Barnt Green
    B45 8QR Birmingham
    British28497420002
    KELL, Christopher Raymond
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    6 Gorse Close
    WR9 7SG Droitwich
    Worcestershire
    British87307470001
    KENNY, Mary Bridget
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    Geschäftsführer
    178 Empire Square West
    Long Lane
    SE1 4NL London
    United KingdomBritish118995490002
    KENT, John Richard
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish174308200001
    LANE, Robert David
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    42 Bridgnorth Road
    WV5 0AA Wombourne
    Staffordshire
    EnglandBritish150099050001
    MEAD, David Harry
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Willowbank
    Pirton
    WR8 9ED Worcester
    Worcestershire
    EnglandBritish254170760001
    PICKEN, Graham Edward
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    Geschäftsführer
    60 Church Road
    Aspley Heath Woburn Sands
    MK17 8TA Milton Keynes
    British144947830001
    QUINN, Noel Paul
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    10 Besford Grove
    Shirley
    B90 4YU Solihull
    West Midlands
    British72093050001
    SENIOR, Carl Thomas
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    United KingdomBritish165728830001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    26. Okt. 2016
    Canada Square
    E14 5HQ London
    8
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland And Wales
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England And Wales)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer229341
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat ASSETFINANCE DECEMBER (W) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Specific legal mortgage (no 10)
    Erstellt am 27. Feb. 2004
    Geliefert am 11. März 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest in and to the equipment identified by the serial numbers described in or attached to schedule 1 to such first priority mortgage, the benefit of all insurances of the specific equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 11. März 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Specific legal mortgage (no 9)
    Erstellt am 28. Nov. 2003
    Geliefert am 02. Dez. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The equipment as specifid in first priority mortgage (specific equipment) , all insurances, compensation payable and warranties, contracts or other agreements relating to the specific equipment.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 02. Dez. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Specific legal mortgage (no 8)
    Erstellt am 31. Okt. 2003
    Geliefert am 04. Nov. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The equipment identified by the serial numbers described in or attached to schedule 1 to such first priority mortgage; the benefit of all insurances of the specific equipment; any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment; and all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 04. Nov. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Specific legal mortgage (no 7)
    Erstellt am 30. Sept. 2003
    Geliefert am 02. Okt. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right, title and interest present and future in and to the equipment described in schedule 1 of the first priority mortgage (specific equipment) the benefit of all insurances of the specific equipment, any compensation payable in respect of the compulsory purchase or requisition for title of the specific equipment and all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Specific legal mortgage (no 6)
    Erstellt am 29. Aug. 2003
    Geliefert am 08. Sept. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right, title and interest present and future in and to the equipment described in schedule 1 of the charge (specific equipment) the benefits of all insurances of the specific equipment any compensation payable in respect of the compulsory acquisition for title of the specific equipment all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use or repair of the specific equipment or any part thereof.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 08. Sept. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    First priority mortgage
    Erstellt am 31. Juli 2003
    Geliefert am 05. Aug. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right title and interest present and future in and to the equipment, the benefit of all insurances of the specific equiptment, any compensation payable, all warranties, contracts or other agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 05. Aug. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A first priority mortgage
    Erstellt am 30. Juni 2003
    Geliefert am 01. Juli 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The equipment, the benefit of all insurances of the specific equipment, any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment and all warraties contracts or other agreements. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • P & O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 01. Juli 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A first priority mortgage
    Erstellt am 30. Mai 2003
    Geliefert am 03. Juni 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to the equipment (as further defined therein) the benefit of all insurances, any compensation payable and all warranties contracts or other agreements in respect of the said equioment.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 03. Juni 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    First priority mortgage
    Erstellt am 30. Apr. 2003
    Geliefert am 07. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The equipment and the benefit of all insurances of the specific equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • P & O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 07. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A first priority mortgage
    Erstellt am 31. März 2003
    Geliefert am 04. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right, title and interest present and future in and to: (a) the equipment (b) the benefit of all insurances of the specific equipment (c) any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the specific equipment, and (d) all warranties, contracts or other agreements relating to the condition, operation, use of repair of the specific equipment or any part thereof. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyds Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    An account assignment
    Erstellt am 28. März 2003
    Geliefert am 04. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The company's right, title and interest present and future in and to: (a) the interest bearing dollar account of the company opened by the company with citibank international PLC designated "p&o re asset finance december (w) limited (lessor proceeds ACCOUNT0" and with account number 0020482508 and with swift address "CITTGB2LELA" (the "account") and any re-designation and sub-accounts of the account (b) the moneys, interest and other amounts from time to time credited to, and for the time being standing to the credit of, the account, and (c) any certificates of deposits, deposit receipt or other instruments or securities relating to the items described above. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    A first priority mortgage
    Erstellt am 28. März 2003
    Geliefert am 04. Apr. 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the company's right, title, interest and benefit (if any) present and future in and to: (a) the equipment (b) the benefit of all insurances of the equipment, and (c) any compensation payable in respect of the compulsory acquisition or requisition for title of the equipment. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • P&O Nedlloyd Limited
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juni 2010Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0