TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01279747 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED?
- Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Tony Wilson Place M15 4FN Manchester England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| HURST PUBLISHING LIMITED | 01. Okt. 1976 | 01. Okt. 1976 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. März 2015 |
Welche sind die letzten Einreichungen für TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 29. März 2015 | 12 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joanne Walker als Geschäftsführer am 22. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Joanne Walker am 18. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Ian Somerset am 17. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Sean Robert Glithero am 17. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Auto Trader House Cutbush Park Industrial Estate Danehill Lower Earley Reading Berkshire RG6 4UT zum 1 Tony Wilson Place Manchester England M15 4FN am 23. Dez. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. März 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tara Collet als Geschäftsführer am 03. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ian Somerset als Direktor am 25. Sept. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Joanne Walker als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Zillah Byng-Maddick als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 01. Apr. 2012 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 03. Apr. 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Lane als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Tara Collet als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GLITHERO, Sean | Sekretär | Hyde End Road Spencers Wood RG7 1DL Reading 262 Berkshire United Kingdom | 159905020001 | |||||||
| GLITHERO, Sean Robert | Geschäftsführer | Tony Wilson Place M15 4FN Manchester 1 England England | England | British | 129229070002 | |||||
| SOMERSET, Ian | Geschäftsführer | Tony Wilson Place M15 4FN Manchester 1 England England | England | British | 191225040001 | |||||
| BESWITHERICK, David Peter | Sekretär | 12 Horncastle Close BL8 1XE Bury Lancashire | British | 15959630001 | ||||||
| HODGSON, Simon | Sekretär | 28 Malvern Close Woodley RG5 4HL Reading Berkshire | British | 6848030001 | ||||||
| HOLLAND, Steven John | Sekretär | 10/12 Ramsbottom Road Hawkshaw BL8 4JS Bury Lancashire | British | 72060560001 | ||||||
| HOWARD, Katherine Frances | Sekretär | 25a Gorringe Road SP2 7JA Salisbury Wiltshire | British | 86019470001 | ||||||
| JENKIN, Elizabeth | Sekretär | Sundew Close RG40 5YB Wokingham 7 Berkshire United Kingdom | British | 137518870001 | ||||||
| LACEY, Eugenia | Sekretär | 151 Ash Street GU12 6LJ Ash Surrey | British | 79114130001 | ||||||
| MILLER, Andrew Arthur | Sekretär | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | British | 162220750001 | ||||||
| MILLER, Andrew Arthur | Sekretär | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | British | 162220750001 | ||||||
| PERRISS, Robyn | Sekretär | The Corn Stook Skinners Green, Enborne RG14 6RE Newbury Berkshire | South African | 97879810002 | ||||||
| BYNG-MADDICK, Zillah Ellen | Geschäftsführer | Danehill Lower Earley RG6 4UT Reading Auto Trader House, Cutbush Park Industrial Estate Berkshire United Kingdom | United Kingdom | British | 147214630001 | |||||
| COLLET, Tara | Geschäftsführer | Wing Close SL7 2RA Marlow 2 Bucks United Kingdom | England | British | 160951420001 | |||||
| GIBBONS, Paul | Geschäftsführer | Oakleigh House Bere Court Road RG8 8JU Pangbourne Berkshire | United Kingdom | British | 8699020002 | |||||
| HODGSON, Simon | Geschäftsführer | 28 Malvern Close Woodley RG5 4HL Reading Berkshire | British | 6848030001 | ||||||
| HOWARD, Katherine Frances | Geschäftsführer | 25a Gorringe Road SP2 7JA Salisbury Wiltshire | British | 86019470001 | ||||||
| LANE, Stephen John Roger | Geschäftsführer | 55 Matlock Road Caversham RG4 7BP Reading Berkshire | England | British | 123670600001 | |||||
| LUFF, Graham Ewart | Geschäftsführer | Willows Westbrook Boxford RG20 8DN Newbury Berkshire | British | 46555440002 | ||||||
| MADEJSKI, Robert John, Sir | Geschäftsführer | Northcourt Pangbourne RG8 8PT Reading Berkshire | England | British | 42866240001 | |||||
| MILLER, Andrew Arthur | Geschäftsführer | The Cottage Bucklebury Alley, Cold Ash RG18 9NN Thatcham Berkshire | United Kingdom | British | 162220750001 | |||||
| MUIRHEAD, Brian Geoffrey | Geschäftsführer | Foxley House High Street OX7 5RH Great Rollright Oxfordshire | England | United Kingdom | 155633620001 | |||||
| PALLEY, Simon Dan | Geschäftsführer | 32 Regents Park Road NW1 7TR London | British | 17925410001 | ||||||
| PERRISS, Robyn | Geschäftsführer | The Corn Stook Skinners Green, Enborne RG14 6RE Newbury Berkshire | South African | 97879810002 | ||||||
| RILEY, Ian | Geschäftsführer | Cokes Lane House Cokes Lane HP8 4UD Chalfont St Giles Buckinghamshire | British | 59747560002 | ||||||
| STOREY, Graham Neil | Geschäftsführer | Treetops Garden Close Lane RG14 6PP Newbury Berkshire | United Kingdom | British | 48939070004 | |||||
| WALKER, Joanne | Geschäftsführer | Tony Wilson Place M15 4FN Manchester 1 England England | England | British | 180119580001 |
Hat TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Global accession deed | Erstellt am 03. Okt. 2003 Geliefert am 10. Okt. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to the secured creditors (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture , supplementing and amending a debenture dated 21/07/98 between the company and each of the companies listed therein | Erstellt am 24. Mai 2000 Geliefert am 08. Juni 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present ans future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever ) of each obligor to the lenders (or any of them) under each of the senior finance documents, the senior subordinated facility agreement and the hedging documents | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Juli 1998 Geliefert am 07. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any other companies named therein (each an "obligor") to the chargees under the terms of each or any of the senior finance documents the mezzanine finance documents and the hedging documents (all as defined in the debenture) | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattels mortgage | Erstellt am 17. Nov. 1995 Geliefert am 17. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof being one new kodak photo C.D. imaging workstation serial no:3465132 00755 K374-6055. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Nov. 1995 Geliefert am 15. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (I) f/hold land - 209 king's rd,reading,berkshire; bk 182629 (ii) ...........- 211.............................;bk 169772. together with all buildings/fixtures/fittings,plant and machinery thereon. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Nov. 1995 Geliefert am 15. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold land on west side of first avenue,royal portbury dock,portbury,bristol,BS20 9XP with all buildings/fixtures,plant/machinery thereon; t/no av 177145. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Secured loan note 1992/1994 | Erstellt am 19. Feb. 1992 Geliefert am 09. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £200,000 | |
Kurze Angaben See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Secured loan note 1992/1994 | Erstellt am 19. Feb. 1992 Geliefert am 09. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £200,000 | |
Kurze Angaben See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Apr. 1991 Geliefert am 09. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Premises at philips street bedminster bristol. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Apr. 1991 Geliefert am 03. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 211 kings road reading berkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Apr. 1991 Geliefert am 03. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Auto trader house cutbush lane tower earley reading berkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Apr. 1991 Geliefert am 03. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 209 kings road reading berkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 25. Apr. 1991 Geliefert am 03. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Mai 1981 Geliefert am 02. Juni 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 211 kings road, reading, berks. Bk 169772. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Nov. 1980 Geliefert am 09. Dez. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H lands hereditaments and premises being 209 kings road reading berkshire together with all fixtures whatsoever. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 14. Nov. 1980 Geliefert am 21. Nov. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge on undertaking and all property and and assets present and future including bookdebts uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat TRADER MEDIA HOLDINGS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0