BEEPATH LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BEEPATH LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01283543 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BEEPATH LIMITED?
- Herstellung von anderen Metallwaren (25990) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich BEEPATH LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 3 Fordhouse Road WV10 9DZ Wolverhampton West Midlands England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BEEPATH LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 30. Juli 2015 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Apr. 2016 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juli 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BEEPATH LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Nov. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 409 Harlestone Road Northampton NN5 6PB zum Unit 3 Fordhouse Road Wolverhampton West Midlands WV10 9DZ am 08. Feb. 2016 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juli 2014 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Juli 2014 bis 30. Juli 2014 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Nov. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2013 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Nov. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 4 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Eintragung der Belastung 012835430006 | 38 Seiten | MR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Juli 2012 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Nov. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Smith als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 29. Nov. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Green als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Maurice Smith als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Keith Crouch als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Green als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | MG01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BEEPATH LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SMITH, Andrew John | Geschäftsführer | Fordhouse Road WV10 9DZ Wolverhampton Unit 3 West Midlands England | England | British | 105631310003 | |||||
| GREEN, James Nelson | Sekretär | 153 Park Road TW11 0BS Teddington Middlesex | British | 23591610001 | ||||||
| CROUCH, Keith Juan | Geschäftsführer | Sandhurst Saint Peters Way NN7 4QJ Weedon Northants | England | British | 23591630001 | |||||
| GREEN, Hazel Jill | Geschäftsführer | 153 Park Road TW11 0BS Teddington Middlesex | British | 23591620001 | ||||||
| GREEN, James Nelson | Geschäftsführer | 153 Park Road TW11 0BS Teddington Middlesex | England | British | 23591610001 | |||||
| SMITH, Maurice Charles | Geschäftsführer | 6 Ingleborough Way NN5 6DY Duston Northampton | England | British | 33278180001 |
Hat BEEPATH LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 28. Juni 2013 Geliefert am 04. Juli 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung 1. by way of legal mortgage:. 1.1 on the properties (if any) specified in schedule 2 to the debenture;. 1.2 on all properties (other than any properties specified in schedule 2 to the debenture) now owned by the company or in which the company has an interest;. 2. by way of fixed charge on all of the following assets, whether now or in future belonging to the company:. 2.1 the freehold and leasehold properties of the company not effectively mortgaged under paragraphs 1.1 and 1.2 including such as may thereafter be acquired;. 2.2 all fixtures in, on or attached to the property subject to the legal mortgages under paragraphs 1.1 and 1.2 and all spare parts, replacements, modifications and additions for or to the same;. 2.3 any other freehold and leasehold property which the company shall own together with all fixtures and fittings (including trade fixtures and fittings) and fixed plant and machinery in, on or attached to such property and all spare parts, replacements, modifications and additions for or to the same;. 2.4 all the company’s intellectual property - all patents (including applications, improvements, prolongations, extensions and right to apply therefor) designs (whether registered or unregistered) copyrights, design rights, trade marks and service marks (whether registered or unregistered) utility models, trade and business names, know-how, formulae, inventions, confidential information, trade secrets and computer software programs and systems (including the benefit of any licences or consents relating to any of the above) and all fees, royalties or other rights derived therefrom or incidental thereto in any part of the world.. Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 23. Nov. 2011 Geliefert am 14. Dez. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| All assets debenture | Erstellt am 23. Nov. 2011 Geliefert am 07. Dez. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Nov. 2011 Geliefert am 26. Nov. 2011 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the sellers on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 21. Apr. 1987 Geliefert am 29. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Single debenture | Erstellt am 30. Okt. 1980 Geliefert am 05. Nov. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts & uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0