01285055 LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Bestätigungsbescheinigung
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    Unternehmensname01285055 LIMITED
    UnternehmensstatusAktiv
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01285055
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von 01285055 LIMITED?

    • (2612) /

    Wo befindet sich 01285055 LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Ground Floor Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von 01285055 LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    DARBY GROUP PLC08. Sept. 198808. Sept. 1988
    MICHAEL J. DARBY (HOLDINGS) LIMITED04. Nov. 197604. Nov. 1976

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 01285055 LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Nächster Jahresabschluss
    Ende des nächsten Geschäftsjahres am28. Feb. 2010
    Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am30. Nov. 2010
    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis28. Feb. 2009

    Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für 01285055 LIMITED?

    ÜberfälligJa
    Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis26. Juli 2016
    Fälligkeit der nächsten Bescheinigung09. Aug. 2016
    ÜberfälligJa

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für 01285055 LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss
    ÜberfälligJa

    Welche sind die letzten Einreichungen für 01285055 LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    4 SeitenAC92

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed darby group\certificate issued on 25/10/17
    SeitenCERTNM

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresrückblick erstellt bis 23. Aug. 2010

    14 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital04. Feb. 2011

    Kapitalaufstellung am 04. Feb. 2011

    • Kapital: GBP 1,381,729.7
    SH01

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt

    1 SeitenDISS40

    Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2009

    15 SeitenAA

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    5 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    2 Seiten288a

    Wer sind die Geschäftsführer von 01285055 LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED
    Ground Floor Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    Sekretär
    Ground Floor Ryder Court
    14 Ryder Street
    SW1Y 6QB London
    36581310005
    MILLS, Christopher Harwood Bernard
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    Geschäftsführer
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    United KingdomBritish35557050001
    BANNISTER, Stephen John
    5 West Drive St Edwards Park
    Cheddleton
    ST13 7DW Leek
    Staffordshire
    Sekretär
    5 West Drive St Edwards Park
    Cheddleton
    ST13 7DW Leek
    Staffordshire
    British115415890001
    BODDY, David Eric
    44 Horkstow Road
    DN18 5DZ Barton On Humber
    Humberside
    Sekretär
    44 Horkstow Road
    DN18 5DZ Barton On Humber
    Humberside
    British34527260001
    COOPER, Robin Timothy
    6 Mayflower Court
    Austerfield
    DN10 6RZ Doncaster
    South Yorkshire
    Sekretär
    6 Mayflower Court
    Austerfield
    DN10 6RZ Doncaster
    South Yorkshire
    British108328050001
    DOVEY, Barry
    3 Woodhill Avenue
    Woodland View
    DN21 1FB Gainsborough
    Lincolnshire
    Sekretär
    3 Woodhill Avenue
    Woodland View
    DN21 1FB Gainsborough
    Lincolnshire
    British34998480001
    HASWELL, Steven Hedley
    Greystones
    Brackenwell Lane North Rigton
    LS17 0DG Leeds
    North Yorkshire
    Sekretär
    Greystones
    Brackenwell Lane North Rigton
    LS17 0DG Leeds
    North Yorkshire
    British16991280001
    HOPCROFT, Martin Peter
    1 The Pastures
    Edlesborough
    LU6 2HL Dunstable
    Bedfordshire
    Sekretär
    1 The Pastures
    Edlesborough
    LU6 2HL Dunstable
    Bedfordshire
    British40168200002
    QUEEN, Roger Charles
    The Old Rectory
    Dishforth
    YO7 3LP Thirsk
    North Yorkshire
    Sekretär
    The Old Rectory
    Dishforth
    YO7 3LP Thirsk
    North Yorkshire
    British78822570002
    ABRAHAMS, Mark Simon
    140 Clifton
    YO30 6BH York
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    140 Clifton
    YO30 6BH York
    North Yorkshire
    EnglandBritish4381310001
    BABER, Ralph Peter
    Oaklands 5 Queenborough Gardens
    BR7 6NP Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    Oaklands 5 Queenborough Gardens
    BR7 6NP Chislehurst
    Kent
    EnglandBritish150093220001
    BANNISTER, Stephen John
    5 West Drive St Edwards Park
    Cheddleton
    ST13 7DW Leek
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    5 West Drive St Edwards Park
    Cheddleton
    ST13 7DW Leek
    Staffordshire
    EnglandBritish115415890001
    BODDY, David Eric
    44 Horkstow Road
    DN18 5DZ Barton On Humber
    Humberside
    Geschäftsführer
    44 Horkstow Road
    DN18 5DZ Barton On Humber
    Humberside
    British34527260001
    COOPER, Brian
    Dew Lawn
    YO5 9QY Marton-Cum-Grafton
    York
    Geschäftsführer
    Dew Lawn
    YO5 9QY Marton-Cum-Grafton
    York
    United KingdomBritish15446400002
    CORKE, Philip
    The Manor House
    1 Bedford Road
    MK44 3RG Moggerhanger
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    The Manor House
    1 Bedford Road
    MK44 3RG Moggerhanger
    Bedfordshire
    EnglandBritish85311430001
    DARBY, Barbara Joan
    Emmerson House School Lane
    Redbourne
    DN21 4QN Gainsborough
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    Emmerson House School Lane
    Redbourne
    DN21 4QN Gainsborough
    Lincolnshire
    British52184420001
    DARBY, Michael John
    New House
    School Lane
    DN21 4QN Redbourne
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    New House
    School Lane
    DN21 4QN Redbourne
    Lincolnshire
    British18981290001
    DAVENPORT, Kathryn Anne
    Stoneleigh
    2 Moorfield Way
    LS29 8BX Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Stoneleigh
    2 Moorfield Way
    LS29 8BX Ilkley
    West Yorkshire
    British104948570001
    EDWARDS, Adrian Stewart
    Church Path
    CB10 1JP Saffron Walden
    2
    Essex
    Geschäftsführer
    Church Path
    CB10 1JP Saffron Walden
    2
    Essex
    EnglandBritish101404540002
    GYLLENHAMMAR, Peter Jan Patrik Valentin
    Banergatan 3
    FOREIGN Stockholm
    Sweden
    Geschäftsführer
    Banergatan 3
    FOREIGN Stockholm
    Sweden
    SwedenSwedish76805000001
    GYLLENHAMMER, Peter Jan Patrik Valentin
    Banergatan 3 3tr
    Stockholm
    Se-114 56
    Sweden
    Geschäftsführer
    Banergatan 3 3tr
    Stockholm
    Se-114 56
    Sweden
    Swedish85781920001
    HARDY, Howard
    13 North Street
    DN21 2HP Gainsborough
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    13 North Street
    DN21 2HP Gainsborough
    Lincolnshire
    British69084070002
    HART, Frederick Harry
    33 Foxhill
    LE15 7HB Whissendine
    Rutland
    Geschäftsführer
    33 Foxhill
    LE15 7HB Whissendine
    Rutland
    British45291310001
    HASWELL, Steven Hedley
    Greystones
    Brackenwell Lane North Rigton
    LS17 0DG Leeds
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    Greystones
    Brackenwell Lane North Rigton
    LS17 0DG Leeds
    North Yorkshire
    British16991280001
    HAYES, Michael Hugh
    Wenlock Mounthooly
    TD8 6TJ Jedburgh
    Roxburghshire
    Geschäftsführer
    Wenlock Mounthooly
    TD8 6TJ Jedburgh
    Roxburghshire
    ScotlandBritish50729030001
    HOLMSTROM, Jan Gustaf Lennart
    Strandstigen 3 Strandstigen 3
    SE18134 Se-18134 Lidingo
    Sweden
    Geschäftsführer
    Strandstigen 3 Strandstigen 3
    SE18134 Se-18134 Lidingo
    Sweden
    SwedenSwedish152201540001
    HOPCROFT, Martin Peter
    1 The Pastures
    Edlesborough
    LU6 2HL Dunstable
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    1 The Pastures
    Edlesborough
    LU6 2HL Dunstable
    Bedfordshire
    British40168200002
    KNIGHT, Patrick Stephen Provis
    Hafod Wen
    LL65 2NJ Rhoscolyn
    Anglesey Gwynedd
    Geschäftsführer
    Hafod Wen
    LL65 2NJ Rhoscolyn
    Anglesey Gwynedd
    WalesBritish97288820001
    LANGTON, Paul
    Fieldside Lodge
    Waterside Winteringham
    DN17 9PG Scunthorpe
    S Humberside
    Geschäftsführer
    Fieldside Lodge
    Waterside Winteringham
    DN17 9PG Scunthorpe
    S Humberside
    British19038720001
    MAHER, Michael
    Norwood
    Shortheath Road
    GU9 8SL Farnham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Norwood
    Shortheath Road
    GU9 8SL Farnham
    Surrey
    EnglandBritish64239090001
    MILLS, Christopher Harwood Bernard
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    Geschäftsführer
    Cliveden Place
    SW1W 8LA London
    10
    United KingdomBritish35557050001
    PAPADOPOULOS, James
    Westhurst Drive
    BR7 6HS Chislehurst
    87
    Kent
    Geschäftsführer
    Westhurst Drive
    BR7 6HS Chislehurst
    87
    Kent
    British139470540001
    QUEEN, Roger Charles
    The Old Rectory
    Dishforth
    YO7 3LP Thirsk
    North Yorkshire
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Dishforth
    YO7 3LP Thirsk
    North Yorkshire
    United KingdomBritish78822570002
    SHORT, Philip Christopher
    Waterside Outgate
    Ealand
    DN17 4JE Scunthorpe
    Humberside
    Geschäftsführer
    Waterside Outgate
    Ealand
    DN17 4JE Scunthorpe
    Humberside
    British19038710001
    SIMPSON, Christopher Michael
    4 Bellbutts View
    Scotter
    DN21 3UX Gainsborough
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    4 Bellbutts View
    Scotter
    DN21 3UX Gainsborough
    Lincolnshire
    EnglandBritish52678440001

    Hat 01285055 LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. März 2007
    Geliefert am 27. März 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H 32-35 hoylake road bottesford t/no HS175599 the rental sums the goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Venture Finance PLC
    Transaktionen
    • 27. März 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Dez. 2006
    Geliefert am 16. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plots 32-35 hoylake road, bottesford, scunthorpe, north lincolnshire t/no. HS175599.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 29. Juli 1991
    Geliefert am 01. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Part plot 5 sunningdale rd. Scunthorpe t/n-160513 & plots 5A-9A sunningdale road scunthorpe t/n-161066 & plots 32-35 hoylake rd scunthorpe t/n-HS175599. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Aug. 1991Registrierung einer Belastung
    • 22. Jan. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Aug. 1989
    Geliefert am 25. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Plots 32-35 hoylake road, bottesford, humberside.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 22. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Okt. 1988
    Geliefert am 05. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H part plot 5, sunningdale road, scunthorpe, south humberside.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 22. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Okt. 1988
    Geliefert am 05. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H plots 5A, 6, 7, 8, 9 and 9A sunningdale road, scunthorpe, south humberside.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 22. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Dez. 1987
    Geliefert am 30. Dez. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Horizontal glass toughening plant including heating chamber, batch system and fully automatic conveyor on rollers type t-p-r-13 x 440V-50 hertz 2000 x 3600 (see 395 for full details relevant to this charge).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Dez. 1987Registrierung einer Belastung
    • 22. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. März 1987
    Geliefert am 10. März 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold-plot 5A sunningdale road, scunthorpe, south humberside.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. März 1987Registrierung einer Belastung
    Supplemental charge
    Erstellt am 27. Feb. 1987
    Geliefert am 12. März 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land situate on the north side of sunningdale road, scunthorpe humberside. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures and fixed plant and machinery from time to time thereon and therein.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 12. März 1987Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 09. Okt. 1985
    Geliefert am 15. Okt. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold 6, 8A, 9 and 9A sunningdale road, scunthorpe, south humberside.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Okt. 1985Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 19. Juni 1985
    Geliefert am 21. Juni 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Legal mortgage over l/hold plot of land at sunningdale road scunthorpe south humberside known as plot 9A sunningdale road. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC.
    Transaktionen
    • 21. Juni 1985Registrierung einer Belastung
    Chattel mortgage
    Erstellt am 19. Juni 1985
    Geliefert am 21. Juni 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of assignment the following plant machinery chattels or other equipment of the company. Stillage storage and rackery equipment internal over head crane serial number dmh 4318. see document M24 for full details.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 21. Juni 1985Registrierung einer Belastung
    Collateral debenture
    Erstellt am 25. Sept. 1984
    Geliefert am 28. Sept. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the teakglade limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Together with stock-in trade work in progress, pre payments stocks exchange investments & cash.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC.
    Transaktionen
    • 28. Sept. 1984Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 02. Aug. 1984
    Geliefert am 08. Aug. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge by way of legal mortgage over:- plot of land at sunningdale road south park industrial estate scunthorpe, south humberside known as plot 9 together with all buildings fixed plant machinery fixtures.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1984Registrierung einer Belastung
    Chattel mortgage
    Erstellt am 02. Aug. 1984
    Geliefert am 08. Aug. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge by way of assignment over:- pannkoke single head cutting fine (see doc M21 for details).
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1984Registrierung einer Belastung
    Supplemental legal charge
    Erstellt am 25. Okt. 1983
    Geliefert am 27. Okt. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All book debts and other debts present & future.
    Berechtigte Personen
    • Investors in Industry PLC
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1983Registrierung einer Belastung
    Chattel mortgage
    Erstellt am 28. Jan. 1983
    Geliefert am 02. Feb. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 horizontal glass toughenine plant including heating chamber batch system and fully automatic conveyor on rollers type t-p-r-13X440V-sohz-2000X3600 so catedat sunningdale road, scunthorpe, south humberside.
    Berechtigte Personen
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 02. Feb. 1983Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 28. Jan. 1983
    Geliefert am 02. Feb. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital, stock-in-trade, work-in-progress, pre-payments, stock exchange investments a cash will all buildings, trade & other fixtures, fixed pland & machinery. L/hold 6-8 sunningdale road & 31-32 northampton road, scunthorpe, south humberside.
    Berechtigte Personen
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 02. Feb. 1983Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 30. Juli 1981
    Geliefert am 06. Aug. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all book debts and other debts of the company.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Aug. 1981Registrierung einer Belastung
    • 22. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juli 1981
    Geliefert am 04. Aug. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold lands hereditaments & premises being:- 6, 7, & 8 sunningdale road, scunthorpe south humberside.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Aug. 1981Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 22. Mai 1981
    Geliefert am 29. Mai 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold, 7 and 8 sunningdale road, scunthorpe.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Mai 1981Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 13. Mai 1981
    Geliefert am 20. Mai 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge on leashold land and buildings at sunningdale road scunthorpe. And all buildings, fixtures (inc. Tradefixtures) fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Industrial and Commercial Finance Corporation Limited
    Transaktionen
    • 20. Mai 1981Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 04. Sept. 1980
    Geliefert am 10. Sept. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H 6, 7 & 8 sunningdale road, moorawell road industrial estate boltesford scunthorpe all fixtures present & future.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Sept. 1980Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 12. Mai 1980
    Geliefert am 16. Mai 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/Hold, factory premises situate in northampton road, known as 31 & 32, scunthorpe together with all fixtures present and fixture. Title no. Hs 39163.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Mai 1980Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 26. Sept. 1977
    Geliefert am 03. Okt. 1977
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Okt. 1977Registrierung einer Belastung
    • 22. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0