01285055 LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | 01285055 LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aktiv |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01285055 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von 01285055 LIMITED?
- (2612) /
Wo befindet sich 01285055 LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Ground Floor Ryder Court 14 Ryder Street SW1Y 6QB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von 01285055 LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DARBY GROUP PLC | 08. Sept. 1988 | 08. Sept. 1988 |
| MICHAEL J. DARBY (HOLDINGS) LIMITED | 04. Nov. 1976 | 04. Nov. 1976 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von 01285055 LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Nächster Jahresabschluss | |
| Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 28. Feb. 2010 |
| Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 30. Nov. 2010 |
| Letzter Jahresabschluss | |
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Feb. 2009 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für 01285055 LIMITED?
| Überfällig | Ja |
|---|---|
| Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 26. Juli 2016 |
| Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 09. Aug. 2016 |
| Überfällig | Ja |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für 01285055 LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für 01285055 LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss | 4 Seiten | AC92 | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed darby group\certificate issued on 25/10/17 | Seiten | CERTNM | ||||||||||
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt | 1 Seiten | DISS16(SOAS) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 23. Aug. 2010 | 14 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde eingestellt | 1 Seiten | DISS40 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 28. Feb. 2009 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 5 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von 01285055 LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| J O HAMBRO CAPITAL MANAGEMENT LIMITED | Sekretär | Ground Floor Ryder Court 14 Ryder Street SW1Y 6QB London | 36581310005 | |||||||
| MILLS, Christopher Harwood Bernard | Geschäftsführer | Cliveden Place SW1W 8LA London 10 | United Kingdom | British | 35557050001 | |||||
| BANNISTER, Stephen John | Sekretär | 5 West Drive St Edwards Park Cheddleton ST13 7DW Leek Staffordshire | British | 115415890001 | ||||||
| BODDY, David Eric | Sekretär | 44 Horkstow Road DN18 5DZ Barton On Humber Humberside | British | 34527260001 | ||||||
| COOPER, Robin Timothy | Sekretär | 6 Mayflower Court Austerfield DN10 6RZ Doncaster South Yorkshire | British | 108328050001 | ||||||
| DOVEY, Barry | Sekretär | 3 Woodhill Avenue Woodland View DN21 1FB Gainsborough Lincolnshire | British | 34998480001 | ||||||
| HASWELL, Steven Hedley | Sekretär | Greystones Brackenwell Lane North Rigton LS17 0DG Leeds North Yorkshire | British | 16991280001 | ||||||
| HOPCROFT, Martin Peter | Sekretär | 1 The Pastures Edlesborough LU6 2HL Dunstable Bedfordshire | British | 40168200002 | ||||||
| QUEEN, Roger Charles | Sekretär | The Old Rectory Dishforth YO7 3LP Thirsk North Yorkshire | British | 78822570002 | ||||||
| ABRAHAMS, Mark Simon | Geschäftsführer | 140 Clifton YO30 6BH York North Yorkshire | England | British | 4381310001 | |||||
| BABER, Ralph Peter | Geschäftsführer | Oaklands 5 Queenborough Gardens BR7 6NP Chislehurst Kent | England | British | 150093220001 | |||||
| BANNISTER, Stephen John | Geschäftsführer | 5 West Drive St Edwards Park Cheddleton ST13 7DW Leek Staffordshire | England | British | 115415890001 | |||||
| BODDY, David Eric | Geschäftsführer | 44 Horkstow Road DN18 5DZ Barton On Humber Humberside | British | 34527260001 | ||||||
| COOPER, Brian | Geschäftsführer | Dew Lawn YO5 9QY Marton-Cum-Grafton York | United Kingdom | British | 15446400002 | |||||
| CORKE, Philip | Geschäftsführer | The Manor House 1 Bedford Road MK44 3RG Moggerhanger Bedfordshire | England | British | 85311430001 | |||||
| DARBY, Barbara Joan | Geschäftsführer | Emmerson House School Lane Redbourne DN21 4QN Gainsborough Lincolnshire | British | 52184420001 | ||||||
| DARBY, Michael John | Geschäftsführer | New House School Lane DN21 4QN Redbourne Lincolnshire | British | 18981290001 | ||||||
| DAVENPORT, Kathryn Anne | Geschäftsführer | Stoneleigh 2 Moorfield Way LS29 8BX Ilkley West Yorkshire | British | 104948570001 | ||||||
| EDWARDS, Adrian Stewart | Geschäftsführer | Church Path CB10 1JP Saffron Walden 2 Essex | England | British | 101404540002 | |||||
| GYLLENHAMMAR, Peter Jan Patrik Valentin | Geschäftsführer | Banergatan 3 FOREIGN Stockholm Sweden | Sweden | Swedish | 76805000001 | |||||
| GYLLENHAMMER, Peter Jan Patrik Valentin | Geschäftsführer | Banergatan 3 3tr Stockholm Se-114 56 Sweden | Swedish | 85781920001 | ||||||
| HARDY, Howard | Geschäftsführer | 13 North Street DN21 2HP Gainsborough Lincolnshire | British | 69084070002 | ||||||
| HART, Frederick Harry | Geschäftsführer | 33 Foxhill LE15 7HB Whissendine Rutland | British | 45291310001 | ||||||
| HASWELL, Steven Hedley | Geschäftsführer | Greystones Brackenwell Lane North Rigton LS17 0DG Leeds North Yorkshire | British | 16991280001 | ||||||
| HAYES, Michael Hugh | Geschäftsführer | Wenlock Mounthooly TD8 6TJ Jedburgh Roxburghshire | Scotland | British | 50729030001 | |||||
| HOLMSTROM, Jan Gustaf Lennart | Geschäftsführer | Strandstigen 3 Strandstigen 3 SE18134 Se-18134 Lidingo Sweden | Sweden | Swedish | 152201540001 | |||||
| HOPCROFT, Martin Peter | Geschäftsführer | 1 The Pastures Edlesborough LU6 2HL Dunstable Bedfordshire | British | 40168200002 | ||||||
| KNIGHT, Patrick Stephen Provis | Geschäftsführer | Hafod Wen LL65 2NJ Rhoscolyn Anglesey Gwynedd | Wales | British | 97288820001 | |||||
| LANGTON, Paul | Geschäftsführer | Fieldside Lodge Waterside Winteringham DN17 9PG Scunthorpe S Humberside | British | 19038720001 | ||||||
| MAHER, Michael | Geschäftsführer | Norwood Shortheath Road GU9 8SL Farnham Surrey | England | British | 64239090001 | |||||
| MILLS, Christopher Harwood Bernard | Geschäftsführer | Cliveden Place SW1W 8LA London 10 | United Kingdom | British | 35557050001 | |||||
| PAPADOPOULOS, James | Geschäftsführer | Westhurst Drive BR7 6HS Chislehurst 87 Kent | British | 139470540001 | ||||||
| QUEEN, Roger Charles | Geschäftsführer | The Old Rectory Dishforth YO7 3LP Thirsk North Yorkshire | United Kingdom | British | 78822570002 | |||||
| SHORT, Philip Christopher | Geschäftsführer | Waterside Outgate Ealand DN17 4JE Scunthorpe Humberside | British | 19038710001 | ||||||
| SIMPSON, Christopher Michael | Geschäftsführer | 4 Bellbutts View Scotter DN21 3UX Gainsborough Lincolnshire | England | British | 52678440001 |
Hat 01285055 LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 07. März 2007 Geliefert am 27. März 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 32-35 hoylake road bottesford t/no HS175599 the rental sums the goodwill. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Dez. 2006 Geliefert am 16. Dez. 2006 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plots 32-35 hoylake road, bottesford, scunthorpe, north lincolnshire t/no. HS175599. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 29. Juli 1991 Geliefert am 01. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Part plot 5 sunningdale rd. Scunthorpe t/n-160513 & plots 5A-9A sunningdale road scunthorpe t/n-161066 & plots 32-35 hoylake rd scunthorpe t/n-HS175599. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Aug. 1989 Geliefert am 25. Aug. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Plots 32-35 hoylake road, bottesford, humberside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Okt. 1988 Geliefert am 05. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H part plot 5, sunningdale road, scunthorpe, south humberside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Okt. 1988 Geliefert am 05. Nov. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H plots 5A, 6, 7, 8, 9 and 9A sunningdale road, scunthorpe, south humberside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. Dez. 1987 Geliefert am 30. Dez. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Horizontal glass toughening plant including heating chamber, batch system and fully automatic conveyor on rollers type t-p-r-13 x 440V-50 hertz 2000 x 3600 (see 395 for full details relevant to this charge). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. März 1987 Geliefert am 10. März 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold-plot 5A sunningdale road, scunthorpe, south humberside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental charge | Erstellt am 27. Feb. 1987 Geliefert am 12. März 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land situate on the north side of sunningdale road, scunthorpe humberside. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures and fixed plant and machinery from time to time thereon and therein. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Okt. 1985 Geliefert am 15. Okt. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold 6, 8A, 9 and 9A sunningdale road, scunthorpe, south humberside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 19. Juni 1985 Geliefert am 21. Juni 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Legal mortgage over l/hold plot of land at sunningdale road scunthorpe south humberside known as plot 9A sunningdale road. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) and fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 19. Juni 1985 Geliefert am 21. Juni 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of assignment the following plant machinery chattels or other equipment of the company. Stillage storage and rackery equipment internal over head crane serial number dmh 4318. see document M24 for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Collateral debenture | Erstellt am 25. Sept. 1984 Geliefert am 28. Sept. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the teakglade limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben Together with stock-in trade work in progress, pre payments stocks exchange investments & cash.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 02. Aug. 1984 Geliefert am 08. Aug. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge by way of legal mortgage over:- plot of land at sunningdale road south park industrial estate scunthorpe, south humberside known as plot 9 together with all buildings fixed plant machinery fixtures. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 02. Aug. 1984 Geliefert am 08. Aug. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge by way of assignment over:- pannkoke single head cutting fine (see doc M21 for details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental legal charge | Erstellt am 25. Okt. 1983 Geliefert am 27. Okt. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben All book debts and other debts present & future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Chattel mortgage | Erstellt am 28. Jan. 1983 Geliefert am 02. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1 horizontal glass toughenine plant including heating chamber batch system and fully automatic conveyor on rollers type t-p-r-13X440V-sohz-2000X3600 so catedat sunningdale road, scunthorpe, south humberside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Jan. 1983 Geliefert am 02. Feb. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital, stock-in-trade, work-in-progress, pre-payments, stock exchange investments a cash will all buildings, trade & other fixtures, fixed pland & machinery. L/hold 6-8 sunningdale road & 31-32 northampton road, scunthorpe, south humberside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 30. Juli 1981 Geliefert am 06. Aug. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge on all book debts and other debts of the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Juli 1981 Geliefert am 04. Aug. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold lands hereditaments & premises being:- 6, 7, & 8 sunningdale road, scunthorpe south humberside. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 22. Mai 1981 Geliefert am 29. Mai 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold, 7 and 8 sunningdale road, scunthorpe. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 13. Mai 1981 Geliefert am 20. Mai 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed charge on leashold land and buildings at sunningdale road scunthorpe. And all buildings, fixtures (inc. Tradefixtures) fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 04. Sept. 1980 Geliefert am 10. Sept. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 6, 7 & 8 sunningdale road, moorawell road industrial estate boltesford scunthorpe all fixtures present & future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 12. Mai 1980 Geliefert am 16. Mai 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/Hold, factory premises situate in northampton road, known as 31 & 32, scunthorpe together with all fixtures present and fixture. Title no. Hs 39163. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 26. Sept. 1977 Geliefert am 03. Okt. 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating charge on the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0