BREANSTAR LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameBREANSTAR LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01286266
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von BREANSTAR LIMITED?

    • Sonstige Vermietung und Verpachtung eigener oder gepachteter Immobilien (68209) / Grundstücks- und Wohnungswesen
    • Tätigkeiten der Hauptniederlassungen (70100) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich BREANSTAR LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Sterling Ford Centurion Court
    83 Camp Road
    AL1 5JN St Albans
    Herts
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BREANSTAR LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für BREANSTAR LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 SeitenLIQ13

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Mai 2020

    6 SeitenLIQ03

    Erfüllung der Belastung 31 vollständig

    2 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 17 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 15 vollständig

    1 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 40 vollständig

    2 SeitenMR04

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Mai 2017

    6 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Mai 2019

    6 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Mai 2018

    6 SeitenLIQ03

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 04. Mai 2017

    6 SeitenLIQ03

    Einzelheiten zur Änderung der an Aktien geknüpften Rechte

    3 SeitenSH10

    Änderung der Bezeichnung der Aktienklasse

    2 SeitenSH08

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Roma Building 32-38 Scrutton Street Bishopsgate London EC2A 4RQ zum Sterling Ford Centurion Court 83 Camp Road St Albans Herts AL1 5JN am 27. Mai 2016

    2 SeitenAD01

    Beschlüsse

    Resolutions
    23 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Änderung der Aktienrechte oder der Bezeichnung

    RES12
    incorporation

    Beschluss zur Annahme der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 05. Mai 2016

    LRESSP

    Beschlüsse

    Resolutions
    3 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Waive article 6 pre-emption transfer 100 ord shares 05/04/2016
    RES13

    Erfüllung der Belastung 41 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 39 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 35 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 32 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 012862660043 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 36 vollständig

    4 SeitenMR04

    Wer sind die Geschäftsführer von BREANSTAR LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    MORNINGTON SECRETARIES LIMITED
    43 Mornington Road
    E4 7DT Chingford
    London
    Sekretär
    43 Mornington Road
    E4 7DT Chingford
    London
    87701330001
    BARD, Sonia Rita
    32/38 Scrutton Street
    EC2A 4RQ Bishopsgate
    The Roma Building
    London
    England
    Geschäftsführer
    32/38 Scrutton Street
    EC2A 4RQ Bishopsgate
    The Roma Building
    London
    England
    EnglandBritish61446740003
    BURNS, Gary Anthony
    E4 7DT Chingford
    43 Mornington Road
    London
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    E4 7DT Chingford
    43 Mornington Road
    London
    United Kingdom
    United KingdomBritish153088020003
    GOLDSTEIN, Michael Howard
    83 Camp Road
    AL1 5JN St Albans
    Sterling Ford Centurion Court
    Herts
    Geschäftsführer
    83 Camp Road
    AL1 5JN St Albans
    Sterling Ford Centurion Court
    Herts
    EnglandEnglish206395540001
    MILNER, Paul George
    Muswell Hill
    N10 3QH London
    32 Etheldene Avenue
    England
    Geschäftsführer
    Muswell Hill
    N10 3QH London
    32 Etheldene Avenue
    England
    EnglandBritish100051650001
    CREATIVE ACCOUNTING SERVICES LTD
    845d High Road
    North Finchley
    N12 8PT London
    Geschäftsführer
    845d High Road
    North Finchley
    N12 8PT London
    83774710004
    ALEXANDER-PASSE, Anita Alexander
    34-36 Maddox Street
    W1R 9PD London
    Sekretär
    34-36 Maddox Street
    W1R 9PD London
    British24777130001
    BERGER, David
    110 Leonard Street
    EC2A 4RH London
    Sekretär
    110 Leonard Street
    EC2A 4RH London
    British32936560002
    DRAPER, Adam
    Studio 3
    75 Leonard Street
    EC2 London
    Sekretär
    Studio 3
    75 Leonard Street
    EC2 London
    British65719670001
    MITRA, Vinod Kumar
    40 Crowndale
    SE19 London
    Sekretär
    40 Crowndale
    SE19 London
    British63428280001
    MITRA, Vinod Kumar
    40 Crowndale
    SE19 London
    Sekretär
    40 Crowndale
    SE19 London
    British63428280001
    THORNE, Anthony Gordon
    43 Mornington Road
    Chingford
    E4 7DJ London
    Sekretär
    43 Mornington Road
    Chingford
    E4 7DJ London
    British70938870001
    BURNS, Gary Anthony
    2 Huson Close
    NW3 London
    Geschäftsführer
    2 Huson Close
    NW3 London
    United KingdomBritish153088020001
    MILLER, Ivor
    Flat 6 Goodwood Close
    24-26 Marsh Lane
    HA7 4HX Stanmore
    Middlesex
    Geschäftsführer
    Flat 6 Goodwood Close
    24-26 Marsh Lane
    HA7 4HX Stanmore
    Middlesex
    United KingdomBritish8310690001
    MURPHY, Simon
    1 Roydon Road
    SG12 8HN Stanstead Abbotts
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    1 Roydon Road
    SG12 8HN Stanstead Abbotts
    Hertfordshire
    British67108200002

    Hat BREANSTAR LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 03. Dez. 2013
    Geliefert am 04. Dez. 2013
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    All that freehold land known as 80 and 82 hornsey park road, london N8 6NY title no NGL414942. Notification of addition to or amendment of charge.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Dez. 2013Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 31. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Okt. 2008
    Geliefert am 08. Nov. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Colonial buildings 59-61 hatton gardens london see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Nov. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 11. Apr. 2007
    Geliefert am 14. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 11. Apr. 2007
    Geliefert am 14. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 141/143 shoreditch high street london t/no EGL431546. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Mai 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 11. Apr. 2007
    Geliefert am 14. Apr. 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 16 anning street and 44/46 new inn yard london t/no LN53793. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 06. Apr. 2005
    Geliefert am 12. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £180,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Basement flat 42-43 compton road, london, by way of fixed charge all rental income present or future, the proceeds of any sale, all rights and claims of the borrower against all lessees, sub-lessees, licensees or ocupiers of the property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Awardprop Limited
    Transaktionen
    • 12. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage deed
    Erstellt am 21. März 2003
    Geliefert am 27. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property 101-105 high road, ilford, essex t/n EGL364160. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Apr. 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deeds
    Erstellt am 21. März 2003
    Geliefert am 26. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 420-436 holloway road london N7, 16-40 enkel street london N7 and 73 roden street london N7. T/no NGL170494, 184210 & 184212. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage deed
    Erstellt am 20. März 2002
    Geliefert am 30. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/a 75 dean street soho london t/n 163298. together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Dez. 1998
    Geliefert am 29. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    8 & 10 long street london borough of hackney. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Apr. 1998
    Geliefert am 06. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H and l/h property k/a 98-108 lowermarsh london t/no's LN41946 (freehold) SGL23263 & SGL127959 (both leasehold). And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Mortgage
    Erstellt am 30. Apr. 1998
    Geliefert am 01. Mai 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H holmes house holmes place waterloo SE1. T/n-LN40377.. Together with all buildings and fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery by way of fixed charge all present and future book and other debts floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment by way of assignment the goodwill of the business (if any) the full benefit of all licences and all guarantees.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Mai 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. März 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Juli 1997
    Geliefert am 24. Juli 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 78 antrim mansions london NW3; 15 thurleigh court london SW12; 9 chapel street london N1; 11 thurleigh court london SW12; 14 greenwich court london E2; 4 thurleigh court london SW12 and 10 thurleigh court london SW12. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juli 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Mai 2014Teilweise Erfüllung einer Belastung (MR04)
    • 02. Juni 2020Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 15. Juli 1996
    Geliefert am 18. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/as 7-8 manningtree street & 8 whitechurch passage london E1 t/no egl 183416 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal mortgage
    Erstellt am 05. Sept. 1995
    Geliefert am 12. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The f/h property k/as 154 canonbury road london borough of islington.t/no.LN115997 and the proceeds of sale thereof together with A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Juni 1993
    Geliefert am 13. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    5 nursery street tottenham l/b of haringey t/no.NGL257358.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 17. Okt. 1991
    Geliefert am 25. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    259 hackney rd. E2. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    • 22. Mai 2014Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Mai 1991
    Geliefert am 23. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    448 jessel house judd street, camden title no ngl 556105.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Mai 1991
    Geliefert am 23. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 1 15 poets road highbury, islington title no ngl 666358.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 27. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Mai 1991
    Geliefert am 23. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 3, 15 poets road highbury, islington title no ngl 666354.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Juli 1990
    Geliefert am 31. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    18 king street gravesend kent t/no k 342312.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 13. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Juli 1990
    Geliefert am 31. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    94/94A high street yiewsley t/no ngl 423776.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 13. März 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Apr. 1990
    Geliefert am 08. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    123 shareditch high street, london borough of hackney title no ln 234000.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Okt. 1988
    Geliefert am 21. Okt. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1-4 holywell lane EC2.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Okt. 1988Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Juli 1988
    Geliefert am 28. Juli 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    83 st. Augustine's road l/b of conder t/no. Ln 55149.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Juli 1988Registrierung einer Belastung
    • 23. Okt. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat BREANSTAR LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    05. Mai 2016Beginn der Liquidation
    28. Feb. 2021Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Phillip Anthony Roberts
    Centurion Court, 83 Camp Road
    AL1 5JN St Albans
    Hertfordshire
    Praktiker
    Centurion Court, 83 Camp Road
    AL1 5JN St Albans
    Hertfordshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0