BUDGET GAS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | BUDGET GAS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01287897 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von BUDGET GAS LIMITED?
- Großhandel mit anderen Brennstoffen und damit verbundenen Produkten (46719) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich BUDGET GAS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Athena House Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Warwickshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von BUDGET GAS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2020 |
Welche sind die letzten Einreichungen für BUDGET GAS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 4 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Shaun Peter Macdonald als Geschäftsführer am 10. Nov. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Rogerio Lopes als Direktor am 17. Okt. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Matthew Quentin Hickin als Geschäftsführer am 30. Sept. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Dez. 2021 bis 30. Dez. 2021 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 9 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 10 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 11 vollständig | 1 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Mr Thomas Michael John Dillon als Direktor am 01. Sept. 2022 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Jonathan Mark Wood als Geschäftsführer am 31. Aug. 2022 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2020 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 23 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Cassandra Louise Worthy als Sekretär am 20. Mai 2020 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Rowan Diane Marshall-Rowan als Sekretär am 20. Mai 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Shaun Peter Macdonald als Direktor am 01. Mai 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adam Euan Thompson als Geschäftsführer am 31. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Matthew Quentin Hickin am 12. Dez. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 29. Nov. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von BUDGET GAS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WORTHY, Cassandra Louise | Sekretär | Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Athena House Warwickshire | 270069520001 | |||||||
| DILLON, Thomas Michael John | Geschäftsführer | Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Athena House Warwickshire | England | British | 299893540001 | |||||
| LOPES, Rogerio | Geschäftsführer | Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Athena House Warwickshire | England | Brazilian | 301203980001 | |||||
| MARSHALL-ROWAN, Rowan Diane | Sekretär | Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Athena House Warwickshire England | British | 181215250001 | ||||||
| PERRY, David Edwin | Sekretär | Ferndale House 56 Lady Byron Lane B93 9AY Knowle West Midlands | British | 57200590001 | ||||||
| SHINTON, John | Sekretär | Kingsnorth 17 Oak Drive Seisdon WV5 7ET Wolverhampton West Midlands | British | 23606270001 | ||||||
| WHORTON, Clive James | Sekretär | Athena House Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Warwickshire | British | 81375510002 | ||||||
| BAILEY, Ray | Geschäftsführer | The Lilacs 11/12 Wrockwardine TF6 5DG Telford Salop | British | 75870500001 | ||||||
| DANTON, John | Geschäftsführer | 3 Rawlins Close OX17 3HS Adderbury Oxfordshire | British | 85980570001 | ||||||
| DAVIS, Alexander | Geschäftsführer | Athena House Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Warwickshire | United Kingdom | British | 39645030003 | |||||
| DAVIS, Russell William | Geschäftsführer | Athena House Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Warwickshire | British | 124356830001 | ||||||
| FEENSTRA, Richard | Geschäftsführer | Athena House Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Warwickshire | British | 81084490003 | ||||||
| GODDARD, Geraldine | Geschäftsführer | Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Athena House Warwickshire England | England | British | 68198190001 | |||||
| GYSELINCK, Geert | Geschäftsführer | Athena House Athena Drive, Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Warwickshire | British | 105778000001 | ||||||
| HICKIN, Matthew Quentin | Geschäftsführer | Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Athena House Warwickshire England | England | British | 324637570001 | |||||
| KENNEDY, Patrick Joseph | Geschäftsführer | 3 Aldwick Close CV32 6LP Leamington Spa Warwickshire | Irish | 61398670002 | ||||||
| KERR, Howard Robert | Geschäftsführer | Athena House Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick | British | 73751080004 | ||||||
| KINNAIRD, Susan, Dr | Geschäftsführer | Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Athena House Warwickshire England | England | British | 110670640002 | |||||
| MACDONALD, Shaun Peter | Geschäftsführer | Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Athena House Warwickshire | England | British | 269320760001 | |||||
| NOTTON, Peter Patterson | Geschäftsführer | Athena House Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Warwickshire | England | British | 53965330002 | |||||
| RENNIE, Stephen | Geschäftsführer | Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Athena House Warwickshire | England | British | 136425260001 | |||||
| SHINTON, John | Geschäftsführer | Kingsnorth 17 Oak Drive Seisdon WV5 7ET Wolverhampton West Midlands | British | 23606270001 | ||||||
| TANNER, Jonathan Brian | Geschäftsführer | Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Athena House Warwickshire | England | British | 136425820001 | |||||
| THOMPSON, Adam Euan | Geschäftsführer | Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Athena House Warwickshire | England | British | 166426260002 | |||||
| THOMPSON, Adam Euan | Geschäftsführer | Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Athena House Warwickshire United Kingdom | England | British | 166426260001 | |||||
| WOOD, Jonathan Mark | Geschäftsführer | Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Athena House Warwickshire | England | British | 217139300003 | |||||
| WOOLLEY, Stewart John | Geschäftsführer | Athena House Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Warwickshire | United Kingdom | British | 96242670002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei BUDGET GAS LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calor Gas Limited | 06. Apr. 2016 | Athena Drive Tachbrook Park CV34 6RL Warwick Athena House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat BUDGET GAS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A registered charge | Erstellt am 26. Sept. 2016 Geliefert am 26. Sept. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Enthält eine Negativzusicherung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of admission to an omnibus letter of set-off | Erstellt am 20. Juni 2006 Geliefert am 28. Juni 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 12TH july 1999 | Erstellt am 08. Jan. 2004 Geliefert am 20. Jan. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more of any present or future accounts of the company or any of them with the bank (including any accounts held in the banks name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A deed of admission to an omnibus letter of set-off dated 12TH july 1999 | Erstellt am 20. Dez. 2002 Geliefert am 03. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Any sum or sums for the time being standing to the credit of any one or more present or future accounts of the companies or any of them with the bank (including any accounts held in the bank's name with any designation which includes the name(s) of the companies or any of them) whether such accounts be denominated in sterling or in a currency or currencies other than sterling. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 07. Juli 2000 Geliefert am 14. Juli 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land being the land lying to the south of lewis street pontwelly t/n wa 854931. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Sept. 1998 Geliefert am 17. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or bates & hunt group limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Tunstall liquid petroleum gas plant tunstall ravensdale staffordshire t/nos: SF10285 and SF52239. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Dez. 1990 Geliefert am 08. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All piece or parcel or f/h land at halesfield 21 telford shropshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Dez. 1990 Geliefert am 08. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at bannerlay rd garretts green, birmingham west midlands title nos wm 446082 wm 439690. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Dez. 1990 Geliefert am 08. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land lying to the north west of heslop, telford shropshire title no sl 15593. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 20. Dez. 1990 Geliefert am 07. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Dez. 1990 Geliefert am 03. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All f/h and l/h property of the company (see doc 395 ref: M278C for full details) including all structures, fixtures, (including trade) and fixed plant, machinery and equipment. All future f/h & l/h property including all structures, fixtures etc as above. The goodwill of the business. All book & other debts. All benefits. All shares a first charge on all lpg customer tanks lpg plant & machinery and lpg cylinders now used in the business. A first charge on all lpg customer tanks lpg plant and machinery & lpg cylinders at any time hereafter.. Undertaking and all property and assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Nov. 1979 Geliefert am 20. Nov. 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Industrial premises at heslop halesfield telford salop as comprised in a lease dated 10/8/79. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat BUDGET GAS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0