HAMMOND LOGISTICS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HAMMOND LOGISTICS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01290841 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HAMMOND LOGISTICS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich HAMMOND LOGISTICS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Pannell House 159 Charles Street LE1 1LD Leicester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HAMMOND LOGISTICS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| RICKABY AND LEE TRANSPORT LIMITED | 29. März 1985 | 29. März 1985 |
| RICKABY & LEE TRANSPORT (PUDSEY) LIMITED | 15. Dez. 1976 | 15. Dez. 1976 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HAMMOND LOGISTICS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HAMMOND LOGISTICS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 14 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 21. Sept. 2015 | 12 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Andrew Cullingford als Geschäftsführer am 30. Juni 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 105 Duke Street Liverpool Merseyside L1 5JQ zum Pannell House 159 Charles Street Leicester LE1 1LD am 07. Okt. 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Erfüllung der Belastung 20 vollständig | 3 Seiten | MR04 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 8 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Iain Alexander Speak am 01. Mai 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Paul Andrew Cullingford am 01. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HAMMOND LOGISTICS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BIBBY BROS. & CO. (MANAGEMENT) LIMITED | Sekretär | 105 Duke Street L1 5JQ Liverpool Merseyside | 153567030002 | |||||||
| SPEAK, Iain Alexander | Geschäftsführer | Duke Street L1 5JQ Liverpool 105 United Kingdom | United Kingdom | British | 54684840001 | |||||
| LAW, Martin | Sekretär | 16 Bumblehole Meadows Wombourne WV5 8BG Wolverhampton Staffordshire | British | 73908170001 | ||||||
| PICKLES, Patricia | Sekretär | 44 Crag Hill Road Thackley BD10 0AH Bradford Yorkshire | British | 6318470001 | ||||||
| SMITH, Philip Michael Forster | Sekretär | 19 Bowers Way AL5 4EP Harpenden Hertfordshire | British | 35806430001 | ||||||
| ATTOCK, George William | Geschäftsführer | Hill Top Wilsden Road BD16 1BG Harden Bingley | British | 22169650001 | ||||||
| CULLINGFORD, Paul Andrew | Geschäftsführer | Duke Street L1 5JQ Liverpool 105 United Kingdom | Wales | British | 53644130003 | |||||
| CUTLER, John Edward | Geschäftsführer | The White House 8 Moor Hall Drive Four Oaks B75 6LP Sutton Coldfield West Midlands | United Kingdom | British | 126241800001 | |||||
| DE PENCIER, Theodore Henry John | Geschäftsführer | Aysgarth House 9 Moreton Avenue AL5 2EU Harpenden Hertfordshire | England | British | 45068720001 | |||||
| LEE, Rodney | Geschäftsführer | 36 Ganners Road Bramley LS13 2PB Leeds West Yorkshire | British | 15512450001 | ||||||
| POLLARD, Geoffrey | Geschäftsführer | 10 Grasleigh Way Allerton BD15 9AN Bradford West Yorkshire | British | 76191570001 | ||||||
| RICKABY, Robert William | Geschäftsführer | 18 Ash Dene Crescent LS28 8NS Pudsey West Yorkshire | British | 49347490001 | ||||||
| SHARP, Garry Macdonald | Geschäftsführer | 6 Pembroke Mews Morgan Street E3 5AW London | British | 6245120001 | ||||||
| SHARP, Gary | Geschäftsführer | Clough Green Farm Cawthorne S75 4AB Barnsley South Yorkshire | British | 92322610001 | ||||||
| SHARP, Gary | Geschäftsführer | Clough Green Farm Cawthorne S75 4AB Barnsley South Yorkshire | British | 92322610001 | ||||||
| SIMONS, David Frank | Geschäftsführer | Grosvenor 32 Fletsand Road SK9 2AB Wilmslow Cheshire | British | 8608100001 | ||||||
| SMITH, Philip Michael Forster | Geschäftsführer | 19 Bowers Way AL5 4EP Harpenden Hertfordshire | United Kingdom | British | 35806430001 | |||||
| SWANNELL, Dennis Peter | Geschäftsführer | Kestrels Chapel Haddlesey YO8 8QQ Selby North Yorkshire | British | 91114820001 | ||||||
| TUTTON, Ian Allen | Geschäftsführer | 8 Sutton Drive Cullingworth BD13 5BQ Bradford West Yorkshire | British | 6318490001 |
Hat HAMMOND LOGISTICS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 01. Aug. 2011 Geliefert am 13. Aug. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 07. Sept. 2005 Geliefert am 17. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 17. Jan. 2003 Geliefert am 28. Jan. 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Aug. 1998 Geliefert am 17. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 2 dealburn road woodroyd industrial estate bradford west yorkshire t/n WYK416541. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 28. Aug. 1998 Geliefert am 17. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or hammond group holdings limited and/or hammond logistics group limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 28. Aug. 1998 Geliefert am 17. Sept. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Unit 1 dealburn road woodroyd industrial estate bradford west yorkshire t/n WYK389702. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed charge on book debts and related rights | Erstellt am 09. Juli 1996 Geliefert am 10. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the agreement dated 8TH july 1996 or otherwise | |
Kurze Angaben Fixed equitable charge over all factored debts the other debts an all related rights. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| A credit agreement | Erstellt am 19. Juli 1991 Geliefert am 25. Juli 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £13670-93 | |
Kurze Angaben All the rights title and interest of the company (please see doc 395 tc ref M99C for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Series of debentures | Erstellt am 27. Juni 1990 Geliefert am 28. Juni 1990 | Vollständig erfüllt | ||
Transaktionen
| ||||
| Charge | Erstellt am 31. Jan. 1990 Geliefert am 02. Feb. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £400,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the principal mortgage dated 27.5.87 and the charge | |
Kurze Angaben L/H land on the west side of dealburn road low moor bradford west yorkshire title no wyk 389702. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 26. Juli 1988 Geliefert am 01. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of legal mortgage l/h land & buildings on south west of dealburn road low moor title no wyk 389702 f/h land approx 3.3 acres & buildings in dealburn road & low moor bradford and the proceeds of sale thereof. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 19. Mai 1988 Geliefert am 25. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at dealburn road, low moor bradford, west yrokshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First charge | Erstellt am 16. Mai 1988 Geliefert am 26. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £800,000 | |
Kurze Angaben Warehouse premises at dealburn road, woodroyd industrial estate, low moor, bradford, west yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 27. Mai 1987 Geliefert am 02. Juni 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £400,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben L/H land at dealburn rd, low moor, bradford tog with buildings erected thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 21. Jan. 1987 Geliefert am 03. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Approx 6 acres of land on the south west side of dealburn road low moor bradford west yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Juni 1983 Geliefert am 13. Juli 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H land and bldgs at dealburn road, k/a woodroyd industrial estate new works rd., Low moor bradford west yorkshire as comprised in a lease dated 20.5.83. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Mai 1983 Geliefert am 24. Mai 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £21,600 | |
Kurze Angaben 3.862 acres (approx) of land with buildings at woodroyd industrial estate new works road low moor bradford. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 20. Mai 1983 Geliefert am 24. Mai 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £75,000 due from the company to the chargee under the terms of the mortgage dated 12.11.82 or this charge | |
Kurze Angaben 3.862 acres (approx) of land with buildings at woodroyd industrial estate new works road low moor bradford. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 12. Nov. 1982 Geliefert am 17. Nov. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £75,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben Assigns all interest in the property referred to in clause 1 of the building agreement dated 12.11.82 and the full benefit of the agreement. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 29. Apr. 1982 Geliefert am 07. Mai 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital and all fixtures plant & machinery (please see doc M28). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat HAMMOND LOGISTICS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0