SSL RETAIL LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSSL RETAIL LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01296016
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SSL RETAIL LIMITED?

    • Sonstiger Einzelhandel nicht in Geschäften, auf Ständen oder Märkten (47990) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen

    Wo befindet sich SSL RETAIL LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Kpmg Llp
    1 St Peter'S Square
    M2 3AE Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SSL RETAIL LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    OLYMPUS SPORT INTERNATIONAL LIMITED30. Juni 198530. Juni 1985

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SSL RETAIL LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis29. Jan. 2012

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SSL RETAIL LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für SSL RETAIL LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Verzichtserklärung auf herrenlose Güter

    1 SeitenBONA

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Sept. 2015

    23 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 25. Sept. 2015

    23 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Juli 2015

    21 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Jan. 2015

    22 Seiten2.24B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE zum Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE am 28. Jan. 2015

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Kpmg Llp St. James's Square Manchester Lancashire M2 6DS zum Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE am 28. Jan. 2015

    2 SeitenAD01

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Juli 2014

    23 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Jan. 2014

    24 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Juli 2013

    24 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. März 2013

    24 Seiten2.24B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * J J B Sports Plc Martland Park Challenge Way Wigan Lancashire WN5 0LD* am 20. Dez. 2012

    2 SeitenAD01

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    35 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    6 Seiten2.16B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beendigung der Bestellung von Keith Jones als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Jan. 2012

    7 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 04. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital08. Juni 2012

    Kapitalaufstellung am 08. Juni 2012

    • Kapital: GBP 40,135,000
    SH01

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschlüsse

    Company business 26/04/2012
    RES13

    legacy

    15 SeitenMG01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Jan. 2011

    7 SeitenAA

    Ernennung von Mr Keith John Jones als Direktor

    2 SeitenAP01

    Wer sind die Geschäftsführer von SSL RETAIL LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    WILLIAMS, David Robert
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Sekretär
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    161511810001
    WILLIAMS, David Robert
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    Geschäftsführer
    1 St Peter's Square
    M2 3AE Manchester
    Kpmg Llp
    United KingdomBritish157062220001
    ASHBY, Jonathan
    Hinckley Court
    CW12 4WE Congleton
    1
    Cheshire
    Sekretär
    Hinckley Court
    CW12 4WE Congleton
    1
    Cheshire
    British134682180001
    FOOT, Peter John Lewis
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    Sekretär
    1 Normanton Lane
    Stanford On Soar
    LE12 5PZ Loughborough
    Leicestershire
    British51176110002
    GREENWOOD, John David
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Sekretär
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    British4527320003
    HEATHER, John Langdale
    32 Beauchamp Avenue
    CV32 5TA Leamington Spa
    Warwickshire
    Sekretär
    32 Beauchamp Avenue
    CV32 5TA Leamington Spa
    Warwickshire
    British33307810001
    KAYE, David Stanley
    56 Castleton Drive
    Newton Mearns
    G77 5LE Glasgow
    Sekretär
    56 Castleton Drive
    Newton Mearns
    G77 5LE Glasgow
    British78278710002
    MADELEY, David Phillip
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    Sekretär
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    British128847520001
    MANNING, Richard Denley John
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Sekretär
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    152719260001
    SIMKINS, Paul Charles
    49 Hazel Crescent
    NN12 6UQ Towcester
    Northamptonshire
    Sekretär
    49 Hazel Crescent
    NN12 6UQ Towcester
    Northamptonshire
    British37115350001
    CLAIRMONTS SOLICITORS
    9 Clairmont Gardens
    G3 7LW Glasgow
    Sekretär
    9 Clairmont Gardens
    G3 7LW Glasgow
    44581680001
    SEARS SPORTS AND LEISUREWEAR PLC
    Sunningdale Road
    LE3 1TP Leicester
    Sekretär
    Sunningdale Road
    LE3 1TP Leicester
    16600870001
    CHAMBERLAIN, Adrian
    Butlers Hall
    Wareside
    SG12 7QL Ware
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Butlers Hall
    Wareside
    SG12 7QL Ware
    Hertfordshire
    British117106730001
    CLIFFORD, Timothy David Ordish
    Flint House
    Hatherden
    SP11 0HP Andover
    Hampshire
    Geschäftsführer
    Flint House
    Hatherden
    SP11 0HP Andover
    Hampshire
    British44473790001
    COPPOCK, Lawrence Patrick
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    EnglandUnited Kingdom152718990001
    DAVIES, Philip Norman
    62 Cunningham Drive
    LE17 4YR Lutterworth
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    62 Cunningham Drive
    LE17 4YR Lutterworth
    Leicestershire
    British30542390001
    DUNN, Barry John Keith
    The Farm House
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    Geschäftsführer
    The Farm House
    Back Lane Heath Charnock
    PR6 9DJ Chorley
    United KingdomBritish60493690005
    FALLON, John Edward
    Gardeners Cottage Old Hall Drive
    Widmerpool Keyworth
    NG12 5PZ Nottingham
    Geschäftsführer
    Gardeners Cottage Old Hall Drive
    Widmerpool Keyworth
    NG12 5PZ Nottingham
    British52124910001
    GLANVILLE, Richard
    Crooked Willows
    Wash Road
    SS15 4BP Basildon
    Essex
    Geschäftsführer
    Crooked Willows
    Wash Road
    SS15 4BP Basildon
    Essex
    British69669910004
    GRABINER, Ian Michael
    Daylesford
    5 Methven Road
    G46 6TG Glasgow
    Geschäftsführer
    Daylesford
    5 Methven Road
    G46 6TG Glasgow
    ScotlandBritish63235540002
    GREEN, Philip Nigel Ross, Sir
    129 Marylebone Road
    London
    Nw1 5qd
    Geschäftsführer
    129 Marylebone Road
    London
    Nw1 5qd
    United KingdomBritish103945640001
    GREENWOOD, John David
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    1 Brookside
    Euxton
    PR7 6HR Chorley
    Lancashire
    United KingdomBritish4527320003
    GUNTER, Kevin
    9 Hawthorn Drive
    Uppingham
    LE15 9TA Oakham
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    9 Hawthorn Drive
    Uppingham
    LE15 9TA Oakham
    Leicestershire
    British55255580001
    HELME, John Frederick
    23 Peacock Place
    NN1 2DP Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    23 Peacock Place
    NN1 2DP Northampton
    Northamptonshire
    British34463520002
    HUNTER, Thomas Blane, Sir
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    Geschäftsführer
    Ladykirk House
    Ladykirk Estate
    KA9 2SF Monkton
    United KingdomBritish97904280003
    JONES, Andrew Gethin
    Orchard Bank Button Bridge Lane
    DY12 3DN Bewdley
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Orchard Bank Button Bridge Lane
    DY12 3DN Bewdley
    Worcestershire
    British57400720001
    JONES, Anthony David
    32 Howe Lane
    LE7 7LB Rothley
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    32 Howe Lane
    LE7 7LB Rothley
    Leicestershire
    British41640680002
    JONES, Keith John
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    United KingdomBritish149574500001
    KINNAIRD, John
    1 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    Geschäftsführer
    1 Courthill
    Bearsden
    G61 3SN Glasgow
    Lanarkshire
    British70691510002
    KNIGHT, Thomas William
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    Geschäftsführer
    Flat 5 Eastfield House
    15 Moor Road South
    NE3 1ND Gosforth
    British11423040008
    LOVELOCK, Derek John
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Oldfields Farm
    Amersham Road
    HP9 2UG Beaconsfield
    Buckinghamshire
    EnglandBritish116560620001
    LUSTMAN, Margaret Eve
    25 Sherriff Road
    NW6 2AS London
    Geschäftsführer
    25 Sherriff Road
    NW6 2AS London
    British40930620001
    MADELEY, David Phillip
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Mill Lane
    WA15 0RD Ashley
    One Castle Mill
    Cheshire
    EnglandBritish128847520001
    MANNING, Richard Denley John
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    Geschäftsführer
    J J B Sports Plc
    Martland Park Challenge Way
    WN5 0LD Wigan
    Lancashire
    EnglandBritish77961690002
    MCCLUSKEY, Brian
    5b Longbank Road
    Alloway
    KA7 4SA Ayr
    Ayrshire
    Uk
    Geschäftsführer
    5b Longbank Road
    Alloway
    KA7 4SA Ayr
    Ayrshire
    Uk
    British68223140002

    Hat SSL RETAIL LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 27. Apr. 2012
    Geliefert am 04. Mai 2012
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and from each other chargor (except as guarantor for the company) to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC (As Security Agent for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 04. Mai 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 03. Juni 2009
    Geliefert am 17. Juni 2009
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and each other chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 17. Juni 2009Registrierung einer Belastung (395)
    Account charge
    Erstellt am 17. Dez. 2008
    Geliefert am 24. Dez. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All of the chargor's rights,title and interest from time to time in and to each charged asset see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC as Agent and Trustee for Itself and Bank of Scotland PLC and Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transaktionen
    • 24. Dez. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 06. Okt. 2008
    Geliefert am 11. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Kaupthing Singer & Friedlander Limited
    Transaktionen
    • 11. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Sept. 2008
    Geliefert am 02. Okt. 2008
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Okt. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2009Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte belastete Eigentum freigegeben wurde (MG04)
    • 07. Apr. 2011Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 26. Sept. 2008
    Geliefert am 29. Sept. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 29. Sept. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 03. Apr. 1996
    Geliefert am 17. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Sept. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 26. Nov. 1995
    Geliefert am 30. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. März 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat SSL RETAIL LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    01. Okt. 2012Beginn der Verwaltung
    25. Sept. 2015Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Brian Green
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    Praktiker
    Kpmg Llp
    St James' Square
    M2 6DS Manchester
    David James Costley-Wood
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester
    Praktiker
    Kpmg Llp
    St James Square
    M2 6DS Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0