SSL RETAIL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SSL RETAIL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01296016 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SSL RETAIL LIMITED?
- Sonstiger Einzelhandel nicht in Geschäften, auf Ständen oder Märkten (47990) / Handel; Instandhaltung und Reparatur von Kraftfahrzeugen
Wo befindet sich SSL RETAIL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Kpmg Llp 1 St Peter'S Square M2 3AE Manchester |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SSL RETAIL LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| OLYMPUS SPORT INTERNATIONAL LIMITED | 30. Juni 1985 | 30. Juni 1985 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SSL RETAIL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 29. Jan. 2012 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für SSL RETAIL LIMITED?
| Jahresabschluss |
|
|---|
Welche sind die letzten Einreichungen für SSL RETAIL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Verzichtserklärung auf herrenlose Güter | 1 Seiten | BONA | ||||||||||
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 25. Sept. 2015 | 23 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 25. Sept. 2015 | 23 Seiten | 2.35B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Juli 2015 | 21 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Jan. 2015 | 22 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE zum Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE am 28. Jan. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O Kpmg Llp St. James's Square Manchester Lancashire M2 6DS zum Kpmg Llp 1 St Peter's Square Manchester M2 3AE am 28. Jan. 2015 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Juli 2014 | 23 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Jan. 2014 | 24 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 02. Juli 2013 | 24 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung | 1 Seiten | 2.31B | ||||||||||
Fortschrittsbericht des Verwalters bis 31. März 2013 | 24 Seiten | 2.24B | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * J J B Sports Plc Martland Park Challenge Way Wigan Lancashire WN5 0LD* am 20. Dez. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge | 1 Seiten | F2.18 | ||||||||||
Vorschlag des Verwalters | 35 Seiten | 2.17B | ||||||||||
Vermögensübersicht mit Formular 2.14B | 6 Seiten | 2.16B | ||||||||||
Ernennung eines Verwalters | 1 Seiten | 2.12B | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Keith Jones als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Jan. 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 04. Juni 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
legacy | 15 Seiten | MG01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Jan. 2011 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Keith John Jones als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SSL RETAIL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WILLIAMS, David Robert | Sekretär | 1 St Peter's Square M2 3AE Manchester Kpmg Llp | 161511810001 | |||||||
| WILLIAMS, David Robert | Geschäftsführer | 1 St Peter's Square M2 3AE Manchester Kpmg Llp | United Kingdom | British | 157062220001 | |||||
| ASHBY, Jonathan | Sekretär | Hinckley Court CW12 4WE Congleton 1 Cheshire | British | 134682180001 | ||||||
| FOOT, Peter John Lewis | Sekretär | 1 Normanton Lane Stanford On Soar LE12 5PZ Loughborough Leicestershire | British | 51176110002 | ||||||
| GREENWOOD, John David | Sekretär | 1 Brookside Euxton PR7 6HR Chorley Lancashire | British | 4527320003 | ||||||
| HEATHER, John Langdale | Sekretär | 32 Beauchamp Avenue CV32 5TA Leamington Spa Warwickshire | British | 33307810001 | ||||||
| KAYE, David Stanley | Sekretär | 56 Castleton Drive Newton Mearns G77 5LE Glasgow | British | 78278710002 | ||||||
| MADELEY, David Phillip | Sekretär | Mill Lane WA15 0RD Ashley One Castle Mill Cheshire | British | 128847520001 | ||||||
| MANNING, Richard Denley John | Sekretär | J J B Sports Plc Martland Park Challenge Way WN5 0LD Wigan Lancashire | 152719260001 | |||||||
| SIMKINS, Paul Charles | Sekretär | 49 Hazel Crescent NN12 6UQ Towcester Northamptonshire | British | 37115350001 | ||||||
| CLAIRMONTS SOLICITORS | Sekretär | 9 Clairmont Gardens G3 7LW Glasgow | 44581680001 | |||||||
| SEARS SPORTS AND LEISUREWEAR PLC | Sekretär | Sunningdale Road LE3 1TP Leicester | 16600870001 | |||||||
| CHAMBERLAIN, Adrian | Geschäftsführer | Butlers Hall Wareside SG12 7QL Ware Hertfordshire | British | 117106730001 | ||||||
| CLIFFORD, Timothy David Ordish | Geschäftsführer | Flint House Hatherden SP11 0HP Andover Hampshire | British | 44473790001 | ||||||
| COPPOCK, Lawrence Patrick | Geschäftsführer | J J B Sports Plc Martland Park Challenge Way WN5 0LD Wigan Lancashire | England | United Kingdom | 152718990001 | |||||
| DAVIES, Philip Norman | Geschäftsführer | 62 Cunningham Drive LE17 4YR Lutterworth Leicestershire | British | 30542390001 | ||||||
| DUNN, Barry John Keith | Geschäftsführer | The Farm House Back Lane Heath Charnock PR6 9DJ Chorley | United Kingdom | British | 60493690005 | |||||
| FALLON, John Edward | Geschäftsführer | Gardeners Cottage Old Hall Drive Widmerpool Keyworth NG12 5PZ Nottingham | British | 52124910001 | ||||||
| GLANVILLE, Richard | Geschäftsführer | Crooked Willows Wash Road SS15 4BP Basildon Essex | British | 69669910004 | ||||||
| GRABINER, Ian Michael | Geschäftsführer | Daylesford 5 Methven Road G46 6TG Glasgow | Scotland | British | 63235540002 | |||||
| GREEN, Philip Nigel Ross, Sir | Geschäftsführer | 129 Marylebone Road London Nw1 5qd | United Kingdom | British | 103945640001 | |||||
| GREENWOOD, John David | Geschäftsführer | 1 Brookside Euxton PR7 6HR Chorley Lancashire | United Kingdom | British | 4527320003 | |||||
| GUNTER, Kevin | Geschäftsführer | 9 Hawthorn Drive Uppingham LE15 9TA Oakham Leicestershire | British | 55255580001 | ||||||
| HELME, John Frederick | Geschäftsführer | 23 Peacock Place NN1 2DP Northampton Northamptonshire | British | 34463520002 | ||||||
| HUNTER, Thomas Blane, Sir | Geschäftsführer | Ladykirk House Ladykirk Estate KA9 2SF Monkton | United Kingdom | British | 97904280003 | |||||
| JONES, Andrew Gethin | Geschäftsführer | Orchard Bank Button Bridge Lane DY12 3DN Bewdley Worcestershire | British | 57400720001 | ||||||
| JONES, Anthony David | Geschäftsführer | 32 Howe Lane LE7 7LB Rothley Leicestershire | British | 41640680002 | ||||||
| JONES, Keith John | Geschäftsführer | J J B Sports Plc Martland Park Challenge Way WN5 0LD Wigan Lancashire | United Kingdom | British | 149574500001 | |||||
| KINNAIRD, John | Geschäftsführer | 1 Courthill Bearsden G61 3SN Glasgow Lanarkshire | British | 70691510002 | ||||||
| KNIGHT, Thomas William | Geschäftsführer | Flat 5 Eastfield House 15 Moor Road South NE3 1ND Gosforth | British | 11423040008 | ||||||
| LOVELOCK, Derek John | Geschäftsführer | Oldfields Farm Amersham Road HP9 2UG Beaconsfield Buckinghamshire | England | British | 116560620001 | |||||
| LUSTMAN, Margaret Eve | Geschäftsführer | 25 Sherriff Road NW6 2AS London | British | 40930620001 | ||||||
| MADELEY, David Phillip | Geschäftsführer | Mill Lane WA15 0RD Ashley One Castle Mill Cheshire | England | British | 128847520001 | |||||
| MANNING, Richard Denley John | Geschäftsführer | J J B Sports Plc Martland Park Challenge Way WN5 0LD Wigan Lancashire | England | British | 77961690002 | |||||
| MCCLUSKEY, Brian | Geschäftsführer | 5b Longbank Road Alloway KA7 4SA Ayr Ayrshire Uk | British | 68223140002 |
Hat SSL RETAIL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 27. Apr. 2012 Geliefert am 04. Mai 2012 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and from each other chargor (except as guarantor for the company) to each finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 03. Juni 2009 Geliefert am 17. Juni 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and each other chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery. See image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Account charge | Erstellt am 17. Dez. 2008 Geliefert am 24. Dez. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the secured parties on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All of the chargor's rights,title and interest from time to time in and to each charged asset see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 06. Okt. 2008 Geliefert am 11. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 26. Sept. 2008 Geliefert am 02. Okt. 2008 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 26. Sept. 2008 Geliefert am 29. Sept. 2008 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Apr. 1996 Geliefert am 17. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 26. Nov. 1995 Geliefert am 30. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SSL RETAIL LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| In Verwaltung |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0