ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01299174 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED?
- Finanzleasing (64910) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 8 Canada Square London E14 5HQ |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| MIDLAND MONTAGU LEASING (UK) LIMITED | 31. Dez. 1977 | 31. Dez. 1977 |
| MIDLAND BANK LEASING LIMITED | 18. Feb. 1977 | 18. Feb. 1977 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Zweite Einreichung für die Abberufung von Robin Louis Henning Bencard als Geschäftsführer | 5 Seiten | RP04TM01 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robin Louis Henning Bencard als Geschäftsführer am 08. Aug. 2016 | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 9 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Mr Simon Einar Long als Direktor am 15. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David John Cavanna als Geschäftsführer am 31. Dez. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Connelly Anderson als Direktor am 16. Dez. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 2 Seiten | AUD | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 17 Seiten | AA | ||||||||||
Rücktritt des Auditors | 1 Seiten | AUD | ||||||||||
Ernennung von Ms Romana Lewis als Sekretär am 28. Mai 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 28. Mai 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Hannah Elizabeth Shepherd als Sekretär am 05. Jan. 2015 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tony Bhambhra als Sekretär am 05. Jan. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 18 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Katherine Dean als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Tony Bhambhra als Sekretär | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 8 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 52 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LEWIS, Romana | Sekretär | Canada Square 14th Floor Canary Wharf E145HQ London, Greater London 8 England England | 198057330001 | |||||||
| ANDERSON, Michael Connelly | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | England | British | 269666390001 | |||||
| KENT, John Richard | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 174308200001 | |||||
| LONG, Simon Einar | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 206202590001 | |||||
| OWEN CONWAY, Gareth | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 82999960002 | |||||
| SUBRAMANIYAN, Jaya | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | Malaysian | 136924480002 | |||||
| BAYER, George William | Sekretär | Flat 1 Old Bank House, 110 Bermondsey Street SE1 3TX London | Other | 123920600002 | ||||||
| BHAMBHRA, Tony | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 187824090001 | |||||||
| DEAN, Katherine | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 180092630001 | |||||||
| GOTT, Sarah Caroline | Sekretär | Whitworth Street SE10 9EN London 13 United Kingdom | British | 136485400005 | ||||||
| MCKENZIE, John Hume | Sekretär | 37 Lime Trees Staplehurst TN12 0SS Tonbridge Kent | British | 67406010001 | ||||||
| MCQUILLAN, Pauline Louise | Sekretär | 1 Bolney Court Portsmouth Road KT6 4HX Surbiton Surrey | British | 109247130001 | ||||||
| MUSGROVE, Robert Hugh | Sekretär | 6 Barn Meadow Staplehurst TN12 0SY Tonbridge Kent | Other | 76913670001 | ||||||
| NIVEN, Frances Julie | Sekretär | 73 Celestial Gardens SE13 5RU London | British | 78670270001 | ||||||
| PEARCE, Mark Vivian | Sekretär | 55 Huntly Road Talbot Woods BH3 7HG Bournemouth Dorset | British | 26776940002 | ||||||
| READ, Alice | Sekretär | 188 Berglen Court 7 Branch Road E14 7JZ London | British | 106168980003 | ||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 194209390001 | |||||||
| SHEPHERD, Hannah Elizabeth | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 154911840001 | |||||||
| WOOD, Hollie Rheanna | Sekretär | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | 166967400001 | |||||||
| ALDRIDGE, Peter Colin | Geschäftsführer | The Barn,Stoneleigh Quarry Farm Quarry Lane CV9 2RD Macetter Warwickshire | British | 145932800001 | ||||||
| BARKER, Fiona Ann | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 151858510001 | |||||
| BENCARD, Robin Louis Henning | Geschäftsführer | Canada Square E14 5HQ London 8 United Kingdom | United Kingdom | British | 46782110002 | |||||
| BROOKES, Malcolm James | Geschäftsführer | 3 School Close Pinvin WR10 2TZ Pershore Worcestershire | British | 61727900003 | ||||||
| BROWNE, Ian James | Geschäftsführer | 4 Hawkshill Drive Box Lane HP3 0BS Hemel Hempstead Hertfordshire | British | 143599030001 | ||||||
| CARNEY, Brian | Geschäftsführer | Springwood Lodge Owler Park Road LS29 0BG Ilkley West Yorkshire | British | 100001170001 | ||||||
| CAVANNA, David John | Geschäftsführer | 8 Canada Square London E14 5HQ | United Kingdom | British | 180384720001 | |||||
| DEVENISH, William Frederick | Geschäftsführer | 12 Hyde Place OX2 7JB Oxford | British | 52830160002 | ||||||
| EVANS, Geoffrey William | Geschäftsführer | The Trumpet House Kington Lane Claverdon CV35 8PP Warwick | British | 42712190001 | ||||||
| GILMAN, David William | Geschäftsführer | 32 Riverside Drive Selly Oak B29 7ES Birmingham | British | 5681410002 | ||||||
| HOLMES, Timothy Victor | Geschäftsführer | 18 The Badgers Mearse Lane Barnt Green B45 8QR Birmingham | British | 28497420002 | ||||||
| KELL, Christopher Raymond | Geschäftsführer | 6 Gorse Close WR9 7SG Droitwich Worcestershire | British | 87307470001 | ||||||
| KENNY, Mary Bridget | Geschäftsführer | 178 Empire Square West Long Lane SE1 4NL London | United Kingdom | British | 118995490002 | |||||
| LANE, Robert David | Geschäftsführer | 42 Bridgnorth Road WV5 0AA Wombourne Staffordshire | England | British | 150099050001 | |||||
| LEECH, Ian Robert | Geschäftsführer | 139 Lordswood Road Harborne B17 9BL Birmingham | British | 52909330001 | ||||||
| LESTER, Edward Paul | Geschäftsführer | 26 St Barnabas Road CB1 2BY Cambridge Cambridgeshire | British | 4300370001 |
Hat ASSETFINANCE DECEMBER (E) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Lessor's security assignment | Erstellt am 19. Dez. 1996 Geliefert am 27. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage | |
Kurze Angaben All rights,title and interest in respect of clause 5.1 of the conditional sale agreement. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 10. Dez. 1996 Geliefert am 20. Dez. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All or any obligations and liabilities of the company to the chargee to apply or to procure the application of relevant proceeds under or pursuant to the provisions of clauses 15.2(b),19.3(b),21.3(b),24 and schedule 6 of the lease and to sell the vessel or to execute a purchase contract transfer under or pursuant to clause 23 of the lease and under this mortgage | |
Kurze Angaben All rights,title,interest,insurances and proceeds of sale in the vessel "hull 1234". see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of covenant | Erstellt am 04. Juni 1981 Geliefert am 22. Juni 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £3404294 & all monies which may from time to time be or become due to the bank under the security documents & secured by a mortgage dated 4-6-81 | |
Kurze Angaben The mortgaged premises being the ship (see doc M23). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage | Erstellt am 04. Juni 1981 Geliefert am 22. Juni 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on account current under the terms of a financial agreement dated 24-11-80 and a deed of covenant dated 4-6-81 | |
Kurze Angaben 4/64TH shares in m v mensey marines registered in liverpool under official nunber 389177. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Delivery order | Erstellt am 24. Nov. 1980 Geliefert am 04. Dez. 1980 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and midland montague leasing limited pursuant to a financial agreement dated 24-11-80 & deeds supplemental thereto to the chargee | |
Kurze Angaben All the owners rights interest & benefits under a building contract dated 24-11-80 all moneys payable to the owners in respect of insurances the vessel as she is constructed and all materials, machinery (further details see doc M29). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Bond & assignment | Erstellt am 24. Nov. 1980 Geliefert am 04. Dez. 1980 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and midland montague leasing limited pursuant to a financial agreement dated 24.11.80 to the chargee | |
Kurze Angaben All the owners rights interest & benefits under a building contract dated 24.11.80 all moneys payable to the owners in respect of insurances the vessel as she is constructed and all materials, machinery (further details see doc M29). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Financial agreement | Erstellt am 24. Nov. 1980 Geliefert am 04. Dez. 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £3494528 all monies due or to become due from the company and midland montague leasing limited under the terms of a financial agreement dated 24/11/1980 to the chargee | |
Kurze Angaben All the owners right interest & benefits under a building contract dated 24 11 80 all moneys payable to the owners in respect of insurance the vessel in respect of insurance the vessel as she is constructed & all materials, machinery (further details see doc M29). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0