VERTCELL LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | VERTCELL LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01304309 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von VERTCELL LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich VERTCELL LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VERTCELL LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2019 |
Welche sind die letzten Einreichungen für VERTCELL LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 23. Feb. 2021
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Juli 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Philip Herbert als Geschäftsführer am 30. Juni 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Simon Willis als Direktor am 08. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Philip Herbert als Direktor am 01. Apr. 2019 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Timothy Paul Holden als Geschäftsführer am 31. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Trevor Garry Finn als Geschäftsführer am 31. März 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Juli 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hilary Claire Sykes als Geschäftsführer am 01. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Hilary Claire Sykes als Sekretär am 01. Jan. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Trevor Garry Finn am 18. Okt. 2016 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von VERTCELL LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MALONEY, Richard James | Sekretär | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | British | 110894220002 | ||||||||||
| CASHA, Martin Shaun | Geschäftsführer | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 41114490010 | |||||||||
| WILLIS, Mark Simon | Geschäftsführer | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | 229010610001 | |||||||||
| PENDRAGON MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | 2 Oakwood Court Little Oak Drive NG15 0DR Annesley Loxley House Nottinghamshire United Kingdom |
| 110674970001 | ||||||||||
| BENNETT, Michael Ronald | Sekretär | 2 Kentmere Road HP21 7HZ Aylesbury Buckinghamshire | British | 75618940001 | ||||||||||
| BOOTH, Brenda | Sekretär | 62 Redesmere Park Urmston M41 9EP Manchester Lancashire | British | 16249170005 | ||||||||||
| HOLROYD, John | Sekretär | Arncliffe House Farm Starbotton BD23 5HY Skipton North Yorkshire | British | 21483450001 | ||||||||||
| PERRY, Brian | Sekretär | 46 Marlborough Avenue Cheadle Hulme SK8 7AW Cheadle Cheshire | British | 10759770001 | ||||||||||
| SYKES, Hilary Claire | Sekretär | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | British | 41559790001 | ||||||||||
| BIGGS, Anthony Mark | Geschäftsführer | Lime Tree House 2 Braddens Furlong HP18 9BL Long Crendon Buckinghamshire | United Kingdom | British | 46681000002 | |||||||||
| BRAMALL, Douglas Charles Antony | Geschäftsführer | Warren Farm Warren Lane Brearton HG3 3DB Harrogate | United Kingdom | British | 29331220001 | |||||||||
| BROWN, Angus Lushington Wylie | Geschäftsführer | 2 Rockford Lodge WA16 8AH Knutsford Cheshire | British | 10759780001 | ||||||||||
| DAVIS, Andrew Michael | Geschäftsf ührer | 57 Lache Lane CH4 7LP Chester Cheshire | United Kingdom | British | 63557750001 | |||||||||
| DAY, John Osborne | Geschäftsführer | 5 Camellia Way Simons Park RG41 3NB Wokingham Berkshire | British | 76450060001 | ||||||||||
| EGERTON, Peter John | Geschäftsführer | The Wilderness Lea Laughton Horton ST13 8PZ Rudyard Staffordshire | British | 17294880001 | ||||||||||
| FAIRGRIEVE, Thomas Darling | Geschäftsführer | 6 Floors Place KY2 5SF Kirkcaldy Fife | British | 708420001 | ||||||||||
| FINN, Trevor Garry | Geschäftsführer | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | United Kingdom | British | 2652610013 | |||||||||
| FORSYTH, David Robertson | Geschäftsführer | Scotland Cottage Melbourne DE73 1BH Derby | United Kingdom | British | 55127120002 | |||||||||
| HERBERT, Mark Philip | Geschäftsführer | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | 123285980005 | |||||||||
| HOLDEN, Timothy Paul | Geschäftsführer | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | 148034310003 | |||||||||
| HOLROYD, John | Geschäftsführer | Arncliffe House Farm Starbotton BD23 5HY Skipton North Yorkshire | British | 21483450001 | ||||||||||
| MURRAY, Alec Barclay | Geschäftsführer | 24 Harrop Road Hale WA15 9DQ Altrincham Cheshire | United Kingdom | British | 163818290001 | |||||||||
| QUICK, James Anthony | Geschäftsführer | The Spinney 106 Park Road Hale WA15 9JT Altrincham Cheshire | British | 10759800001 | ||||||||||
| ROYLE, Frederick Alfred | Geschäftsführer | Overton 6 Woodhead Road Hale WA15 9LD Altrincham Cheshire | British | 13008590002 | ||||||||||
| SYKES, Hilary Claire | Geschäftsführer | Loxley House 2 Oakwood Court Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Nottinghamshire | England | British | 41559790001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei VERTCELL LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bramall Quicks Limited | 06. Apr. 2016 | Little Oak Drive Annesley NG15 0DR Nottingham Loxley House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat VERTCELL LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| A security agreement | Erstellt am 13. Mai 2009 Geliefert am 21. Mai 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben For details of property charged please refer to form 395. fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed to the guarantee and debenture | Erstellt am 22. Aug. 2002 Geliefert am 03. Sept. 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargor to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Target guarantee and debenture made between the company (the "chargor") and the governor and company of the bank of scotland,as agent and security trustee for the secured parties | Erstellt am 13. Juni 2002 Geliefert am 21. Juni 2002 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from the company to any of the secured parties under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Dez. 1997 Geliefert am 09. Jan. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All present and future obligations and liabilities (whether actual or contingent and whether owed jointly or severally or in any other capacity whatsoever) of each obligor (as defined) to each lender under each designated finance document (as defined) except for: any obligation which is excluded under clause 4.2 of the intercreditor agreement (as defined) and any obligation which if it were so included would result in the debenture contravening section 151 of the companies act 1985 (the "secured liabilities") | |
Kurze Angaben L/H unit 11 ringway trading estate shadowmoss road wythenshawe manchester M22 5LH f/h land and buildings on the south east side of manchester road altrincham WA14 5LZ t/n GM569388 for further details of property charged refer to form 395. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 18. Nov. 1997 Geliefert am 25. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Nov. 1997 Geliefert am 22. Nov. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 29. Apr. 1977 Geliefert am 09. Mai 1977 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land & buildings formerly known as tiffanys gas street, ashton under lyne greater manchester as comprised in a transfer dated 29.4.77. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0