ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01315424 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Trafford House Chester Road Old Trafford M32 0RS Manchester |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
THOMAS BERMINGHAM CONTRACTORS LIMITED | 30. Mai 1977 | 30. Mai 1977 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Dez. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 25 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juni 2019 | 16 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juni 2018 | 13 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom West Point Old Trafford Manchester M16 9HU zum Trafford House Chester Road Old Trafford Manchester M32 0RS am 06. Feb. 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juni 2017 | 9 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juni 2016 | 8 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 25. Juni 2015 | 9 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Lancaster House Centurion Way Leyland Lancashire PR26 6TX zum West Point Old Trafford Manchester M16 9HU am 18. Juli 2014 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 2 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Andrew Nelson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Dez. 2012 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 6 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Ernennung von Sherard Secretariat Services Limited als Sekretär | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Birch als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Latham Nelson als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Gordon House Sceptre Way Bamber Bridge Preston Lancashire PR5 6AW United Kingdom* am 31. Okt. 2011 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SHERARD SECRETARIAT SERVICES LIMITED | Sekretär | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England |
| 109588620001 | ||||||||||
BIRCH, Paul | Geschäftsführer | Chester Road Old Trafford M32 0RS Manchester Trafford House | England | British | Company Secretary | 76116640003 | ||||||||
EASTWOOD, Andrew Michael | Geschäftsführer | Chester Road Old Trafford M32 0RS Manchester Trafford House | England | British | Group Financial Controller | 160883820001 | ||||||||
ANDREWS, Angela | Sekretär | 45 Wadsley Park Crescent S6 4BX Sheffield Yorkshire | British | 54213650001 | ||||||||||
BERMINGHAM, Jean | Sekretär | Wadsley Lodge Laird Road S6 4BS Sheffield | British | 22459530001 | ||||||||||
BIRCH, Paul | Sekretär | Centurion Way PR26 6TX Leyland Lancaster House Lancashire United Kingdom | British | 76116640002 | ||||||||||
GAVAN, John Vincent | Sekretär | 23 Fulshaw Avenue SK9 5JE Wilmslow Cheshire | British | Solicitor | 36153790001 | |||||||||
BERESFORD, Colin Max | Geschäftsführer | 122 Sandygate Road S10 5RZ Sheffield | England | British | Company Director | 127316500001 | ||||||||
BERMINGHAM, Jean | Geschäftsführer | Wadsley Lodge Laird Road S6 4BS Sheffield | British | Company Director | 22459530001 | |||||||||
BERMINGHAM, Joy Marie | Geschäftsführer | 1 Towngate Grove Worrall S35 0BE Sheffield South Yorkshire | British | Company Director | 61310840001 | |||||||||
BERMINGHAM, Thomas | Geschäftsführer | Wadsley Lodge Laird Road S6 4BS Sheffield | British | Civil Engineer | 22459550001 | |||||||||
BOND, Constance Mary | Geschäftsführer | 51 Colley Crescent S5 9FS Sheffield South Yorkshire | British | Company Director | 22459560001 | |||||||||
GAVAN, John Vincent | Geschäftsführer | 23 Fulshaw Avenue SK9 5JE Wilmslow Cheshire | England | British | Solicitor | 36153790001 | ||||||||
GREENBURY, Lee | Geschäftsführer | Sceptre Way Bamber Bridge PR5 6AW Preston Gordon House Lancashire United Kingdom | England | British | Solicitor | 61478920003 | ||||||||
KIRKBY, Neil Robert Ernest | Geschäftsführer | 5 Dashwood Close Grappenhall WA4 3JA Warrington Cheshire | England | British | Finance Director | 51438040006 | ||||||||
MALONEY, John Gerard | Geschäftsführer | 10 Pendle Hill Grimsargh PR2 5BG Preston Lancashire | Irish | Chief Operating Officer | 96964980001 | |||||||||
MCGRORY, Jack | Geschäftsführer | 12 Woodlands Park Scarcroft LS14 3JU Leeds West Yorkshire | United Kingdom | British | Chief Executive Officer | 96596920001 | ||||||||
MCINNES, Randolf Graham | Geschäftsführer | Journeys End Werneth Low SK14 3AF Stockport Cheshire | England | British | Accountant | 100684180001 | ||||||||
MCLAUGHLIN, Owen Gerard | Geschäftsführer | Greyfriars Hall Walker Lane Fulwood PR2 7AN Preston Lancashire | United Kingdom | British | Director | 17129800004 | ||||||||
MCLAUGHLIN, Owen Gerard | Geschäftsführer | Greyfriars Hall Walker Lane Fulwood PR2 7AN Preston Lancashire | United Kingdom | British | Company Director | 17129800004 | ||||||||
NELSON, Andrew Latham | Geschäftsführer | Edmund Halley Road OX4 4DQ Oxford The Sherard Building England | United Kingdom | British | Finance Director | 36191090003 | ||||||||
WOOLGAR, David John Mitchell | Geschäftsführer | The Priory Church Street SY6 6DQ Church Stretton Salop | United Kingdom | British | Chartered Engineer | 71343240001 |
Hat ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 18. Mai 2007 Geliefert am 31. Mai 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor and each grantor of security to the secured parties or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of accession to a composite guarantee and mortgage debenture dated 21 august 2000 | Erstellt am 15. Feb. 2001 Geliefert am 17. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys, obligations and liabilities due or to become due by the obligors or any of them to any of the beneficiaries under or in connection with the financing documents and/or on any other account whatsoever (all terms as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 18. Sept. 1997 Geliefert am 29. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a railway siding alongside elsecar railway station barnsley south yorkshire t/no.SYK233566. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 20. Sept. 1985 Geliefert am 04. Okt. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the south east side of brightside lane, shefield, south yorkshire t/n ywe 48422 and proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 04. Juli 1983 Geliefert am 11. Juli 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof. A fixed & floating charge over goodwill & bookdebts. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Standard security registered at the register of sasines 11/1/78 | Erstellt am 17. Dez. 1977 Geliefert am 20. Jan. 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Dwellinghouse and ground at one hundred and ninty one arran rd. Dumfries. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat ENTERPRISE UTILITY SERVICES (TBC) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0