KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED
Überblick
Unternehmensname | KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01316012 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED?
- Herstellung sonstiger Keramikprodukte n.e.c. (23490) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Lake Road Leeway Industrial Estate NP19 4SR Newport Gwent |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BORIDE CERAMICS & COMPOSITES LIMITED | 13. Feb. 1990 | 13. Feb. 1990 |
R.T.Z. CHEMICALS (BORIDES) LIMITED | 28. Nov. 1988 | 28. Nov. 1988 |
BORAX CONSOLIDATED (BORIDES) LIMITED | 31. Dez. 1978 | 31. Dez. 1978 |
DUMOORYA LIMITED | 02. Juni 1977 | 02. Juni 1977 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 6 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 1 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Dr Thomas Ludwig Lask als Direktor am 29. März 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | SH20 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 24. März 2016
| 4 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Peter Godwin als Sekretär | 1 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Lindley als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Philip Ferraz als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Peter Godwin als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 20 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GODWIN, Andrew Peter | Sekretär | Lake Road Leeway Industrial Estate NP19 4SR Newport Gwent | 162061180001 | |||||||
GODWIN, Andrew Peter | Geschäftsführer | Lake Road Leeway Industrial Estate NP19 4SR Newport Gwent | United Kingdom | British | Accountant | 125696960001 | ||||
LASK, Thomas Ludwig, Dr | Geschäftsführer | Universitatsstrasse Erlangen 91054 36 Germany | Germany | German | Company Secretary | 204144060001 | ||||
WILLIAMS, Mike | Geschäftsführer | Tyn-Y-Wern CF39 8AW Tonyrefail 34 Porth Wales | Wales | British | Company Director | 139990220001 | ||||
BESSANT, Philip Michael | Sekretär | 28 High Cross Road Rogerstone NP10 9AD Newport | British | 28159860001 | ||||||
EGGERT, Rudiger | Sekretär | 380 Western Avenue CF5 2BJ Cardiff South Glamorgan | German | Accountant | 65419500001 | |||||
LINDLEY, Paul John | Sekretär | 28 Fisher Hill Way Radyr CF15 8DR Cardiff South Glamorgan | British | Accountant | 102709950001 | |||||
WOODFIELD, William Mostyn | Sekretär | 7 Cherry Walk NP25 5DE Monmouth Gwent | British | 24043390001 | ||||||
BENCKER, Ulrich Gerhard Christian | Geschäftsführer | Karpfenweg 6 Sulzberg Oschle Bavaria 87477 Germany | German | President Ceo | 123579510001 | |||||
DJOLOLIAN, Claude | Geschäftsführer | 11 Ter Rue Felicien David FOREIGN 78100 Saint Germain En Laye France | French | Director | 28159870001 | |||||
FERRAZ, Philip Brian | Geschäftsführer | Sunnenbergstrasse 8447 Dachsen 39 Switzerland | Switzerland | British | Business Executive | 53650560003 | ||||
GOETZ, Frau Margarete | Geschäftsführer | Romantische Strasse 18 D 87642 Halblech-Buching Germany | German | Company Director | 28159890001 | |||||
GOETZ, Ulrich | Geschäftsführer | Romantische Strasse 18 D 87642 Halblech Buching Germany | German | Company Director | 34064330001 | |||||
HORNUNG, Frank | Geschäftsführer | Badergasse 63739 Aschaffenburg 24 Bavaria Germany | German | Md Of Sintec&Amsg Controller Europe | 133897240001 | |||||
LEES, Norman William Frank | Geschäftsführer | Rookery House The Causeway Mark TA9 4QH Highbridge Somerset | England | British | Director | 8596650001 | ||||
MATTHEWS, John David | Geschäftsführer | 36 Avenue Paul Doumer 75016 Paris France | British | Managing Director | 38382910001 | |||||
RAOUL, Valerie | Geschäftsführer | 17 Rue De La Croix - Nivert 75015 Paris | British | Director | 35151230001 | |||||
ROCHER, Claude Francois | Geschäftsführer | 8 Windsor Way W14 9RL London | British | Accountant | 42948480001 | |||||
SINDLHAUIER, Peter | Geschäftsführer | Hockvogelweg 34 W8961 Probstried Germany | German | Managing Director | 38382860001 |
Hat KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Legal charge | Erstellt am 07. Sept. 2005 Geliefert am 20. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north east side of nash road, newport. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 07. Sept. 2005 Geliefert am 20. Sept. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land and buildings on the north side of lake road, leeway industrial estate, newport. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 13. Aug. 2004 Geliefert am 18. Aug. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 05. März 1996 Geliefert am 09. März 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property at north side lake road leeway industrial estate newport gwent with the beneift of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease, licence or other interest created in respect of the property; and all other payments whatever in respect of the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 20. Nov. 1995 Geliefert am 23. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land & buildings on the north east side of nash road newport gwent t/no WA15778 & WA23321 with the goodwill of the business the benefit of all rights licences guarantees. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed and floating charge | Erstellt am 14. Sept. 1995 Geliefert am 22. Sept. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 14. Sept. 1995 Geliefert am 19. Sept. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land and buildings on the north east side of nash road newport gwent t/n wa 15778. together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 31. März 1992 Geliefert am 11. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £630,000 and any other monies due fron the company to the chargee under the terms of the charge. | |
Kurze Angaben By way of lehgal mortage the property situate at lake road , leeway industrial estate ,newport,gwent. Together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery from time to time thereon. Fixed charge over all the companys propeerty and assets at 31-3-92. floating charge over all the companys proiperty and assets and bank debts and bank deposits from time to time in existance. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0