KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED

KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameKENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01316012
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED?

    • Herstellung sonstiger Keramikprodukte n.e.c. (23490) / Verarbeitendes Gewerbe

    Wo befindet sich KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Lake Road
    Leeway Industrial Estate
    NP19 4SR Newport
    Gwent
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    BORIDE CERAMICS & COMPOSITES LIMITED13. Feb. 199013. Feb. 1990
    R.T.Z. CHEMICALS (BORIDES) LIMITED28. Nov. 198828. Nov. 1988
    BORAX CONSOLIDATED (BORIDES) LIMITED31. Dez. 197831. Dez. 1978
    DUMOORYA LIMITED02. Juni 197702. Juni 1977

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2014

    Welche sind die letzten Einreichungen für KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    6 Seiten4.71

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 Seiten4.70

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 31. März 2016

    LRESSP

    Ernennung von Dr Thomas Ludwig Lask als Direktor am 29. März 2016

    2 SeitenAP01

    legacy

    2 SeitenSH20

    Kapitalaufstellung am 24. März 2016

    • Kapital: GBP 1
    4 SeitenSH19

    legacy

    2 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital19. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 19. Mai 2015

    • Kapital: GBP 2,138,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014

    14 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital30. Mai 2014

    Kapitalaufstellung am 30. Mai 2014

    • Kapital: GBP 2,138,000
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2013

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2012

    13 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2011

    15 SeitenAA

    Ernennung von Mr Andrew Peter Godwin als Sekretär

    1 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Paul Lindley als Sekretär

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Philip Ferraz als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Andrew Peter Godwin als Direktor

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010

    20 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 11. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GODWIN, Andrew Peter
    Lake Road
    Leeway Industrial Estate
    NP19 4SR Newport
    Gwent
    Sekretär
    Lake Road
    Leeway Industrial Estate
    NP19 4SR Newport
    Gwent
    162061180001
    GODWIN, Andrew Peter
    Lake Road
    Leeway Industrial Estate
    NP19 4SR Newport
    Gwent
    Geschäftsführer
    Lake Road
    Leeway Industrial Estate
    NP19 4SR Newport
    Gwent
    United KingdomBritishAccountant125696960001
    LASK, Thomas Ludwig, Dr
    Universitatsstrasse
    Erlangen 91054
    36
    Germany
    Geschäftsführer
    Universitatsstrasse
    Erlangen 91054
    36
    Germany
    GermanyGermanCompany Secretary204144060001
    WILLIAMS, Mike
    Tyn-Y-Wern
    CF39 8AW Tonyrefail
    34
    Porth
    Wales
    Geschäftsführer
    Tyn-Y-Wern
    CF39 8AW Tonyrefail
    34
    Porth
    Wales
    WalesBritishCompany Director139990220001
    BESSANT, Philip Michael
    28 High Cross Road
    Rogerstone
    NP10 9AD Newport
    Sekretär
    28 High Cross Road
    Rogerstone
    NP10 9AD Newport
    British28159860001
    EGGERT, Rudiger
    380 Western Avenue
    CF5 2BJ Cardiff
    South Glamorgan
    Sekretär
    380 Western Avenue
    CF5 2BJ Cardiff
    South Glamorgan
    GermanAccountant65419500001
    LINDLEY, Paul John
    28 Fisher Hill Way
    Radyr
    CF15 8DR Cardiff
    South Glamorgan
    Sekretär
    28 Fisher Hill Way
    Radyr
    CF15 8DR Cardiff
    South Glamorgan
    BritishAccountant102709950001
    WOODFIELD, William Mostyn
    7 Cherry Walk
    NP25 5DE Monmouth
    Gwent
    Sekretär
    7 Cherry Walk
    NP25 5DE Monmouth
    Gwent
    British24043390001
    BENCKER, Ulrich Gerhard Christian
    Karpfenweg 6
    Sulzberg Oschle
    Bavaria 87477
    Germany
    Geschäftsführer
    Karpfenweg 6
    Sulzberg Oschle
    Bavaria 87477
    Germany
    GermanPresident Ceo123579510001
    DJOLOLIAN, Claude
    11 Ter Rue Felicien David
    FOREIGN 78100 Saint Germain En Laye
    France
    Geschäftsführer
    11 Ter Rue Felicien David
    FOREIGN 78100 Saint Germain En Laye
    France
    FrenchDirector28159870001
    FERRAZ, Philip Brian
    Sunnenbergstrasse
    8447 Dachsen
    39
    Switzerland
    Geschäftsführer
    Sunnenbergstrasse
    8447 Dachsen
    39
    Switzerland
    SwitzerlandBritishBusiness Executive53650560003
    GOETZ, Frau Margarete
    Romantische Strasse 18
    D 87642
    Halblech-Buching
    Germany
    Geschäftsführer
    Romantische Strasse 18
    D 87642
    Halblech-Buching
    Germany
    GermanCompany Director28159890001
    GOETZ, Ulrich
    Romantische Strasse 18
    D 87642
    Halblech Buching
    Germany
    Geschäftsführer
    Romantische Strasse 18
    D 87642
    Halblech Buching
    Germany
    GermanCompany Director34064330001
    HORNUNG, Frank
    Badergasse
    63739 Aschaffenburg
    24
    Bavaria
    Germany
    Geschäftsführer
    Badergasse
    63739 Aschaffenburg
    24
    Bavaria
    Germany
    GermanMd Of Sintec&Amsg Controller Europe133897240001
    LEES, Norman William Frank
    Rookery House The Causeway
    Mark
    TA9 4QH Highbridge
    Somerset
    Geschäftsführer
    Rookery House The Causeway
    Mark
    TA9 4QH Highbridge
    Somerset
    EnglandBritishDirector8596650001
    MATTHEWS, John David
    36 Avenue Paul Doumer
    75016 Paris
    France
    Geschäftsführer
    36 Avenue Paul Doumer
    75016 Paris
    France
    BritishManaging Director38382910001
    RAOUL, Valerie
    17 Rue De La Croix - Nivert
    75015
    Paris
    Geschäftsführer
    17 Rue De La Croix - Nivert
    75015
    Paris
    BritishDirector35151230001
    ROCHER, Claude Francois
    8 Windsor Way
    W14 9RL London
    Geschäftsführer
    8 Windsor Way
    W14 9RL London
    BritishAccountant42948480001
    SINDLHAUIER, Peter
    Hockvogelweg 34
    W8961 Probstried
    Germany
    Geschäftsführer
    Hockvogelweg 34
    W8961 Probstried
    Germany
    GermanManaging Director38382860001

    Hat KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 07. Sept. 2005
    Geliefert am 20. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north east side of nash road, newport. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Sept. 2005
    Geliefert am 20. Sept. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north side of lake road, leeway industrial estate, newport. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 20. Sept. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 13. Aug. 2004
    Geliefert am 18. Aug. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Aug. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 05. März 1996
    Geliefert am 09. März 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property at north side lake road leeway industrial estate newport gwent with the beneift of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating to the property; any shares or membership rights in any management company for the property; any goodwill of any business from time to time carried on at the property; any rental and other money payable under any lease, licence or other interest created in respect of the property; and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. März 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 20. Nov. 1995
    Geliefert am 23. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land & buildings on the north east side of nash road newport gwent t/no WA15778 & WA23321 with the goodwill of the business the benefit of all rights licences guarantees. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 14. Sept. 1995
    Geliefert am 22. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Feb. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Sept. 1995
    Geliefert am 19. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a land and buildings on the north east side of nash road newport gwent t/n wa 15778. together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 27. Jan. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 31. März 1992
    Geliefert am 11. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £630,000 and any other monies due fron the company to the chargee under the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    By way of lehgal mortage the property situate at lake road , leeway industrial estate ,newport,gwent. Together with all buildings fixtures and fixed plant and machinery from time to time thereon. Fixed charge over all the companys propeerty and assets at 31-3-92. floating charge over all the companys proiperty and assets and bank debts and bank deposits from time to time in existance.
    Berechtigte Personen
    • Rhone Poulenc Chemicals Limited
    Transaktionen
    • 11. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Sept. 1995Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 19. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat KENNAMETAL SINTEC KERAMIK (UK) LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    31. März 2016Beginn der Liquidation
    24. Aug. 2017Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Karen Lesley Dukes
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0