THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED

THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameTHE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01319819
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Two Snowhill
    Snow Hill
    B4 6GA Birmingham
    West Midlands
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    COMTRANS LIMITED01. Juli 197701. Juli 1977

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    14 SeitenLIQ13

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    5 SeitenLIQ01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Xpo House Lodge Way New Duston Northampton NN5 7SL United Kingdom zum Two Snowhill Snow Hill Birmingham West Midlands B4 6GA am 26. März 2018

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 06. März 2018

    LRESSP

    Beendigung der Bestellung von Georgina Garratt als Sekretär am 28. Feb. 2018

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Ms Georgina Garratt als Direktor am 01. Feb. 2018

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Lyndsay Gillian Navid Lane als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 09. Mai 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    4 SeitenAA

    Ernennung von Ms Georgina Garratt als Sekretär am 20. Feb. 2017

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Lyndsay Navid Lane als Sekretär am 17. Feb. 2017

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von David James Thomas als Geschäftsführer am 04. Nov. 2016

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Simon Gavin Evans als Direktor am 04. Nov. 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital09. Mai 2016

    Kapitalaufstellung am 09. Mai 2016

    • Kapital: GBP 50,000
    SH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Lyndsay Navid Lane am 09. Mai 2016

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    4 SeitenAA

    Ernennung von Mr David James Thomas als Direktor am 30. Nov. 2015

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Patrick Bataillard als Geschäftsführer am 27. Nov. 2015

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Gaultier De La Rochebrochard als Geschäftsführer am 29. Sept. 2015

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Ms Lyndsay Gillian Navid Lane als Direktor am 14. Okt. 2015

    2 SeitenAP01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Norbert Dentressangle House Lodge Way New Duston Northampton Northamptonshire NN5 7SL zum Xpo House Lodge Way New Duston Northampton NN5 7SL am 26. Juni 2015

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital11. Mai 2015

    Kapitalaufstellung am 11. Mai 2015

    • Kapital: GBP 50,000
    SH01

    Wer sind die Geschäftsführer von THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EVANS, Simon Gavin
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    Geschäftsführer
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    United KingdomBritish150758530001
    GARRATT, Georgina
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    Geschäftsführer
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    United KingdomBritish242693040001
    GARRATT, Georgina
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    Sekretär
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    225097100001
    HORNE, Geoffrey Wemyss
    25 Oswald Road
    EH9 2HJ Edinburgh
    Midlothian
    Sekretär
    25 Oswald Road
    EH9 2HJ Edinburgh
    Midlothian
    British66121750001
    LYNCH, David Paul
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    Northamptonshire
    Sekretär
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    Northamptonshire
    British52425370006
    LYNCH, David Paul
    14 Douglas Road
    NN5 6XX Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    14 Douglas Road
    NN5 6XX Northampton
    Northamptonshire
    British52425370002
    MCDONALD, Charles Malcolm
    11 Lennox Row
    EH5 3JP Edinburgh
    Scotland
    Sekretär
    11 Lennox Row
    EH5 3JP Edinburgh
    Scotland
    British42547930001
    NAVID LANE, Lyndsay
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    Sekretär
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    British163252740001
    ROSE, Ian Andrew
    Trehern Close
    Knowle
    B93 9HA Solihull
    3
    West Midlands
    Sekretär
    Trehern Close
    Knowle
    B93 9HA Solihull
    3
    West Midlands
    British128431040001
    ADAM, Ian C
    Gowanfield
    2 Cammo Road
    EH4 8EB Edinburgh
    Geschäftsführer
    Gowanfield
    2 Cammo Road
    EH4 8EB Edinburgh
    ScotlandBritish37076220001
    ASPDEN, Peter Graham
    Sandholme
    Walton Road
    LE17 5RU Kimcote
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Sandholme
    Walton Road
    LE17 5RU Kimcote
    Leicestershire
    EnglandBritish78527750003
    BATAILLARD, Patrick
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    FrenchFrench148397660002
    BRISTOW, David John
    12 Hillside Close
    Heddington
    SN11 0PZ Calne
    Wiltshire
    Geschäftsführer
    12 Hillside Close
    Heddington
    SN11 0PZ Calne
    Wiltshire
    British72470990001
    DE LA ROCHEBROCHARD, Gaultier
    Nd House Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Nobert Dentressangle House
    Northamptonshire
    Gb
    Geschäftsführer
    Nd House Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Nobert Dentressangle House
    Northamptonshire
    Gb
    FranceFrench163237590002
    HORNE, Geoffrey Wemyss
    25 Oswald Road
    EH9 2HJ Edinburgh
    Midlothian
    Geschäftsführer
    25 Oswald Road
    EH9 2HJ Edinburgh
    Midlothian
    ScotlandBritish66121750001
    HOWES, David William
    Old Walls
    Birdingbury Road, Leamington Hasting
    CV23 8EB Rugby
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Old Walls
    Birdingbury Road, Leamington Hasting
    CV23 8EB Rugby
    Warwickshire
    British53711750001
    HUTTON, Timothy Horace
    Highcroft Lodge Farm
    LE17 6NW Husbands Bosworth
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Highcroft Lodge Farm
    LE17 6NW Husbands Bosworth
    Leicestershire
    British50886110001
    LANGLANDS, George Flockhart
    Badachro 5 Highfield Gardens
    WS14 9JA Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    Badachro 5 Highfield Gardens
    WS14 9JA Lichfield
    Staffordshire
    British21371800001
    LAUGERY, Stephane Jacques Andre Philippe
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Norbert Dentressangle House
    Northamptonshire
    FranceFrench126820460002
    LAVELLE, James William
    Meadow Court The Lane
    Grafton Regis
    NN12 7HW Towcester
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Meadow Court The Lane
    Grafton Regis
    NN12 7HW Towcester
    Northamptonshire
    British55957600002
    LYNCH, David Paul
    14 Douglas Road
    NN5 6XX Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    14 Douglas Road
    NN5 6XX Northampton
    Northamptonshire
    British52425370002
    NAVID LANE, Lyndsay Gillian
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    EnglandBritish177674310001
    PEPPIATT, Edward Hugh Davidson
    Church Farm
    Oxendon Road, Arthingworth
    LE16 8LA Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Church Farm
    Oxendon Road, Arthingworth
    LE16 8LA Market Harborough
    Leicestershire
    British83323550001
    RUSCH, Henry
    Victoria House
    161 Station Road
    LE9 7GF Earl Shilton
    Leicestershire
    England
    Geschäftsführer
    Victoria House
    161 Station Road
    LE9 7GF Earl Shilton
    Leicestershire
    England
    British63973770001
    THOMAS, David James
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    United Kingdom
    EnglandBritish147800590002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    06. Apr. 2016
    Lodge Way
    New Duston
    NN5 7SL Northampton
    Xpo House
    England
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer2832085
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Single debenture
    Erstellt am 24. Apr. 1991
    Geliefert am 30. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 15. Apr. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge over credit balance
    Erstellt am 16. Apr. 1991
    Geliefert am 24. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a rent guarantee dated 13/5/89 for £108070 given to legal and general and in relation to a kent guarantee dated 19/1/90 for £246.000 given to lazard property unit trust
    Kurze Angaben
    The sum of £354,070 on an account numbered 7477813.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 27. Juli 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Credit agreement entitted "prompt credit application"
    Erstellt am 06. Nov. 1990
    Geliefert am 13. Nov. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £197669-35 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement
    Kurze Angaben
    All right title and interest of the company in and to all sums payable under the insurances particulars of which are set out on the reverse of the form 395, see doc for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 13. Nov. 1990Registrierung einer Belastung
    • 10. Apr. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 15. Mai 1989
    Geliefert am 02. Juni 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A charge by way of legal mortgage over freehold land k/a land at amberley way west side of gren lane heston title no. Ngl 460967 and/or the proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Juni 1989Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 10. Feb. 1989
    Geliefert am 18. Feb. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that l/h land k/a unit 6, block c, winneral tnangle wokingham, berkshire.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 18. Feb. 1989Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 24. Feb. 1985
    Geliefert am 14. März 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H - land at cutbush close, earley, leading, berks & land on the south east side of cutbush lane, ealey, reading, berks,. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. März 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 01. Juli 1983
    Geliefert am 05. Juli 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a land at amberley way, west side of green lane, heston, london borough of hounslow, (formerly park tn: mx 316152). together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Juli 1983Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 27. Apr. 1983
    Geliefert am 29. Apr. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Apr. 1983Registrierung einer Belastung

    Hat THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    06. März 2018Beginn der Liquidation
    05. Apr. 2019Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Edward Terence Kerr
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Praktiker
    Two Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GA Birmingham
    Malcolm Cohen
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London
    Praktiker
    Bdo Llp 55 Baker Street
    W1U 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0