THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01319819 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Two Snowhill Snow Hill B4 6GA Birmingham West Midlands |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| COMTRANS LIMITED | 01. Juli 1977 | 01. Juli 1977 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 14 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Xpo House Lodge Way New Duston Northampton NN5 7SL United Kingdom zum Two Snowhill Snow Hill Birmingham West Midlands B4 6GA am 26. März 2018 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Georgina Garratt als Sekretär am 28. Feb. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Ms Georgina Garratt als Direktor am 01. Feb. 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lyndsay Gillian Navid Lane als Geschäftsführer am 31. Jan. 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 09. Mai 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Ms Georgina Garratt als Sekretär am 20. Feb. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lyndsay Navid Lane als Sekretär am 17. Feb. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David James Thomas als Geschäftsführer am 04. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Gavin Evans als Direktor am 04. Nov. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Lyndsay Navid Lane am 09. Mai 2016 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr David James Thomas als Direktor am 30. Nov. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patrick Bataillard als Geschäftsführer am 27. Nov. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Gaultier De La Rochebrochard als Geschäftsführer am 29. Sept. 2015 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Ms Lyndsay Gillian Navid Lane als Direktor am 14. Okt. 2015 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Norbert Dentressangle House Lodge Way New Duston Northampton Northamptonshire NN5 7SL zum Xpo House Lodge Way New Duston Northampton NN5 7SL am 26. Juni 2015 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 09. Mai 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EVANS, Simon Gavin | Geschäftsführer | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | United Kingdom | British | 150758530001 | |||||
| GARRATT, Georgina | Geschäftsführer | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | United Kingdom | British | 242693040001 | |||||
| GARRATT, Georgina | Sekretär | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | 225097100001 | |||||||
| HORNE, Geoffrey Wemyss | Sekretär | 25 Oswald Road EH9 2HJ Edinburgh Midlothian | British | 66121750001 | ||||||
| LYNCH, David Paul | Sekretär | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire | British | 52425370006 | ||||||
| LYNCH, David Paul | Sekretär | 14 Douglas Road NN5 6XX Northampton Northamptonshire | British | 52425370002 | ||||||
| MCDONALD, Charles Malcolm | Sekretär | 11 Lennox Row EH5 3JP Edinburgh Scotland | British | 42547930001 | ||||||
| NAVID LANE, Lyndsay | Sekretär | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House United Kingdom | British | 163252740001 | ||||||
| ROSE, Ian Andrew | Sekretär | Trehern Close Knowle B93 9HA Solihull 3 West Midlands | British | 128431040001 | ||||||
| ADAM, Ian C | Geschäftsführer | Gowanfield 2 Cammo Road EH4 8EB Edinburgh | Scotland | British | 37076220001 | |||||
| ASPDEN, Peter Graham | Geschäftsführer | Sandholme Walton Road LE17 5RU Kimcote Leicestershire | England | British | 78527750003 | |||||
| BATAILLARD, Patrick | Geschäftsführer | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House United Kingdom | French | French | 148397660002 | |||||
| BRISTOW, David John | Geschäftsführer | 12 Hillside Close Heddington SN11 0PZ Calne Wiltshire | British | 72470990001 | ||||||
| DE LA ROCHEBROCHARD, Gaultier | Geschäftsführer | Nd House Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Nobert Dentressangle House Northamptonshire Gb | France | French | 163237590002 | |||||
| HORNE, Geoffrey Wemyss | Geschäftsführer | 25 Oswald Road EH9 2HJ Edinburgh Midlothian | Scotland | British | 66121750001 | |||||
| HOWES, David William | Geschäftsführer | Old Walls Birdingbury Road, Leamington Hasting CV23 8EB Rugby Warwickshire | British | 53711750001 | ||||||
| HUTTON, Timothy Horace | Geschäftsführer | Highcroft Lodge Farm LE17 6NW Husbands Bosworth Leicestershire | British | 50886110001 | ||||||
| LANGLANDS, George Flockhart | Geschäftsführer | Badachro 5 Highfield Gardens WS14 9JA Lichfield Staffordshire | British | 21371800001 | ||||||
| LAUGERY, Stephane Jacques Andre Philippe | Geschäftsführer | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Norbert Dentressangle House Northamptonshire | France | French | 126820460002 | |||||
| LAVELLE, James William | Geschäftsführer | Meadow Court The Lane Grafton Regis NN12 7HW Towcester Northamptonshire | British | 55957600002 | ||||||
| LYNCH, David Paul | Geschäftsführer | 14 Douglas Road NN5 6XX Northampton Northamptonshire | British | 52425370002 | ||||||
| NAVID LANE, Lyndsay Gillian | Geschäftsführer | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House United Kingdom | England | British | 177674310001 | |||||
| PEPPIATT, Edward Hugh Davidson | Geschäftsführer | Church Farm Oxendon Road, Arthingworth LE16 8LA Market Harborough Leicestershire | British | 83323550001 | ||||||
| RUSCH, Henry | Geschäftsführer | Victoria House 161 Station Road LE9 7GF Earl Shilton Leicestershire England | British | 63973770001 | ||||||
| THOMAS, David James | Geschäftsführer | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House United Kingdom | England | British | 147800590002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Xpo Holdings Uk And Ireland Limited | 06. Apr. 2016 | Lodge Way New Duston NN5 7SL Northampton Xpo House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Single debenture | Erstellt am 24. Apr. 1991 Geliefert am 30. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over credit balance | Erstellt am 16. Apr. 1991 Geliefert am 24. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee in relation to a rent guarantee dated 13/5/89 for £108070 given to legal and general and in relation to a kent guarantee dated 19/1/90 for £246.000 given to lazard property unit trust | |
Kurze Angaben The sum of £354,070 on an account numbered 7477813. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Credit agreement entitted "prompt credit application" | Erstellt am 06. Nov. 1990 Geliefert am 13. Nov. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £197669-35 due from the company to the chargee pursuant to the terms of the agreement | |
Kurze Angaben All right title and interest of the company in and to all sums payable under the insurances particulars of which are set out on the reverse of the form 395, see doc for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 15. Mai 1989 Geliefert am 02. Juni 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A charge by way of legal mortgage over freehold land k/a land at amberley way west side of gren lane heston title no. Ngl 460967 and/or the proceeds of sale thereof.. A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Feb. 1989 Geliefert am 18. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that l/h land k/a unit 6, block c, winneral tnangle wokingham, berkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 24. Feb. 1985 Geliefert am 14. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H - land at cutbush close, earley, leading, berks & land on the south east side of cutbush lane, ealey, reading, berks,. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Juli 1983 Geliefert am 05. Juli 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land k/a land at amberley way, west side of green lane, heston, london borough of hounslow, (formerly park tn: mx 316152). together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 27. Apr. 1983 Geliefert am 29. Apr. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat THE NATURAL VEGETABLE COMPANY LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0