HONEYSUCKLE FASHIONS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HONEYSUCKLE FASHIONS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01320820 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HONEYSUCKLE FASHIONS LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich HONEYSUCKLE FASHIONS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Unit 2 Longwood Road Brookhill Industrial Estate NG16 6NT Pinxton Nottinghamshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HONEYSUCKLE FASHIONS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ROBERT ASHLEY INVESTMENTS LIMITED | 08. Juli 1977 | 08. Juli 1977 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HONEYSUCKLE FASHIONS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HONEYSUCKLE FASHIONS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Das freiwillige Löschungsverfahren wurde ausgesetzt. | 1 Seiten | SOAS(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jason John Melrose am 05. Dez. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Mr Jason John Melrose am 05. Dez. 2011 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Alexander Campbell Anderson am 05. Dez. 2011 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Dez. 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 287 | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 7 Seiten | 363s | ||||||||||
Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2005 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Verschiedenes 225 -orig was not rej by stem | 1 Seiten | MISC | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HONEYSUCKLE FASHIONS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MELROSE, Jason John | Sekretär | Longwood Road Brookhill Industrial Estate NG16 6NT Pinxton Unit 2 Nottinghamshire | British | 59908760001 | ||||||
| ANDERSON, Alexander Campbell | Geschäftsführer | Longwood Road Brookhill Industrial Estate NG16 6NT Pinxton Unit 2 Nottinghamshire | England | British | 43710680002 | |||||
| MELROSE, Jason John | Geschäftsführer | Longwood Road Brookhill Industrial Estate NG16 6NT Pinxton Unit 2 Nottinghamshire | United Kingdom | British | 59908760001 | |||||
| BHULLAR, Ujjal Simon | Sekretär | The Gables 1 Wigton Chase Alwoodley LS17 8SG Leeds West Yorkshire | British | 24910480002 | ||||||
| DAY, Phillip | Sekretär | 1 Stonegate BD16 4SA Bingley West Yorkshire | British | 51649600002 | ||||||
| INGRAM, David Colin | Sekretär | Bridleways Woodcote Green Road KT18 7DN Epsom Surrey | British | 109149390001 | ||||||
| MOULSDALE, Nicholas Geoffrey | Sekretär | Ivy Cottage Castley Lane Castley LS21 2PY Otley North Yorkshire | British | 7378970001 | ||||||
| SERR, Linda Barbara | Sekretär | Elm Lodge 39 Circus Road St Johns Wood NW8 9JG London | British | 42474660001 | ||||||
| BHULLAR, Ajmair Singh | Geschäftsführer | 7 Wigton Chase Alwoodley LS17 8SG Leeds West Yorkshire | British | 74064740001 | ||||||
| DAY, Phillip | Geschäftsführer | 1 Stonegate BD16 4SA Bingley West Yorkshire | British | 51649600002 | ||||||
| GRAY, Geoffrey Malcolm | Geschäftsführer | 172 Alwoodley Lane LS17 7PF Leeds West Yorkshire | British | 7378990001 | ||||||
| HAMER, Jeremy John | Geschäftsführer | Great Down Farm Marnhull DT10 1JY Sturminster Newton Dorset | England | British | 10425110003 | |||||
| HARGREAVES, Peter Michael | Geschäftsführer | Wellstone 22 Main Street Ledston WF10 2AA Castleford West Yorkshire | British | 70475750001 | ||||||
| INGRAM, David Colin | Geschäftsführer | Bridleways Woodcote Green Road KT18 7DN Epsom Surrey | British | 109149390001 | ||||||
| KALETA, Richard | Geschäftsführer | 54 Old Hatch Lane Old Basing RG24 7EB Basingstoke Hampshire | British | 52201380002 | ||||||
| MOULSDALE, Nicholas Geoffrey | Geschäftsführer | Ivy Cottage Castley Lane Castley LS21 2PY Otley North Yorkshire | United Kingdom | British | 7378970001 | |||||
| SERR, David Selwyn, Mr. | Geschäftsführer | Dunkeswick House Weeton Lane LS17 9LP Dunkeswick North Yorkshire | England | English | 3686160011 | |||||
| SERR, Linda Barbara | Geschäftsführer | Elm Lodge 39 Circus Road St Johns Wood NW8 9JG London | British | 42474660001 |
Hat HONEYSUCKLE FASHIONS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 12. Okt. 1999 Geliefert am 20. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Rights and security letter from alexander anderson (the chargee) to honeysuckle group PLC and honeysuckle fashions limited | Erstellt am 09. Apr. 1998 Geliefert am 23. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag (I) the assigned debt (as defined); (ii) any and all future borrowings by honeysuckle group PLC and honeysuckle fashions limited from the chargee; (iii) all honeysuckle group PLC and honeysuckle fashions limited money obligations and liabilities (including fees payable to the chargee) under the new facility letter (as defined) | |
Kurze Angaben From the effective date (as defined) the facility letter (as defined) and the assigned security documents (as defined) shall be amended and be read and construed such that the chargee and any successors in title from time to time shall take the place of national westminster bank PLC (nat west). Accordingly without limitation the benefit of nat west's right title and interest in and under the assigned debt and the assigned security (as defined) shall accrue to the chargee. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed (supplemental to and amending the provisions of a mortgage debenture dated 25TH may 1995) | Erstellt am 09. Apr. 1998 Geliefert am 23. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to alexander anderson under or pursuant to the anderson facility letter and all monies due to national westminster bank PLC under the natwest facility letter up to a maximum aggregate amount of £300,000, the assigned debt and the obligations of the company under the guarantee | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 09. Apr. 1998 Geliefert am 22. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Account number 43997633. the charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 11. Apr. 1996 Geliefert am 18. Apr. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents. Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 25. Mai 1995 Geliefert am 05. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 06. Aug. 1990 Geliefert am 07. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 15 leylands road leeds w yorkshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 06. Aug. 1990 Geliefert am 07. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Basement & ground floor 19 margaret street london W1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 06. Aug. 1990 Geliefert am 07. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben First floor 19 margaret street london W1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 06. Aug. 1990 Geliefert am 07. Aug. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Basement & ground floor 21 little portland london W1. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Aug. 1985 Geliefert am 15. Aug. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Floating security on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & book debts uncalled capital. (Please see doc M13 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 05. Aug. 1983 Geliefert am 13. Aug. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0