HARGREAVES VENDING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHARGREAVES VENDING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01322308
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HARGREAVES VENDING LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich HARGREAVES VENDING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Mccoll's House
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Essex
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HARGREAVES VENDING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis27. Nov. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für HARGREAVES VENDING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Beendigung der Bestellung von Bernadette Clare Young als Sekretär am 07. Sept. 2018

    1 SeitenTM02

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2018 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Nov. 2016

    4 SeitenAA

    Ernennung von Mr Steven Green als Direktor am 22. Aug. 2017

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Bernadette Clare Young als Sekretär am 22. Aug. 2017

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Simon Jonathan Miller als Sekretär am 22. Aug. 2017

    1 SeitenTM02

    Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2017 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Nov. 2015

    4 SeitenAA

    Ernennung von Mr Simon Jeremy Ian Fuller als Direktor am 26. Apr. 2016

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von James Lancaster als Geschäftsführer am 26. Apr. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital07. Apr. 2016

    Kapitalaufstellung am 07. Apr. 2016

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2014

    10 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Kingsley John Tedder als Sekretär am 12. Aug. 2015

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital31. März 2015

    Kapitalaufstellung am 31. März 2015

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Nov. 2013

    4 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Martyn James Aguss als Geschäftsführer am 30. Juli 2014

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital12. Juni 2014

    Kapitalaufstellung am 12. Juni 2014

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Martin Mccoll House Ashwells Road Pilgrims Hatch Brentwood Essex CM15 9ST* am 21. Jan. 2014

    1 SeitenAD01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Nov. 2012

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Nov. 2011

    4 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01

    Wer sind die Geschäftsführer von HARGREAVES VENDING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FULLER, Simon Jeremy Ian
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Geschäftsführer
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritish181763320001
    GREEN, Steven
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Geschäftsführer
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    EnglandBritish209349290001
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Geschäftsführer
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritish88269280005
    BARNES, Christopher Howard
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    Sekretär
    11 Hepplewhite Close
    Baughurst
    RG26 5HD Basingstoke
    Hampshire
    British25597650001
    MILLER, Simon Jonathan
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Sekretär
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    British88269280005
    SNEYD, Ian Nicholas
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    Sekretär
    Oakleigh Swan Lane
    Marlpit Hill
    TN8 6BA Edenbridge
    Kent
    British31342250001
    TEDDER, Kingsley John
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Sekretär
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    British101631010002
    YOUNG, Bernadette Clare
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    Sekretär
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    237612690001
    AGUSS, Martyn James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Geschäftsführer
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritish107991420002
    COX, Allister Russell
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    Geschäftsführer
    The Small House Mynthurst
    Leigh
    RH2 8RJ Reigate
    Surrey
    EnglandBritish31500810002
    FOSTER, Brian
    24 Palm Street
    Droylsden
    M43 6WJ Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    24 Palm Street
    Droylsden
    M43 6WJ Manchester
    Lancashire
    British24323870001
    LANCASTER, James
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    Geschäftsführer
    Ashwells Road
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    Essex
    England
    EnglandBritish147052660001
    MCFARLANE, Ian Douglas
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    Geschäftsführer
    Shirenewton
    NP16 6RL Chepstow
    The Cayo
    Gwent
    British130747750001
    POPE, Philip
    23 Croftacres
    Edenfield Ramsbottom
    BL0 0LX Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    23 Croftacres
    Edenfield Ramsbottom
    BL0 0LX Bury
    Lancashire
    United KingdomBritish52431400001
    WILKINSON, Stephen William
    Martin Mccoll House
    Ashwells Road
    CM15 9ST Pilgrims Hatch Brentwood
    Essex
    Geschäftsführer
    Martin Mccoll House
    Ashwells Road
    CM15 9ST Pilgrims Hatch Brentwood
    Essex
    United KingdomBritish101631100002

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HARGREAVES VENDING LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    England
    06. Apr. 2016
    Ashwells Road
    Pilgrims Hatch
    CM15 9ST Brentwood
    Mccoll's House
    England
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageEngland
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer03462566
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.

    Hat HARGREAVES VENDING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 28. Nov. 1998
    Geliefert am 08. Dez. 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Dez. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 14. Juni 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 24. Juli 1995
    Geliefert am 31. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 31. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Mai 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Juli 1984
    Geliefert am 01. Aug. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that f/h land with the buildings erected thereon situate at and known as 146 manchester road droylsden, tameside, greater manchester.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Aug. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 04. Aug. 1983
    Geliefert am 13. Aug. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land on the north side of manchester road, droylsden, tameside, greater manchester title no. La 316784 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1983Registrierung einer Belastung
    • 01. Apr. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 04. Aug. 1983
    Geliefert am 13. Aug. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold land and buildings on the south side of manor road, droylsden tameside, greater manchester. Title no p 178345 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Aug. 1983Registrierung einer Belastung
    • 01. Apr. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed supplemental to a debenture
    Erstellt am 17. Aug. 1981
    Geliefert am 21. Aug. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 23.10.79
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all bookdebts & other debts of the company both present & future.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transaktionen
    • 21. Aug. 1981Registrierung einer Belastung
    • 01. Apr. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Juli 1981
    Geliefert am 16. Juli 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land situate on the east side of hemmons road now known as unit 1 longden road longsight. Manchester greater manchester title no: gm 229537 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with plant machinery fixtures implements and utensils. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank Limited
    Transaktionen
    • 16. Juli 1981Registrierung einer Belastung
    • 20. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 23. Okt. 1979
    Geliefert am 01. Nov. 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge - undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. All fixtures, fittings fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyn's Bank Limited.
    Transaktionen
    • 01. Nov. 1979Registrierung einer Belastung
    • 01. Apr. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Mai 1979
    Geliefert am 21. Mai 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H known as 35 longshut lane west stockport greater manchester title number ch 70634 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with plant machinery fixtures implements and utensils.
    Berechtigte Personen
    • Williams & Glyns Bank Limited
    Transaktionen
    • 21. Mai 1979Registrierung einer Belastung
    • 20. Juli 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0