HARGREAVES VENDING LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HARGREAVES VENDING LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01322308 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HARGREAVES VENDING LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich HARGREAVES VENDING LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Mccoll's House Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Essex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HARGREAVES VENDING LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 27. Nov. 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HARGREAVES VENDING LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Bernadette Clare Young als Sekretär am 07. Sept. 2018 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Nov. 2016 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Steven Green als Direktor am 22. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Bernadette Clare Young als Sekretär am 22. Aug. 2017 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Jonathan Miller als Sekretär am 22. Aug. 2017 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 29. Nov. 2015 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Simon Jeremy Ian Fuller als Direktor am 26. Apr. 2016 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Lancaster als Geschäftsführer am 26. Apr. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Nov. 2014 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kingsley John Tedder als Sekretär am 12. Aug. 2015 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Nov. 2013 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Martyn James Aguss als Geschäftsführer am 30. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Martin Mccoll House Ashwells Road Pilgrims Hatch Brentwood Essex CM15 9ST* am 21. Jan. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 25. Nov. 2012 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 27. Nov. 2011 | 4 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HARGREAVES VENDING LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FULLER, Simon Jeremy Ian | Geschäftsführer | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | England | British | 181763320001 | |||||
| GREEN, Steven | Geschäftsführer | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | England | British | 209349290001 | |||||
| MILLER, Simon Jonathan | Geschäftsführer | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | England | British | 88269280005 | |||||
| BARNES, Christopher Howard | Sekretär | 11 Hepplewhite Close Baughurst RG26 5HD Basingstoke Hampshire | British | 25597650001 | ||||||
| MILLER, Simon Jonathan | Sekretär | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | British | 88269280005 | ||||||
| SNEYD, Ian Nicholas | Sekretär | Oakleigh Swan Lane Marlpit Hill TN8 6BA Edenbridge Kent | British | 31342250001 | ||||||
| TEDDER, Kingsley John | Sekretär | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | British | 101631010002 | ||||||
| YOUNG, Bernadette Clare | Sekretär | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex | 237612690001 | |||||||
| AGUSS, Martyn James | Geschäftsführer | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | England | British | 107991420002 | |||||
| COX, Allister Russell | Geschäftsführer | The Small House Mynthurst Leigh RH2 8RJ Reigate Surrey | England | British | 31500810002 | |||||
| FOSTER, Brian | Geschäftsführer | 24 Palm Street Droylsden M43 6WJ Manchester Lancashire | British | 24323870001 | ||||||
| LANCASTER, James | Geschäftsführer | Ashwells Road CM15 9ST Brentwood Mccoll's House Essex England | England | British | 147052660001 | |||||
| MCFARLANE, Ian Douglas | Geschäftsführer | Shirenewton NP16 6RL Chepstow The Cayo Gwent | British | 130747750001 | ||||||
| POPE, Philip | Geschäftsführer | 23 Croftacres Edenfield Ramsbottom BL0 0LX Bury Lancashire | United Kingdom | British | 52431400001 | |||||
| WILKINSON, Stephen William | Geschäftsführer | Martin Mccoll House Ashwells Road CM15 9ST Pilgrims Hatch Brentwood Essex | United Kingdom | British | 101631100002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei HARGREAVES VENDING LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tm Group Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Ashwells Road Pilgrims Hatch CM15 9ST Brentwood Mccoll's House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat HARGREAVES VENDING LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 28. Nov. 1998 Geliefert am 08. Dez. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from company to the chargee (as agent and trustee for the secured parties (as therein defined) pursuant to the terms of a credit agreement (as therein defined)) under or pursuant to any of the financing documents (as therein defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 24. Juli 1995 Geliefert am 31. Juli 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee as agent and trustee for the secured parties and to any of the secured parties (as defined) under or pursuant to the financing documents (as defined) including this guarantee and debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 26. Juli 1984 Geliefert am 01. Aug. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All that f/h land with the buildings erected thereon situate at and known as 146 manchester road droylsden, tameside, greater manchester.. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. Together with all buildings and erections thereon and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Aug. 1983 Geliefert am 13. Aug. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land on the north side of manchester road, droylsden, tameside, greater manchester title no. La 316784 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 04. Aug. 1983 Geliefert am 13. Aug. 1983 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold land and buildings on the south side of manor road, droylsden tameside, greater manchester. Title no p 178345 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed supplemental to a debenture | Erstellt am 17. Aug. 1981 Geliefert am 21. Aug. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a debenture dated 23.10.79 | |
Kurze Angaben Fixed charge on all bookdebts & other debts of the company both present & future. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 10. Juli 1981 Geliefert am 16. Juli 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land situate on the east side of hemmons road now known as unit 1 longden road longsight. Manchester greater manchester title no: gm 229537 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with plant machinery fixtures implements and utensils. Together with fixed and moveable plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 23. Okt. 1979 Geliefert am 01. Nov. 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge - undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. All fixtures, fittings fixed plant & machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Mai 1979 Geliefert am 21. Mai 1979 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H known as 35 longshut lane west stockport greater manchester title number ch 70634 together with all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878. together with plant machinery fixtures implements and utensils. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0