EURO PACKAGING LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameEURO PACKAGING LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01328600
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von EURO PACKAGING LIMITED?

    • (2121) /
    • (2524) /
    • (5156) /

    Wo befindet sich EURO PACKAGING LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    c/o KPMG LLP
    One Snowhill
    Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von EURO PACKAGING LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EURO PACKAGING PLC15. Sept. 198215. Sept. 1982
    MAJID (DISTRIBUTOR) LIMITED05. Sept. 197705. Sept. 1977

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von EURO PACKAGING LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2007

    Welche sind die letzten Einreichungen für EURO PACKAGING LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 15. Aug. 2012

    18 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 15. Aug. 2012

    18 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. März 2012

    14 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. Sept. 2011

    14 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. März 2011

    16 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. Sept. 2010

    17 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    3 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. März 2010

    14 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 03. März 2010

    1 Seiten2.24B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Kpmg Llp 2 Cornwall Street Birmingham B3 2DL am 22. Dez. 2009

    1 SeitenAD01

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    10 Seiten2.16B

    Vorschlag des Verwalters

    29 Seiten2.17B

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    11 Seiten395

    legacy

    8 Seiten395

    legacy

    5 Seiten395

    Wer sind die Geschäftsführer von EURO PACKAGING LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GILL, Harjainder
    Oaken Lodge
    Oaken Lanes
    WV8 2AH Codsall
    West Midlands
    Sekretär
    Oaken Lodge
    Oaken Lanes
    WV8 2AH Codsall
    West Midlands
    British151578950001
    AUDAS, Robert Graham
    Cherry Blossom
    29 Upton Lane
    CH2 1EB Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Cherry Blossom
    29 Upton Lane
    CH2 1EB Chester
    Cheshire
    EnglandBritish103678030001
    KORAL, Gregory David
    39 St Bernards Road
    B92 7AX Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    39 St Bernards Road
    B92 7AX Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish108145070001
    ALIMAHOMED, Afzal Majid
    51a Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    51a Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    British1188400002
    NAWAB, Rafik Ahmed
    88 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3HN Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    88 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3HN Birmingham
    West Midlands
    British1188390001
    AHMED, Qadir
    98 Danford Lane
    B91 1QR Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    98 Danford Lane
    B91 1QR Solihull
    West Midlands
    British52847280001
    ALIMAHOMED, Abdul Majid
    The Paddocks 51 Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    The Paddocks 51 Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    British7213370001
    ALIMAHOMED, Afzal Majid
    51a Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    51a Church Road
    Edgbaston
    B15 3SJ Birmingham
    West Midlands
    United Arab EmiratesBritish1188400002
    BALDREY, Philip Nigel
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    34 Saint Bernards Road
    B92 7BB Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish44039650003
    BALOGH, Attila
    3 Cypress Gardens
    Four Oaks Park
    B74 2HD Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    3 Cypress Gardens
    Four Oaks Park
    B74 2HD Sutton Coldfield
    West Midlands
    United KingdomAmerican117533860002
    BOOT, Richard John
    Churchill Grange Waggon Lane
    Churchill
    DY10 3LZ Kidderminster
    Worcestershire
    Geschäftsführer
    Churchill Grange Waggon Lane
    Churchill
    DY10 3LZ Kidderminster
    Worcestershire
    United KingdomBritish91900570001
    DICKINSON, Adam
    19 Francis Road
    WS13 7JX Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    19 Francis Road
    WS13 7JX Lichfield
    Staffordshire
    British97300740001
    ELLISON, Bridget Jayne
    16 Dale View
    PR7 3QJ Chorley
    Lancashire
    Geschäftsführer
    16 Dale View
    PR7 3QJ Chorley
    Lancashire
    EnglandBritish32319380002
    GILL, Harjainder
    Oaken Lodge
    Oaken Lanes
    WV8 2AH Codsall
    West Midlands
    Geschäftsführer
    Oaken Lodge
    Oaken Lanes
    WV8 2AH Codsall
    West Midlands
    United KingdomBritish151578950001
    MAJID, Shabir
    22 Westbourne Road
    B15 3TX Edgbaston
    Birmingham
    Geschäftsführer
    22 Westbourne Road
    B15 3TX Edgbaston
    Birmingham
    United Arab EmiratesBritish67515050003
    MONAGHAN, Mark
    39 St James Place 34 George Road
    Edgbaston
    B15 1PQ Birmingham
    Geschäftsführer
    39 St James Place 34 George Road
    Edgbaston
    B15 1PQ Birmingham
    British120881120003
    NAWAB, Rafik Ahmed
    88 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3HN Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    88 Harborne Road
    Edgbaston
    B15 3HN Birmingham
    West Midlands
    British1188390001
    ROBSON, Anthony Gerald
    56 Frederick Road
    B73 5QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    Geschäftsführer
    56 Frederick Road
    B73 5QN Sutton Coldfield
    West Midlands
    British52847230002
    SHAFI, Javaid
    36 Arthog Road
    Hale, Altrincham, Cheshire
    WA15 0LU Altrincham
    Geschäftsführer
    36 Arthog Road
    Hale, Altrincham, Cheshire
    WA15 0LU Altrincham
    EnglandBritish80996800001
    WINDLE, Paul Stephen
    203 Bagnall Road
    NG6 8SJ Nottingham
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    203 Bagnall Road
    NG6 8SJ Nottingham
    Nottinghamshire
    EnglandBritish117533470001

    Hat EURO PACKAGING LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charges on non-vesting debts
    Erstellt am 25. Juli 2008
    Geliefert am 09. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coface Receivables Finance Limited (The "Security Holder")
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    All assets debenture
    Erstellt am 25. Juli 2008
    Geliefert am 09. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Coface Receivables Finance Limited (The "Security Holder")
    Transaktionen
    • 09. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Charge over cash deposit
    Erstellt am 25. Juli 2008
    Geliefert am 08. Aug. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    By way of first fixed charge the deposit, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Aug. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Security accession deed
    Erstellt am 07. Dez. 2006
    Geliefert am 15. Dez. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any charging company or any other obligor to any secured party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC as Security Trustee for Itself and the Other Secured Parties (Thesecurity Agent)
    Transaktionen
    • 15. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Security over cash deposits
    Erstellt am 26. Jan. 2004
    Geliefert am 30. Jan. 2004
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the company's rights to and interest in all of the amounts from time to time credited to all the company's accounts, all interest and other benefits arising in connection with those amounts.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Jan. 2004Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 31. Juli 2001
    Geliefert am 31. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All and singular the chattels plant machinery and things described in the schedule hereto or any part thereof. 1999 nissan forklift s/no 700759. 1999 nissan forklift s/no 700760. jungheinrich lpg fork lift trusck s/no A810B02694S. For further details of chattels charged please refer to form 395.. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Asset Finance (UK) Limited and Hsbc Equipment Finance (UK) Limited
    Transaktionen
    • 31. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Dez. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 31. Mai 2000
    Geliefert am 06. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Juli 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Juli 1995
    Geliefert am 29. Juli 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bangkok Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Juli 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 09. Dez. 1994
    Geliefert am 09. Dez. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    One new triumph I sos bag making machine serial no QMS9921746/S127111957.
    Berechtigte Personen
    • Forward Trust Limited
    Transaktionen
    • 09. Dez. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    General letter of pledge and charge
    Erstellt am 06. Juli 1994
    Geliefert am 14. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All goods bills of lading docks and warehouse warrants other documents of title to or relating to goods policies of insurance and securities which shall from time totime be deposited by the company with the chargee or its agent. All property and other rights all proceeds of sale.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Dallah Albaraka Investment Company Limited
    Transaktionen
    • 14. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    General letter of pledge and charge
    Erstellt am 10. Aug. 1993
    Geliefert am 18. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Such bills of lading and other documents of title to goods. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bangkok Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Credit agreement
    Erstellt am 18. Apr. 1993
    Geliefert am 22. Apr. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £18,980.88 due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest in and to all sums payable under the insurance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Juli 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Credit agreement
    Erstellt am 16. März 1993
    Geliefert am 19. März 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £57,089.11 due from the company to the chagee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    All right title interest in and to all sums payable under the insurance ( see 395 for full details ).
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 19. März 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Aug. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Credit agreement
    Erstellt am 28. Jan. 1992
    Geliefert am 13. Feb. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £25681.80
    Kurze Angaben
    All the right title and interest in and to all sums payable (including by way of refund) under the insurance, particulars whereof are set out in full in the form 395. (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Close Brothers Limited
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Juni 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Assignation in security dated 16/3/90 and intimated by a letter dated 24/10/90
    Erstellt am 24. Okt. 1990
    Geliefert am 25. Okt. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or clyde polythene limited to the chargee.
    Kurze Angaben
    All sums due and to become due to the company by clyde polythene limited in respect of a loan for £225,000.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. Okt. 1990Registrierung einer Belastung
    • 02. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    General letter of hypothecation
    Erstellt am 29. Aug. 1989
    Geliefert am 01. Sept. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All goods bills of lading dock and warehouse warrants (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Albaraka International Bank Limited
    Transaktionen
    • 01. Sept. 1989Registrierung einer Belastung
    • 02. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 20. Okt. 1987
    Geliefert am 02. Nov. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Automotive engineering work shops situate at highgate road spark brook birmingham west midlands wm 330104.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Nov. 1987Registrierung einer Belastung
    • 02. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 17. Juli 1987
    Geliefert am 24. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    • 02. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. Sept. 1983
    Geliefert am 30. Sept. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Specific equitable charge over all f/h & l/h properties and/or the proceeds of the sale thereof. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future excluding goodwill bookdebts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Sept. 1983Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 18. März 1983
    Geliefert am 19. März 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Floating charge over the. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Keep Brothers Limited.
    Transaktionen
    • 19. März 1983Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 05. Okt. 1979
    Geliefert am 19. Okt. 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Unit 19B highgate trading estate, moseley rd, kyrwicks, and oughton rd, highgate birmingham wm 122764. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Okt. 1979Registrierung einer Belastung
    • 02. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat EURO PACKAGING LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    04. Sept. 2009Beginn der Verwaltung
    15. Aug. 2012Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Mark Jeremy Orton
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Praktiker
    2 Cornwall Street
    B3 2DL Birmingham
    Allan Watson Graham
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham
    Praktiker
    One Snowhill Snow Hill Queensway
    B4 6GH Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0