GROUP AIR REALISATIONS LIMITED

GROUP AIR REALISATIONS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGROUP AIR REALISATIONS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01329030
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GROUP AIR REALISATIONS LIMITED?

    • Aktivitäten von Reiseveranstaltern (79120) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich GROUP AIR REALISATIONS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    4 Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GROUP AIR REALISATIONS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    PAGE & MOY TRAVEL GROUP AIR HOLIDAYS LIMITED04. März 201104. März 2011
    TRAVELSPHERE LIMITED08. Okt. 198608. Okt. 1986
    TRAVELSPHERE (HARBOROUGH) LIMITED31. Dez. 197831. Dez. 1978
    AWNMAY TRANSPORT LIMITED07. Sept. 197707. Sept. 1977

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GROUP AIR REALISATIONS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Okt. 2015

    Welche sind die letzten Einreichungen für GROUP AIR REALISATIONS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Insolvenzmeldung

    Insolvency:form WU09 - secretary of state's release
    3 SeitenLIQ MISC

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    18 SeitenLIQ14

    Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss

    11 SeitenLIQ10

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    4 Seiten600

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    41 SeitenAM22

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    33 SeitenAM10

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    4 SeitenAM19

    Fortschrittsbericht des Verwalters

    38 SeitenAM10

    Vermögensübersicht mit Formular AM02SOA

    21 SeitenAM02

    Vorschlag des Verwalters

    48 Seiten2.17B

    Ergebnis der Gläubigerversammlung

    50 Seiten2.23B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB zum 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB am 20. Jan. 2017

    2 SeitenAD01

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Compass House Rockingham Road Market Harborough Leicestershire LE16 7QD zum 4 Hardman Square Spinningfields Manchester M3 3EB am 16. Jan. 2017

    1 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    1 Seiten2.12B

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 30. Dez. 2016

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Erfüllung der Belastung 013290300020 vollständig

    4 SeitenMR04

    Erfüllung der Belastung 19 vollständig

    4 SeitenMR04

    Eintragung der Belastung 013290300021, erstellt am 09. Dez. 2016

    20 SeitenMR01

    Beendigung der Bestellung von Nigel John Arthur als Sekretär am 27. Sept. 2016

    1 SeitenTM02

    Ernennung von Mr Peter Eric Buckley als Sekretär am 27. Sept. 2016

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Nigel John Arthur als Geschäftsführer am 27. Sept. 2016

    1 SeitenTM01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2015

    29 SeitenAA

    Eintragung der Belastung 013290300020, erstellt am 04. Mai 2016

    21 SeitenMR01

    Wer sind die Geschäftsführer von GROUP AIR REALISATIONS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    BUCKLEY, Peter Eric
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Sekretär
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    215220310001
    ALLARD, Roger Jeffrey
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Geschäftsführer
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomEnglish81122260002
    MCKINNON, Tracey Anne
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Geschäftsführer
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritish162927400001
    SMITH, Ian
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Geschäftsführer
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    United KingdomBritish5734800003
    WILSON, Colin James
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    Geschäftsführer
    Hardman Square
    Spinningfields
    M3 3EB Manchester
    4
    EnglandBritish162927160001
    ARTHUR, Nigel John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Sekretär
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    193406110001
    EDWARDS, Michael John
    The Hall
    Ketton
    PE9 3RB Stamford
    Lincolnshire
    Sekretär
    The Hall
    Ketton
    PE9 3RB Stamford
    Lincolnshire
    British76861010002
    GADSBY, Christopher
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Sekretär
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    161968570001
    HARDMAN, John Benjamin
    Hill Rise
    Burbage
    LE10 2UA Hinckley
    42
    Leicestershire
    United Kingdom
    Sekretär
    Hill Rise
    Burbage
    LE10 2UA Hinckley
    42
    Leicestershire
    United Kingdom
    British131024350001
    PARKINSON, Ian
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    Sekretär
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    British100921910001
    SIMMONS, Susan
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    Sekretär
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    British125431690001
    THOMAS, Hywel David
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Sekretär
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    British59274640002
    WITTS, Kevan
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Sekretär
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    190942650001
    ARTHUR, Nigel John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandEnglish175689210001
    AUSTEN, Belinda Jane
    28 Stockerston Road
    LE15 9UD Uppingham
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    28 Stockerston Road
    LE15 9UD Uppingham
    Leicestershire
    British102336650001
    BRYANT, Robert David
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish152320790001
    BURTON, William John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish64885440001
    CLEMSON, David
    New Sawley Grange Farm
    Gisburn Road, Sawley
    BB7 4LH Clitheroe
    Lancashire
    Geschäftsführer
    New Sawley Grange Farm
    Gisburn Road, Sawley
    BB7 4LH Clitheroe
    Lancashire
    British68160250001
    COE, Albert Henry
    Finvara Blackhurst Brow
    Wilmslow Road
    SK10 4QT Mottram St Andrew
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Finvara Blackhurst Brow
    Wilmslow Road
    SK10 4QT Mottram St Andrew
    Cheshire
    United KingdomBritish3977310002
    DUFTY, Andrew
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish161857980002
    EDWARDS, Michael John
    The Hall
    Ketton
    PE9 3RB Stamford
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    The Hall
    Ketton
    PE9 3RB Stamford
    Lincolnshire
    British76861010002
    FOSTER, Stephen Albert
    The Lymes
    295 Gisburn Road
    BB9 6AW Barrowford
    Lancashire
    Geschäftsführer
    The Lymes
    295 Gisburn Road
    BB9 6AW Barrowford
    Lancashire
    United KingdomBritish94033560001
    GADSBY, Christopher James
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish118396090002
    GOODENOUGH, Steven
    61 Northampton Road
    LE16 9HD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    61 Northampton Road
    LE16 9HD Market Harborough
    Leicestershire
    British54620130001
    HARVEY, Gillian
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish140490960002
    HIGMAN, Mark
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish140504540003
    MACKAY, Richard
    The Malt House 42 Newbold Road
    Desford
    LE9 9GS Leicester
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    The Malt House 42 Newbold Road
    Desford
    LE9 9GS Leicester
    Leicestershire
    British26236830001
    MORRIS, Neil John
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    United KingdomBritish158818060001
    PARKINSON, Ian
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    Geschäftsführer
    17 South Green
    LA12 0UJ Ulverston
    Cumbria
    British100921910001
    PHILPOT, Nathan Richard
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    UkBritish160975710001
    SIMMONS, Susan
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Reservoir Farm
    Church Street Naseby
    NN6 6DA Northampton
    Northamptonshire
    EnglandBritish125431690001
    SPRIGGS, Pauline Ann
    Poppinwell House
    The Limes
    LE16 7UN Thorpe Langton
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Poppinwell House
    The Limes
    LE16 7UN Thorpe Langton
    Leicestershire
    United KingdomBritish47259460001
    THOMAS, Hywel David
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Compass House
    Rockingham Road
    LE16 7QD Market Harborough
    Leicestershire
    EnglandBritish59274640002
    WAKE, Bruce Hereward
    Hall Cottage
    Ayston
    LE15 Uppingham
    Leicestershire
    Geschäftsführer
    Hall Cottage
    Ayston
    LE15 Uppingham
    Leicestershire
    British26236840001
    WATTS, Mark Bingham Titus
    May Tree Lodge
    Newlands, Naseby
    NN6 6DE Northampton
    Geschäftsführer
    May Tree Lodge
    Newlands, Naseby
    NN6 6DE Northampton
    United KingdomBritish43948350004

    Hat GROUP AIR REALISATIONS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 09. Dez. 2016
    Geliefert am 13. Dez. 2016
    Ausstehend
    Kurzbeschreibung
    Land lying to the north west of rockingham road, market harborough (LT282958); land at rockingham road, market harborough (LT359863); and compass house, rockingham road, market harborough, LE16 7QD (LT230882).
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • All Leisure Holidays Limited
    Transaktionen
    • 13. Dez. 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    A registered charge
    Erstellt am 04. Mai 2016
    Geliefert am 06. Mai 2016
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Freehold land known as compass house, rockingham road, market harborough, leicestershire, LE16 7QD (title numbers LT230882, LT282958 and LT359863).
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Mai 2016Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 21. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    An omnibus guarantee and set-off agreement
    Erstellt am 15. Mai 2012
    Geliefert am 01. Juni 2012
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Any sums or sums standing to the credit of any one or more of any present of future accounts of the company with the bank whether such accounts be denominated in sterling or in any other currency or currency unit, and the debt or debts owing by the bank represented by any such sum or sums (each such sum and debt being a credit balance).
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 01. Juni 2012Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 16. Dez. 2016Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Charge over offset bank account
    Erstellt am 02. Mai 2006
    Geliefert am 16. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from any obligor to the chargee and/or the other secured parties (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All security interest and dispositions, all monies at any time standing to the credit of the security account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Agent)
    Transaktionen
    • 16. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge over offset bank account
    Erstellt am 27. Apr. 2005
    Geliefert am 14. Mai 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due of any member of the group to each finance party (or any of them) under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    All the right, title and interest in to the security account and the account balance. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (As Security Agent for the Finance Parties)
    Transaktionen
    • 14. Mai 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Mai 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 09. Sept. 1997
    Geliefert am 19. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Account no.24705422. The charge creates a fixed charge over all the deposit(s) referred to in the schedule to the form 395 (including all or any part of the money payable pursuant to such deposit(s) and the debts represented thereby) together with all interest from time to time accruing thereon it also creates an assignment by the chargor for the purposes of and to give effect to the security over the right of the chargor to require repayment of such deposit(s) and interest thereon.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 15. Apr. 1996
    Geliefert am 18. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all the deposit(s) being all sums of money in any currency (a) deposited or paid by the company with or to the bank or held by the bank on behalf of the company pursuant to the deposit contract(s) re: travelsphere limited gts treasurers deposit bid no. 73502077 and (b) representing the renewal or replacement of or for any sums deposited or paid or held as aforesiad, together with all interest accruing thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 24. März 1995
    Geliefert am 29. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all the "deposit(s)" together with all interest from time to time accruing thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 27. Feb. 1995
    Geliefert am 03. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A fixed charge over all the deposit(s) together with all interest from time to time accruing thereon. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge over credit balances
    Erstellt am 26. Juli 1994
    Geliefert am 02. Aug. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all the "deposit(s)" together with all interest from time to time accruing thereon. Details of charged contract(s)-barclays bank PLC re travelsphere limited G.T.S. dib deposit deal no. 75755677 (*charge reinstated pursuant to an order of court dated 10 june 1997 together with the variation order). See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Aug. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Nov. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Transfer deed .
    Erstellt am 01. Sept. 1993
    Geliefert am 16. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Freehold property known as or being the three swans hotel, high street, market harborough, leicestershire , title no lt 192973 ,together with all buildings ,fixtures, and fixed plant and machinery, from time to time in or on any real property charged.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Tsb Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 15. März 1990
    Geliefert am 26. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H and/or l/h hereditaments & premises situate at rockingham road, ,market harborough, leicestershire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 26. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. März 1990
    Geliefert am 26. März 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 26. März 1990Registrierung einer Belastung
    • 23. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Nov. 1988
    Geliefert am 13. Dez. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 10 fairfield road market, harborough, leicestershire together with the fixed plant machinery and other fixtures and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1988Registrierung einer Belastung
    • 23. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Nov. 1988
    Geliefert am 13. Dez. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 21 fairfield road market harborough, leicestershire together with fixed plant machinery and other fixtures and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank LTD
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1988Registrierung einer Belastung
    • 23. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 30. Nov. 1988
    Geliefert am 13. Dez. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 16 fairfield road market harborough, leicestershire together with the fixed plant machinery and other fixtures and assigns the goodwill of the business (if any). Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel Bank Limited
    Transaktionen
    • 13. Dez. 1988Registrierung einer Belastung
    • 23. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Juli 1987
    Geliefert am 25. Juli 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold the three swans hotel high street market harborough leicestershire with fixed plant machinery & fixtures. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transaktionen
    • 25. Juli 1987Registrierung einer Belastung
    • 23. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. Apr. 1986
    Geliefert am 11. Apr. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold compass house coventry road, market harborough, leicester LE18 9BZ. All fixed plant machinery and other fixtures.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Hill Samuel & Co Limited
    Transaktionen
    • 11. Apr. 1986Registrierung einer Belastung
    • 23. Apr. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Letter of charge
    Erstellt am 08. Mai 1985
    Geliefert am 20. Mai 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All monies now or at any time hereafter standing to the credit of any account (s) of the company with the banks designated bid deposits.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Mai 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 1984
    Geliefert am 09. Nov. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold 34 coventry road, market harborough, leicestershire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Nov. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 1984
    Geliefert am 09. Nov. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold 1, 3 and 6 school lane market harborough, leicestershire. & land to the rear of 36 & 38 coventry road, aforesaid.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Nov. 1984Registrierung einer Belastung
    • 29. März 1990Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GROUP AIR REALISATIONS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    30. Dez. 2016Beginn der Verwaltung
    22. Mai 2018Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Matthew Richards
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Edward Williams
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    David John Dunckley
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    2
    DatumTyp
    22. Mai 2018Beginn der Liquidation
    01. Nov. 2019Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Dunckley
    4 Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    Praktiker
    4 Hardman Square
    M3 3EB Manchester
    Edward Williams
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Praktiker
    Grant Thornton Uk Llp Colmore Building
    Colmore Circus
    B4 6AT Birmingham
    Matthew Richards
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London
    Praktiker
    30 Finsbury Square
    EC2P 2YU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0