GE ESE UK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGE ESE UK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01329406
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GE ESE UK LIMITED?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich GE ESE UK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von GE ESE UK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TFS LEASING LIMITED10. Aug. 198910. Aug. 1989
    CABLE AND WIRELESS (LEASING) LIMITED09. Sept. 197709. Sept. 1977

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GE ESE UK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für GE ESE UK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    12 SeitenLIQ13

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 16. Sept. 2020

    LRESSP

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT zum 1 More London Place London SE1 2AF am 08. Okt. 2020

    2 SeitenAD01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT verlegt

    2 SeitenAD03

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT geändert

    2 SeitenAD02

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018

    24 SeitenAA

    Änderung der Details des Direktors für Jonathan Lawrence John Gatt am 01. Aug. 2019

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Stewart Girling am 01. Mai 2019

    2 SeitenCH01

    Change of details for Ige Usa Investments as a person with significant control on 23. Nov. 2018

    2 SeitenPSC05

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2018 bis 31. Dez. 2018

    1 SeitenAA01

    Kapitalaufstellung am 16. Aug. 2018

    • Kapital: GBP 1.00
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2017

    22 SeitenAA

    Notification of Ige Usa Investments as a person with significant control on 06. Apr. 2016

    2 SeitenPSC02

    Withdrawal of a person with significant control statement on 28. Dez. 2017

    2 SeitenPSC09

    Ernennung von Paul Stewart Girling als Direktor am 18. Dez. 2017

    2 SeitenAP01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen

    3 SeitenCS01

    Beendigung der Bestellung von Joseph Preston Swithenbank als Geschäftsführer am 11. Sept. 2017

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von GE ESE UK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesBritische Gesellschaft mit beschränkter Haftung
    Registrierungsnummer7038430
    146358090001
    GATT, Jonathan Lawrence John
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomMalteseFp&A Leader228824220001
    GIRLING, Paul Stewart
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    Geschäftsführer
    More London Place
    SE1 2AF London
    1
    United KingdomBritishDirector225432580001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Sekretär
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    British61314280001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Sekretär
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    PRICE, Philip Ian
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    Sekretär
    4 Queenswood Avenue
    Hutton
    CM13 1HR Brentwood
    Essex
    British75578650002
    A G SECRETARIAL LIMITED
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    Sekretär
    100 Barbirolli Square
    M2 3AB Manchester
    90084920001
    HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    Sekretär
    7 Devonshire Square
    Cutlers Gardens
    EC2M 4YH London
    67382580002
    TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    Trafalgar House
    29 Park Place
    LS1 2SP Leeds
    West Yorkshire
    50087010001
    BEADLE, Paul Laurence
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United KingdomBritishEuropean Operations Director100238650001
    BRAIDWOOD, Rodger Gordon
    Abbotsleigh Rosecroft Park
    Farnham Lane
    TN3 0DZ Langton Green
    Kent
    Geschäftsführer
    Abbotsleigh Rosecroft Park
    Farnham Lane
    TN3 0DZ Langton Green
    Kent
    EnglandBritishCompany Director1484600001
    BRENNAN, Ann Elizabeth
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Floor
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishChartered Accountant137519160001
    BRIERLEY, Timothy George
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    NetherlandsBritishLawyer150552870001
    CAKEBREAD, David
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    The Quadrant
    Aztec West
    BS32 4GQ Bristol
    2630
    United Kingdom
    United KingdomBritishNone183172770001
    CHANDLER, Andrew Philip
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    Geschäftsführer
    66 Baywell
    Leybourne
    ME19 5QQ West Malling
    Kent
    BritishFinance Director53832740001
    CITRON, Zachary Joseph
    Cheyne Walk
    NW4 3QH London
    31
    Geschäftsführer
    Cheyne Walk
    NW4 3QH London
    31
    United KingdomBritishSolicitor91783950002
    CITRON, Zachary Joseph
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    Geschäftsführer
    23 Holders Hill Crescent
    NW14 1NE London
    BritishSolicitor91783950001
    CLARK, Roy Graham
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    Geschäftsführer
    18 Rosary Gardens
    SW7 4NT London
    BritishTax Adviser65257100001
    CLUBB, Ian Mcmaster
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Pond House
    EN5 4PS Hadley Green
    Hertfordshire
    BritishDirector3485960001
    D'AMMASSA, Carl Mark
    The Smithy
    Bottoms Farm Warmingham Road
    CW1 4PJ Warmingham
    Geschäftsführer
    The Smithy
    Bottoms Farm Warmingham Road
    CW1 4PJ Warmingham
    BritishCompany Director119207850001
    DELAMORE, Karen Ann
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    United Kingdom
    United KingdomBritishSolicitor136619480001
    DWYER, Stephen John
    3 Juggs Close
    BN7 1QP Lewes
    East Sussex
    Geschäftsführer
    3 Juggs Close
    BN7 1QP Lewes
    East Sussex
    EnglandBritishTax Director57914140001
    ENOCH, Simon Jocelyn
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    Geschäftsführer
    38 Chiddingstone Street
    Fulham
    SW6 3TG London
    EnglandBritishSecretary/Solicitor61314280001
    FAST, Robert Alain
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    NetherlandsAmericanDirector89843360002
    GOODWIN, Eric
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    Geschäftsführer
    Brewers Wood Pondfield Lane
    Shorne
    DA12 3LD Gravesend
    Kent
    EnglandBritishCompany Director45623310001
    GREEN, Pamela Anne
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    7 Belgravia Road
    St Johns
    WF1 3JP Wakefield
    West Yorkshire
    British38435990009
    HITCHIN, Paul Robert
    27 Northcliffe Close
    KT4 7DS Worcester Park
    Surrey
    Geschäftsführer
    27 Northcliffe Close
    KT4 7DS Worcester Park
    Surrey
    BritishFinancial Controller114603290002
    HOWELL, David
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Flat 10 The Isabella
    Hatchford Park Ockham Lane
    KT11 1LR Cobham
    Surrey
    United KingdomBritishAccountant109591300001
    MANDERSON, Mark Anthony
    1 Eaton Court
    BR7 6NB Chislehurst
    Kent
    Geschäftsführer
    1 Eaton Court
    BR7 6NB Chislehurst
    Kent
    New ZealanderAccountant31211810001
    MANNION, Eileen Frances
    74 Church Street
    SK13 7RN Old Glossop
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    74 Church Street
    SK13 7RN Old Glossop
    Derbyshire
    BritishAccountant119358410001
    MCENROE, Malachy
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Old Hall Road
    M33 2HR Sale
    Dovecote House
    Cheshire
    NetherlandsIrishController148254090001
    MOCHAN, Lori Elizabeth
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    201 Talgarth Road
    Hammersmith
    W6 8BJ London
    The Ark
    United Kingdom
    EnglandBritishFinance Manager195905580001
    MONTAGUE, Robert Joel
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Pusey House
    SN7 8QB Pusey
    Oxfordshire
    BritishCompany Director65130630002
    PALMER, Christopher Antony
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Church Farm
    East Woodhay
    RG20 0AL Newbury
    Berkshire
    BritishCompany Director4764800001
    PAREKH, Girish
    Fairhaven
    1 Kings Drive Fulwood
    PR2 3HN Preston
    Geschäftsführer
    Fairhaven
    1 Kings Drive Fulwood
    PR2 3HN Preston
    BritishDirector84067630001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GE ESE UK LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    1 Ashley Road
    WA14 2DT Altrincham
    3rd Floor
    Cheshire
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformLimited By Shares
    RegistrierungslandEngland
    RechtsgrundlageUnited Kingdom (England)
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer3255766
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für GE ESE UK LIMITED?

    Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss
    Benachrichtigt amAufgehört amErklärung
    31. Okt. 201601. Dez. 2017Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen.

    Hat GE ESE UK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 26. Juli 1996
    Geliefert am 30. Juli 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C.as Security Trustee for the Secured Parties
    Transaktionen
    • 30. Juli 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Mai 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 14. Aug. 1995
    Geliefert am 01. Sept. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease agreement dated 29TH december 1989 (as defined),as amended by supplemental agreements dated 31ST december 1991 and 14TH august 1995
    Kurze Angaben
    The trailers as described in the annexed schedule with all accessories,appliances,components......etc.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Trinity (Jersey) Limited
    Transaktionen
    • 01. Sept. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 30. Mai 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Account charge
    Erstellt am 15. März 1994
    Geliefert am 23. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the indemnity (as defined)
    Kurze Angaben
    All the company's right,title,benefit and interest in and to both and each of the company's accounts numbered 14-0-04001346 and P12741 held with national westminster bank PLC at 41 lothbury,london EC2P 2BP including,without limitation,the balance standing to the credit of the charged account. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. März 1994
    Geliefert am 21. März 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to law debenture trust corporation P.L.C as security trustee for the secured parties (as defined therein) or the banks (as defined in the credit agreement dated 13 february 1994 on any account whatsoever under the terms of the said credit agreement and a guarantee dated 15 march 1994 and the other documents relating thereto (each as defined in the credit agreement)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Law Debenture Trust Corporation P.L.C
    Transaktionen
    • 21. März 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 05. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 01. Sept. 1993
    Geliefert am 06. Sept. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities which now are or shall at any time be due,owing or incurred to barclays bank PLC by the company under or pursuant to the facility letter dated 9 april 1992 as varied,supplemented,amended and substituted from time to time and/or by the parent pursuant to the override agreement dated 22 july 1993 in respect of the facility letter.
    Kurze Angaben
    By way of a first fixed charge in favour of barclays bank PLC all of the company's rights,title and interest in and to the charged property as a continuing security for the payment and discharge to barclays bank PLC of the monies and liabilities.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Sept. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A chattel mortgage
    Erstellt am 21. Apr. 1993
    Geliefert am 12. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to corestates bank N.A. under the terms of any finance documents and/or in connection with any loan facility or other financial accommodation and under the terms of this charge
    Kurze Angaben
    By way of assignment by way of security all the mortgagor's right, title and interest in the property excluding receivables;. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Corestates Bank N.A.
    Transaktionen
    • 12. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Hire purchase agreement
    Erstellt am 30. Apr. 1992
    Geliefert am 11. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase agreement reference 04 041195 000
    Kurze Angaben
    Evergreen heavy industrial corp 40' dry van, hyundai precision & industry co LTD 20' dry van, hyundai precision & industry co LTD 20' dry van.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais Equipment Finance Limited
    Transaktionen
    • 11. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 30. Apr. 1992
    Geliefert am 01. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company and/or tiphook container rental company limited to the chargee under the terms of any finance document as defined
    Kurze Angaben
    All specified operating assets acquired by the company after the date of the deed and all its present and future right title and interest to or in its specified property. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank Plcpartiesas Security Agent and Trustee for the Secured
    Transaktionen
    • 01. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 28. Feb. 1992
    Geliefert am 03. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 27/02/92
    Kurze Angaben
    All interests in the charged assets (please see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Westdeutsche Landesbank Girozentrale
    Transaktionen
    • 03. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of charge
    Erstellt am 17. Feb. 1992
    Geliefert am 05. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the rights and interest in the agreements (see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Commerzbank Aktiengesellschaft
    Transaktionen
    • 05. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 28. Nov. 1991
    Geliefert am 07. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £1,076,928.79 and all other monies due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed charge over road trailers as per schedule. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker LTD
    Transaktionen
    • 07. Dez. 1991Registrierung einer Belastung
    • 21. Dez. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge
    Erstellt am 31. Okt. 1991
    Geliefert am 09. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £2,922,956.22 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Fixed charge over road trailers as listed. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bowmaker Limited
    Transaktionen
    • 09. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Dez. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 03. Okt. 1991
    Geliefert am 10. Okt. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 1.10.91
    Kurze Angaben
    See schedule and form 395 for details of particulars. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Creditanstalt-Bankverein
    Transaktionen
    • 10. Okt. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Juni 1991
    Geliefert am 14. Juni 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 30/4/91
    Kurze Angaben
    604 rail wagons as specified on the form 395. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bayerische Hypotheken-Und Wechsel-Bank Ag
    Transaktionen
    • 14. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of charge
    Erstellt am 30. Apr. 1991
    Geliefert am 08. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust indenture of even date and the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest of the company in certain marine shipping containers described in the schedule to the form 395.
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust Company as Trustee for the Noteholders
    Transaktionen
    • 08. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Trust indenture & security agreement
    Erstellt am 30. Apr. 1991
    Geliefert am 08. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust indenture of even date and the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest of the company in certain marine shipping containers described in the schedule to the form 395.
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust Company as Trustee for the Noteholders
    Transaktionen
    • 08. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Indenture supplement no. 1
    Erstellt am 30. Apr. 1991
    Geliefert am 08. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust indenture of even date and the charge
    Kurze Angaben
    All right title and interest of the company in certain marine shipping containers described in the schedule to the form 395.
    Berechtigte Personen
    • Wilmington Trust Company as Trustee for the Noteholders
    Transaktionen
    • 08. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 08. Apr. 1991
    Geliefert am 12. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date and this charge.
    Kurze Angaben
    All rights title and interest of the owner and the benefit of all the owner's right title and interests to all insurance policies. (Please see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Bank of Nova Scotia
    Transaktionen
    • 12. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage of containers
    Erstellt am 04. Apr. 1991
    Geliefert am 18. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    $10,000,000 due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 8/4/91.
    Kurze Angaben
    Mortgage of marine containers or any other containers to be purchased out of the loan at a later date.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Novia Scotia
    Transaktionen
    • 18. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 30. Mai 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of assignment
    Erstellt am 14. März 1991
    Geliefert am 22. März 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from the company and/or euroleasing oy to the chargee under the terms of the facility agreement
    Kurze Angaben
    All rights, title interest and benefit in the master lease agreement dated 28/3/88 (see doc m 454C for full details).
    Berechtigte Personen
    • Kansallis-Osake-Pankki
    Transaktionen
    • 22. März 1991Registrierung einer Belastung
    • 10. Juli 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Invoice
    Erstellt am 04. Feb. 1991
    Geliefert am 20. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase agreement reference no. 331-03-1136-11 of even date
    Kurze Angaben
    453 trailers as described in the schedule attached to the form 395.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais Equipment Finance Limited
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 11. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Container mortgage
    Erstellt am 21. Dez. 1990
    Geliefert am 10. Jan. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The aggregate amount of the loan and of all other sums of money due from the company to the chargee under the terms of the security documents or any of them.
    Kurze Angaben
    By way of fixed charge the cargo containers, and by way of assignment all of the owners interest in all policies and contracts of insurance. See form 395 for details.
    Berechtigte Personen
    • Kredietbank N.V. London Branch
    Transaktionen
    • 10. Jan. 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Invoice dated 2/7/90 hire purchase agreement
    Erstellt am 05. Juli 1990
    Geliefert am 19. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase agreement reference no 331-03-1073-h of even date.
    Kurze Angaben
    The hire purchase agreements and equipment as defined. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Credit Lyonnais Equipment Finance Limited.
    Transaktionen
    • 19. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 11. Dez. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattel mortgage
    Erstellt am 25. Juni 1990
    Geliefert am 12. Juli 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 27.4.90 and/or this charge
    Kurze Angaben
    (1) the chattels (2) benefit of all contracts & agreements (3) the benefit of all insurances (4) any moneys payable to the mortgagor in connection with a disposal of chattels and (5) all book & other monetary debts (see doc. For full details).
    Berechtigte Personen
    • Allied Irish Banks PLC
    Transaktionen
    • 12. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 30. März 1990
    Geliefert am 10. Apr. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 19TH october 1989 as amended by a novation and sale agreement dated 30TH march 1990 and this charge
    Kurze Angaben
    As a continuing and a fixed or specific security the company assigns to the bank 707 4OFT dry van containers having the serial nos 460706-460712, 465913-466112 and 462813-463312,809 2OFT dry van containers having the serial nos 635800-636250 and 636251-636608. (see 395 for more details).
    Berechtigte Personen
    • Commonwealth Bank of Australia
    Transaktionen
    • 10. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    • 18. März 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GE ESE UK LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Sept. 2020Beginn der Liquidation
    13. Okt. 2021Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Richard Barker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Matthew Coomber
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    1 More London Place
    SE1 2AF London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0