GE ESE UK LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GE ESE UK LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01329406 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GE ESE UK LIMITED?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich GE ESE UK LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 More London Place SE1 2AF London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von GE ESE UK LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
TFS LEASING LIMITED | 10. Aug. 1989 | 10. Aug. 1989 |
CABLE AND WIRELESS (LEASING) LIMITED | 09. Sept. 1977 | 09. Sept. 1977 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GE ESE UK LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GE ESE UK LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 12 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham Cheshire WA14 2DT zum 1 More London Place London SE1 2AF am 08. Okt. 2020 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT verlegt | 2 Seiten | AD03 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 3rd Floor 1 Ashley Road Altrincham WA14 2DT geändert | 2 Seiten | AD02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 24 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Jonathan Lawrence John Gatt am 01. Aug. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Paul Stewart Girling am 01. Mai 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Change of details for Ige Usa Investments as a person with significant control on 23. Nov. 2018 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Aktueller Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Juni 2018 bis 31. Dez. 2018 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 16. Aug. 2018
| 3 Seiten | SH19 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2017 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Notification of Ige Usa Investments as a person with significant control on 06. Apr. 2016 | 2 Seiten | PSC02 | ||||||||||
Withdrawal of a person with significant control statement on 28. Dez. 2017 | 2 Seiten | PSC09 | ||||||||||
Ernennung von Paul Stewart Girling als Direktor am 18. Dez. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 31. Okt. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Joseph Preston Swithenbank als Geschäftsführer am 11. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GE ESE UK LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
OAKWOOD CORPORATE SECRETARY LIMITED | Sekretär | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom |
| 146358090001 | ||||||||||
GATT, Jonathan Lawrence John | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | Maltese | Fp&A Leader | 228824220001 | ||||||||
GIRLING, Paul Stewart | Geschäftsführer | More London Place SE1 2AF London 1 | United Kingdom | British | Director | 225432580001 | ||||||||
ENOCH, Simon Jocelyn | Sekretär | 38 Chiddingstone Street Fulham SW6 3TG London | British | 61314280001 | ||||||||||
GREEN, Pamela Anne | Sekretär | 7 Belgravia Road St Johns WF1 3JP Wakefield West Yorkshire | British | 38435990009 | ||||||||||
PRICE, Philip Ian | Sekretär | 4 Queenswood Avenue Hutton CM13 1HR Brentwood Essex | British | 75578650002 | ||||||||||
A G SECRETARIAL LIMITED | Sekretär | 100 Barbirolli Square M2 3AB Manchester | 90084920001 | |||||||||||
HAMMOND SUDDARDS SECRETARIES LIMITED | Sekretär | 7 Devonshire Square Cutlers Gardens EC2M 4YH London | 67382580002 | |||||||||||
TRAF SHELF (NOMINEES) LIMITED | Sekretär | Trafalgar House 29 Park Place LS1 2SP Leeds West Yorkshire | 50087010001 | |||||||||||
BEADLE, Paul Laurence | Geschäftsführer | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire | United Kingdom | British | European Operations Director | 100238650001 | ||||||||
BRAIDWOOD, Rodger Gordon | Geschäftsführer | Abbotsleigh Rosecroft Park Farnham Lane TN3 0DZ Langton Green Kent | England | British | Company Director | 1484600001 | ||||||||
BRENNAN, Ann Elizabeth | Geschäftsführer | Floor 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 137519160001 | ||||||||
BRIERLEY, Timothy George | Geschäftsführer | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire | Netherlands | British | Lawyer | 150552870001 | ||||||||
CAKEBREAD, David | Geschäftsführer | The Quadrant Aztec West BS32 4GQ Bristol 2630 United Kingdom | United Kingdom | British | None | 183172770001 | ||||||||
CHANDLER, Andrew Philip | Geschäftsführer | 66 Baywell Leybourne ME19 5QQ West Malling Kent | British | Finance Director | 53832740001 | |||||||||
CITRON, Zachary Joseph | Geschäftsführer | Cheyne Walk NW4 3QH London 31 | United Kingdom | British | Solicitor | 91783950002 | ||||||||
CITRON, Zachary Joseph | Geschäftsführer | 23 Holders Hill Crescent NW14 1NE London | British | Solicitor | 91783950001 | |||||||||
CLARK, Roy Graham | Geschäftsführer | 18 Rosary Gardens SW7 4NT London | British | Tax Adviser | 65257100001 | |||||||||
CLUBB, Ian Mcmaster | Geschäftsführer | Pond House EN5 4PS Hadley Green Hertfordshire | British | Director | 3485960001 | |||||||||
D'AMMASSA, Carl Mark | Geschäftsführer | The Smithy Bottoms Farm Warmingham Road CW1 4PJ Warmingham | British | Company Director | 119207850001 | |||||||||
DELAMORE, Karen Ann | Geschäftsführer | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire United Kingdom | United Kingdom | British | Solicitor | 136619480001 | ||||||||
DWYER, Stephen John | Geschäftsführer | 3 Juggs Close BN7 1QP Lewes East Sussex | England | British | Tax Director | 57914140001 | ||||||||
ENOCH, Simon Jocelyn | Geschäftsführer | 38 Chiddingstone Street Fulham SW6 3TG London | England | British | Secretary/Solicitor | 61314280001 | ||||||||
FAST, Robert Alain | Geschäftsführer | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire | Netherlands | American | Director | 89843360002 | ||||||||
GOODWIN, Eric | Geschäftsführer | Brewers Wood Pondfield Lane Shorne DA12 3LD Gravesend Kent | England | British | Company Director | 45623310001 | ||||||||
GREEN, Pamela Anne | Geschäftsführer | 7 Belgravia Road St Johns WF1 3JP Wakefield West Yorkshire | British | 38435990009 | ||||||||||
HITCHIN, Paul Robert | Geschäftsführer | 27 Northcliffe Close KT4 7DS Worcester Park Surrey | British | Financial Controller | 114603290002 | |||||||||
HOWELL, David | Geschäftsführer | Flat 10 The Isabella Hatchford Park Ockham Lane KT11 1LR Cobham Surrey | United Kingdom | British | Accountant | 109591300001 | ||||||||
MANDERSON, Mark Anthony | Geschäftsführer | 1 Eaton Court BR7 6NB Chislehurst Kent | New Zealander | Accountant | 31211810001 | |||||||||
MANNION, Eileen Frances | Geschäftsführer | 74 Church Street SK13 7RN Old Glossop Derbyshire | British | Accountant | 119358410001 | |||||||||
MCENROE, Malachy | Geschäftsführer | Old Hall Road M33 2HR Sale Dovecote House Cheshire | Netherlands | Irish | Controller | 148254090001 | ||||||||
MOCHAN, Lori Elizabeth | Geschäftsführer | 201 Talgarth Road Hammersmith W6 8BJ London The Ark United Kingdom | England | British | Finance Manager | 195905580001 | ||||||||
MONTAGUE, Robert Joel | Geschäftsführer | Pusey House SN7 8QB Pusey Oxfordshire | British | Company Director | 65130630002 | |||||||||
PALMER, Christopher Antony | Geschäftsführer | Church Farm East Woodhay RG20 0AL Newbury Berkshire | British | Company Director | 4764800001 | |||||||||
PAREKH, Girish | Geschäftsführer | Fairhaven 1 Kings Drive Fulwood PR2 3HN Preston | British | Director | 84067630001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GE ESE UK LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Ige Usa Investments Limited | 06. Apr. 2016 | 1 Ashley Road WA14 2DT Altrincham 3rd Floor Cheshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Wie lauten die letzten Erklärungen zu Personen mit maßgeblichem Einfluss für GE ESE UK LIMITED?
Benachrichtigt am | Aufgehört am | Erklärung |
---|---|---|
31. Okt. 2016 | 01. Dez. 2017 | Das Unternehmen hat die erforderlichen Schritte zur Ermittlung, ob eine Person eine registrierungspflichtige Person oder eine registrierungspflichtige relevante juristische Person in Bezug auf das Unternehmen ist, noch nicht abgeschlossen. |
Hat GE ESE UK LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Debenture | Erstellt am 26. Juli 1996 Geliefert am 30. Juli 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under, or pursuant to the credit agreement, the indenture, the notes, the company's bank guarantee, the company's noteholder guarantee, the new asset financing guarantees and the other secured documents | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 14. Aug. 1995 Geliefert am 01. Sept. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to the lease agreement dated 29TH december 1989 (as defined),as amended by supplemental agreements dated 31ST december 1991 and 14TH august 1995 | |
Kurze Angaben The trailers as described in the annexed schedule with all accessories,appliances,components......etc.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Account charge | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 23. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the indemnity (as defined) | |
Kurze Angaben All the company's right,title,benefit and interest in and to both and each of the company's accounts numbered 14-0-04001346 and P12741 held with national westminster bank PLC at 41 lothbury,london EC2P 2BP including,without limitation,the balance standing to the credit of the charged account. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 15. März 1994 Geliefert am 21. März 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to law debenture trust corporation P.L.C as security trustee for the secured parties (as defined therein) or the banks (as defined in the credit agreement dated 13 february 1994 on any account whatsoever under the terms of the said credit agreement and a guarantee dated 15 march 1994 and the other documents relating thereto (each as defined in the credit agreement) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge | Erstellt am 01. Sept. 1993 Geliefert am 06. Sept. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities which now are or shall at any time be due,owing or incurred to barclays bank PLC by the company under or pursuant to the facility letter dated 9 april 1992 as varied,supplemented,amended and substituted from time to time and/or by the parent pursuant to the override agreement dated 22 july 1993 in respect of the facility letter. | |
Kurze Angaben By way of a first fixed charge in favour of barclays bank PLC all of the company's rights,title and interest in and to the charged property as a continuing security for the payment and discharge to barclays bank PLC of the monies and liabilities. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A chattel mortgage | Erstellt am 21. Apr. 1993 Geliefert am 12. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to corestates bank N.A. under the terms of any finance documents and/or in connection with any loan facility or other financial accommodation and under the terms of this charge | |
Kurze Angaben By way of assignment by way of security all the mortgagor's right, title and interest in the property excluding receivables;. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hire purchase agreement | Erstellt am 30. Apr. 1992 Geliefert am 11. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase agreement reference 04 041195 000 | |
Kurze Angaben Evergreen heavy industrial corp 40' dry van, hyundai precision & industry co LTD 20' dry van, hyundai precision & industry co LTD 20' dry van. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 30. Apr. 1992 Geliefert am 01. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and/or tiphook container rental company limited to the chargee under the terms of any finance document as defined | |
Kurze Angaben All specified operating assets acquired by the company after the date of the deed and all its present and future right title and interest to or in its specified property. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 28. Feb. 1992 Geliefert am 03. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter dated 27/02/92 | |
Kurze Angaben All interests in the charged assets (please see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Memorandum of charge | Erstellt am 17. Feb. 1992 Geliefert am 05. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All the rights and interest in the agreements (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge | Erstellt am 28. Nov. 1991 Geliefert am 07. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £1,076,928.79 and all other monies due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed charge over road trailers as per schedule. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge | Erstellt am 31. Okt. 1991 Geliefert am 09. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2,922,956.22 and all other monies due or to become due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Fixed charge over road trailers as listed. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 03. Okt. 1991 Geliefert am 10. Okt. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility letter dated 1.10.91 | |
Kurze Angaben See schedule and form 395 for details of particulars. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Juni 1991 Geliefert am 14. Juni 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a loan agreement dated 30/4/91 | |
Kurze Angaben 604 rail wagons as specified on the form 395. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of charge | Erstellt am 30. Apr. 1991 Geliefert am 08. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust indenture of even date and the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest of the company in certain marine shipping containers described in the schedule to the form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Trust indenture & security agreement | Erstellt am 30. Apr. 1991 Geliefert am 08. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust indenture of even date and the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest of the company in certain marine shipping containers described in the schedule to the form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Indenture supplement no. 1 | Erstellt am 30. Apr. 1991 Geliefert am 08. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a trust indenture of even date and the charge | |
Kurze Angaben All right title and interest of the company in certain marine shipping containers described in the schedule to the form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 08. Apr. 1991 Geliefert am 12. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement of even date and this charge. | |
Kurze Angaben All rights title and interest of the owner and the benefit of all the owner's right title and interests to all insurance policies. (Please see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage of containers | Erstellt am 04. Apr. 1991 Geliefert am 18. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag $10,000,000 due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 8/4/91. | |
Kurze Angaben Mortgage of marine containers or any other containers to be purchased out of the loan at a later date. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of assignment | Erstellt am 14. März 1991 Geliefert am 22. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from the company and/or euroleasing oy to the chargee under the terms of the facility agreement | |
Kurze Angaben All rights, title interest and benefit in the master lease agreement dated 28/3/88 (see doc m 454C for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Invoice | Erstellt am 04. Feb. 1991 Geliefert am 20. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase agreement reference no. 331-03-1136-11 of even date | |
Kurze Angaben 453 trailers as described in the schedule attached to the form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Container mortgage | Erstellt am 21. Dez. 1990 Geliefert am 10. Jan. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The aggregate amount of the loan and of all other sums of money due from the company to the chargee under the terms of the security documents or any of them. | |
Kurze Angaben By way of fixed charge the cargo containers, and by way of assignment all of the owners interest in all policies and contracts of insurance. See form 395 for details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Invoice dated 2/7/90 hire purchase agreement | Erstellt am 05. Juli 1990 Geliefert am 19. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company to the chargee under the terms of the hire purchase agreement reference no 331-03-1073-h of even date. | |
Kurze Angaben The hire purchase agreements and equipment as defined. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Chattel mortgage | Erstellt am 25. Juni 1990 Geliefert am 12. Juli 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility letter dated 27.4.90 and/or this charge | |
Kurze Angaben (1) the chattels (2) benefit of all contracts & agreements (3) the benefit of all insurances (4) any moneys payable to the mortgagor in connection with a disposal of chattels and (5) all book & other monetary debts (see doc. For full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 30. März 1990 Geliefert am 10. Apr. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a loan agreement dated 19TH october 1989 as amended by a novation and sale agreement dated 30TH march 1990 and this charge | |
Kurze Angaben As a continuing and a fixed or specific security the company assigns to the bank 707 4OFT dry van containers having the serial nos 460706-460712, 465913-466112 and 462813-463312,809 2OFT dry van containers having the serial nos 635800-636250 and 636251-636608. (see 395 for more details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat GE ESE UK LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0