VICTOR GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameVICTOR GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01330212
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von VICTOR GROUP LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich VICTOR GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Cala House
    54 The Causeway
    TW18 3AX Staines
    Surrey
    United Kingdom
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von VICTOR GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    VICTOR HOMES LIMITED31. Dez. 197931. Dez. 1979
    VICTOR SYSTEM HOMES LIMITED31. Dez. 197731. Dez. 1977
    WULEIGH LIMITED15. Sept. 197715. Sept. 1977

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von VICTOR GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für VICTOR GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 10. Juli 2013

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    5 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 18. Apr. 2013

    7 Seiten4.68

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2012

    5 SeitenAA

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    legacy

    3 SeitenMG02

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 19. Apr. 2012

    LRESSP

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Apr. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital24. Apr. 2012

    Kapitalaufstellung am 24. Apr. 2012

    • Kapital: GBP 300,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2011

    6 SeitenAA

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Block B Burgan House the Causeway Staines Middlesex TW18 3PR am 02. März 2012

    1 SeitenAD01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Apr. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2010

    5 SeitenAA

    legacy

    15 SeitenMG01

    Jahresrückblick erstellt bis 18. Apr. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Juni 2009

    5 SeitenAA

    Beschlüsse

    Resolutions
    11 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Beendigung der Bestellung von Alan Downie als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Geoffrey Ball als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Alan Duke Brown als Direktor

    3 SeitenAP01

    legacy

    7 SeitenMG01

    Wer sind die Geschäftsführer von VICTOR GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    LEDGE SERVICES LIMITED
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    Sekretär
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1HA Aberdeen
    42504200004
    BROWN, Alan Duke
    Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House 5
    Geschäftsführer
    Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House 5
    EnglandBritish32640750005
    REID, John Graham Gunn
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Geschäftsführer
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    ScotlandBritish54537790003
    WARD, Arnold Geoffrey
    7 Holmsley Garth
    Woodlesford
    LS26 8RZ Leeds
    West Yorkshire
    Sekretär
    7 Holmsley Garth
    Woodlesford
    LS26 8RZ Leeds
    West Yorkshire
    British7510670001
    LEDINGHAM CHALMERS LLP
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    Sekretär
    Johnstone House
    52-54 Rose Street
    AB10 1UD Aberdeen
    73896680003
    BALL, Geoffrey Arthur
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Geschäftsführer
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    ScotlandBritish246030002
    DICK, Robert John Westwater
    5 Comiston Drive
    EH10 5QP Edinburgh
    Lothian
    Scotland
    Geschäftsführer
    5 Comiston Drive
    EH10 5QP Edinburgh
    Lothian
    Scotland
    British246770002
    DOWNIE, Alan Wood
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    Geschäftsführer
    5 Mid New Cultins
    EH11 4DU Edinburgh
    Adam House
    Scotland
    ScotlandBritish248110001
    EAMES, Malcolm Russell
    19 Grove Crescent South
    Boston Spa
    LS23 6AY Wetherby
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    19 Grove Crescent South
    Boston Spa
    LS23 6AY Wetherby
    West Yorkshire
    British26059770001
    FLEMING, Peter Maclean
    52 Falcon Road
    BD16 4DW Bingley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    52 Falcon Road
    BD16 4DW Bingley
    West Yorkshire
    EnglandBritish43012300001
    KENT, Kathleen
    15 Mayfield Grove
    Wilsden
    BD15 0EY Bradford
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    15 Mayfield Grove
    Wilsden
    BD15 0EY Bradford
    West Yorkshire
    British7510700001
    MORE, Gerald Campbell
    37 Morningside Drive
    EH10 5LZ Edinburgh
    Geschäftsführer
    37 Morningside Drive
    EH10 5LZ Edinburgh
    British66976580001
    PRESTON, James Jackson Wilson
    West Ghyll
    21 Victoria Avenue
    LS29 9BW Ilkley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    West Ghyll
    21 Victoria Avenue
    LS29 9BW Ilkley
    West Yorkshire
    British57938300004
    WILLETTS, Franklyn Nigel
    46 Lane End
    LS28 9AD Pudsey
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    46 Lane End
    LS28 9AD Pudsey
    West Yorkshire
    United KingdomBritish26059780002

    Hat VICTOR GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 29. Juni 2010
    Geliefert am 07. Juli 2010
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee and the other senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC ( the “Security Trustee”)
    Transaktionen
    • 07. Juli 2010Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Floating charge
    Erstellt am 21. Dez. 2009
    Geliefert am 23. Dez. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee and the other senior creditors (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The whole of the property, assets and undertaking (including uncalled capital).
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Senior Creditors (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Debenture
    Erstellt am 21. Dez. 2009
    Geliefert am 23. Dez. 2009
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company or any other obligor to the chargee and the other senior creditors or any of them on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC as Agent and Security Trustee for Each of the Senior Creditors (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 23. Dez. 2009Registrierung einer Belastung (MG01)
    • 08. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Letter of charge
    Erstellt am 08. Juli 1994
    Geliefert am 20. Juli 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys due or to become due from victor group limited to the governor and company of the bank of scotland under or pursuant to the terms of the charge.
    Kurze Angaben
    All monies now or at any time herafter standing to the credit of any account or accounts of the company in the bank's books,.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland.
    Transaktionen
    • 20. Juli 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Dez. 2012Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Feb. 1991
    Geliefert am 26. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 woodside road boston spa wetherby west yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • National Provincial Building Society
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Feb. 1991
    Geliefert am 26. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    2 applerley lane yeadon wst yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • National Provincial Building Society
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 12. Feb. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Feb. 1991
    Geliefert am 26. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    5 bolehill park brighouse west yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • National Provincial Building Society
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Feb. 1991
    Geliefert am 26. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    22 george lane calverton nottingham.
    Berechtigte Personen
    • National & Provincial Building Society
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Feb. 1991
    Geliefert am 26. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    23 oakwell avenue batley west yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • National & Provincial Building Society
    Transaktionen
    • 26. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 22. Feb. 1991
    Geliefert am 23. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge not exceeding £1,000,000.
    Kurze Angaben
    Any properties purchased by the company in part exchange for new properties sold out.
    Berechtigte Personen
    • National Provincial Building Society
    Transaktionen
    • 23. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. März 1990
    Geliefert am 17. Apr. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land fronting hall lane northawram hall halifax west yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Apr. 1990Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Dez. 1989
    Geliefert am 04. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Land on the north side of abbotsford road york north yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • The Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Dez. 1989
    Geliefert am 04. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Land on north side of intake place bromley west yorkshire title no wyk 422779.
    Berechtigte Personen
    • The Governor Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Dez. 1989
    Geliefert am 04. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Land in the north east side of fieldhead lane and birstall lane droghlington leeds w yorkshire title no wyk 354895.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Dez. 1989
    Geliefert am 04. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or any of the companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    9, 11 and 13 hyde terrace leeds together with lind & buildings lying to the west side of hyde place leeds w yorkshire title no:- wyk 418184 wyk 4181848 wyk 418185, wyk 4300778.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Dez. 1989
    Geliefert am 04. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Providence works marsh pudsey w yorkshire title no 408594.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Dez. 1989
    Geliefert am 04. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Land lying to the smith of brownhill rd and on the east side of quarry lane and on the north of norwood drive birstall w yorkshire title no wyk 334272.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 19. Juli 1989
    Geliefert am 25. Juli 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land at rear of oaks cottage boston spa west yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 25. Juli 1989Registrierung einer Belastung
    • 23. Juli 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge registered pursuant to an order of court 17/8/89
    Erstellt am 26. Jan. 1989
    Geliefert am 30. Aug. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All that f/h plot of land situate to the rear of oaks cottage oaks lane boston spa west yorkshire.
    Berechtigte Personen
    • Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 30. Aug. 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Dez. 1988
    Geliefert am 04. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    All those two, plots of land at laven thorpe lane thornton bradford w yorkshire title no:- wyk 420635.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 10. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Dez. 1988
    Geliefert am 04. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Firstly willow cottage willow lane clifford west yorkshire secondly land comprising part of the croft albion street clifford west yorkshire title no wyk 335345.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 10. März 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Dez. 1988
    Geliefert am 04. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or delmorgan limited to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    East cottingworth arms (formerly k/a the bluebell inn) east cottingwith humberside title no hs 29802.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 19. Dez. 1988
    Geliefert am 04. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and or all of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Berkeley house, clarendon rd, leeds, west yorkshire title no ywe 54478 wnd WK419864.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 04. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 22. Nov. 1988
    Geliefert am 02. Dez. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at fieldhead lane, drighlington, leeds. The borrower as beneficial owner hereby charges by way of legal mortgage all and singular the above property together with all fixtures other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act.
    Berechtigte Personen
    • Chartered Trust PLC
    Transaktionen
    • 02. Dez. 1988Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Nov. 1988
    Geliefert am 24. Nov. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings a north side of abbotsford road york north yorkshire together with all fixtures whatseover now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878.
    Berechtigte Personen
    • Chartered Trust Public Limited Company
    Transaktionen
    • 24. Nov. 1988Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat VICTOR GROUP LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    16. Okt. 2013Aufgelöst am
    19. Apr. 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Donald Mckinnon
    168 Bath Street
    G2 4TP Glasgow
    Praktiker
    168 Bath Street
    G2 4TP Glasgow

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0