WARMINSTER PROPERTIES LIMITED

WARMINSTER PROPERTIES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWARMINSTER PROPERTIES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01333953
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WARMINSTER PROPERTIES LIMITED?

    • (7011) /
    • (7020) /

    Wo befindet sich WARMINSTER PROPERTIES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    51 South Street
    Dorking
    RH4 2JX Surrey
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WARMINSTER PROPERTIES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WARMINSTER TROUT FARMS LIMITED14. Okt. 197714. Okt. 1977

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WARMINSTER PROPERTIES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für WARMINSTER PROPERTIES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für WARMINSTER PROPERTIES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Wiederherstellung durch Gerichtsbeschluss

    3 SeitenAC92

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2007

    5 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    3 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2006

    5 SeitenAA

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    3 Seiten395

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    3 Seiten395

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2005

    5 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2004

    5 SeitenAA

    legacy

    1 Seiten288b

    legacy

    6 Seiten363s
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    annual-return02. Juni 2005

    legacy

    363(288)

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    1 Seiten287

    legacy

    6 Seiten363s

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. März 2003

    6 SeitenAA

    legacy

    6 Seiten363s

    Wer sind die Geschäftsführer von WARMINSTER PROPERTIES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SWIFT, Colin
    Coneyhurst Abinger Lane
    Abinger Common
    RH5 6JF Dorking
    Surrey
    Sekretär
    Coneyhurst Abinger Lane
    Abinger Common
    RH5 6JF Dorking
    Surrey
    British12801520001
    LEWIS, William Austin
    Fernbank
    Harrisons Lane Abinger Common
    RH5 6JF Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Fernbank
    Harrisons Lane Abinger Common
    RH5 6JF Dorking
    Surrey
    BritishFarmer78266940001
    PULLAR, Simon Denis Hedley
    Monks Tower
    Okewood Hill, Honeywood Lane
    RH5 5PZ Dorking
    Surrey
    Sekretär
    Monks Tower
    Okewood Hill, Honeywood Lane
    RH5 5PZ Dorking
    Surrey
    British63507580001

    Hat WARMINSTER PROPERTIES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal charge
    Erstellt am 30. Mai 2007
    Geliefert am 31. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 5 malby house malby street london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Mai 2007
    Geliefert am 31. Mai 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Flat 1 malby house malby street london. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 31. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Apr. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Aug. 2006
    Geliefert am 26. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    91A and 91B balfour street london t/n TGL20099. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 10. Feb. 1999
    Geliefert am 12. Feb. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever and all sums due under the terms of the commercial mortgage loan approval
    Kurze Angaben
    5 maltby house maltby street london SE1. By way of fixed charge all rental income present or future and whether payable now or in the future and the proceeds of any sale lease or other disposition of the property as listed above and all rights and claims of the company against all lessees, sub-lessees, licensees or occupiers of the said property. By way of floating charge the undertaking and all other property assets and rights of the company not effectively charged above.
    Berechtigte Personen
    • Capital Home Loans LTD
    Transaktionen
    • 12. Feb. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 1998
    Geliefert am 05. Jan. 1999
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1 maltby house maltby street london SE1 and by way of fixed charge all rental income and by way of floating charge the undertaking and all other property assets and rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Capital Home Loans Limited
    Transaktionen
    • 05. Jan. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Nov. 1998
    Geliefert am 27. Nov. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    68 beaufoy terrace dover kent together with fixed charge all rental income and the proceeds of any sale lease or other disposition of the property and all rights claims against all lessees sub-lessees licencees or occupiers of the property and by way of floating charge the undertaking and all other propertty and assets and rights the company not charged above.
    Berechtigte Personen
    • Capital Home Loans
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 26. Nov. 1998
    Geliefert am 27. Nov. 1998
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    91A and 91B balfour street london together with all rental income and proceeds of sale lease and and all rights of the company against all lessees sub-lessees licencees or occupiers of the said property and floating charge over all undertaking property and assets not charged by way of fixed charge above.
    Berechtigte Personen
    • Capital Home Loans
    Transaktionen
    • 27. Nov. 1998Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Apr. 1995
    Geliefert am 03. Mai 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property situate in beaufoy terrace dover kent t/n K678489 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Mai 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 03. Feb. 1994
    Geliefert am 10. Feb. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Okt. 1991
    Geliefert am 15. Okt. 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    91 balfour street l b of southwark, title no: tgl 20099. and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Okt. 1991Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 10. Juni 1991
    Geliefert am 19. Juni 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    89, balfour street london. SE17. L/b of southwark and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Juni 1991Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 08. März 1991
    Geliefert am 21. März 1991
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    87 balfour street SE17. L/b of southwark title no: tgl 20099, and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. März 1991Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Juli 1990
    Geliefert am 17. Juli 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on south side of a road leading from ewhurst to forest green ewhurst surrey title no sy 360618 and/or the proceeds sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 17. Juli 1990Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 06. Juli 1990
    Geliefert am 16. Juli 1990
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land lying to south of westbrook hall bognor road warnham west sussex title no:- wsx 143993, and/or the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Juli 1990Registrierung einer Belastung

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0