PAISLEY 1989 PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnamePAISLEY 1989 PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 01340285
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von PAISLEY 1989 PLC?

    • Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen

    Wo befindet sich PAISLEY 1989 PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Brookfield House
    44-48 Davies Street
    W1K 5JA London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von PAISLEY 1989 PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ARROWCROFT GROUP PLC28. Sept. 201028. Sept. 2010
    CCR INVESTMENT GROUP PLC09. März 200909. März 2009
    ARROWCROFT GROUP PLC04. Aug. 198704. Aug. 1987
    ARROWCROFT GROUP PLC31. Dez. 197931. Dez. 1979
    ARROWCROFT GROUP PLC31. Dez. 197931. Dez. 1979

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PAISLEY 1989 PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2013

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PAISLEY 1989 PLC?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für PAISLEY 1989 PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital10. Sept. 2014

    Kapitalaufstellung am 10. Sept. 2014

    • Kapital: GBP 2,832,916
    SH01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013

    15 SeitenAA

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed arrowcroft group PLC\certificate issued on 05/06/14
    3 SeitenCERTNM
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name05. Juni 2014

    Namensänderung durch Beschluss

    NM01
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 05. Juni 2014

    RES15

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 110 Park Street Mayfair London W1K 6AD am 28. März 2014

    1 SeitenAD01

    Ernennung von Mr Stuart Neil Eppel als Sekretär am 17. März 2014

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Daniel Richard Edward Carter als Geschäftsführer am 17. März 2014

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Alan Jones als Sekretär am 17. März 2014

    1 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Alan Jones als Geschäftsführer am 17. März 2014

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von James Lawrence Burchell als Geschäftsführer am 28. Okt. 2013

    1 SeitenTM01

    Änderung der Details des Direktors für Mr James Lawrence Burchell am 17. Sept. 2013

    2 SeitenCH01

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012

    15 SeitenAA

    Ernennung von Mr James Lawrence Burchell als Direktor am 17. Jan. 2013

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Leonard Cedric Eppel als Geschäftsführer am 12. Aug. 2012

    1 SeitenTM01

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    15 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt

    1 SeitenAD03

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    15 SeitenAA

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    49 SeitenMEM/ARTS

    Bescheinigung über die Änderung der Firma

    Company name changed ccr investment group PLC\certificate issued on 28/09/10
    2 SeitenCERTNM
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    change-of-name

    Beschluss zur Änderung der Firma am 20. Sept. 2010

    RES15

    Hinweis auf Namensänderung

    2 SeitenCONNOT

    Wer sind die Geschäftsführer von PAISLEY 1989 PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    EPPEL, Stuart Neil
    44-48 Davies Street
    W1K 5JA London
    Brookfield House
    United Kingdom
    Sekretär
    44-48 Davies Street
    W1K 5JA London
    Brookfield House
    United Kingdom
    186049970001
    EPPEL, Stuart Neil
    Park Street
    Mayfair
    W1K 6AD London
    110
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Park Street
    Mayfair
    W1K 6AD London
    110
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor36660410004
    HAI, Nicholas Paul
    44-48 Davies Street
    W1K 5JA London
    Brookfield House
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    44-48 Davies Street
    W1K 5JA London
    Brookfield House
    United Kingdom
    EnglandBritishChartered Surveyor14697390002
    JONES, Alan
    110 Park Street
    Mayfair
    W1K 6AD London
    Sekretär
    110 Park Street
    Mayfair
    W1K 6AD London
    British14634220001
    BURCHELL, James Lawrence
    110 Park Street
    Mayfair
    W1K 6AD London
    Geschäftsführer
    110 Park Street
    Mayfair
    W1K 6AD London
    United KingdomBritishChief Executive37364960006
    CAMPBELL HORNE, Iain David
    Cato Street
    W1H 5JF London
    17
    Geschäftsführer
    Cato Street
    W1H 5JF London
    17
    BritishChartered Surveyor73859540001
    CARTER, Daniel Richard Edward
    110 Park Street
    Mayfair
    W1K 6AD London
    Geschäftsführer
    110 Park Street
    Mayfair
    W1K 6AD London
    EnglandBritishDevelopment Surveyor14697360004
    EPPEL, Barbara Priscilla
    Flat 1 Summit Lodge
    9 Lower Terrace Hampstead
    NW3 6RF London
    Geschäftsführer
    Flat 1 Summit Lodge
    9 Lower Terrace Hampstead
    NW3 6RF London
    BritishCompany Director15234090003
    EPPEL, Leonard Cedric
    110 Park Street
    Mayfair
    W1K 6AD London
    Geschäftsführer
    110 Park Street
    Mayfair
    W1K 6AD London
    BritishProperty Developer28121430001
    FOX, Christopher Paul
    7 Larchways
    Appleton Park
    WA4 5EN Warrington
    Cheshire
    Geschäftsführer
    7 Larchways
    Appleton Park
    WA4 5EN Warrington
    Cheshire
    BritishManaging Director49798200002
    JONES, Alan
    110 Park Street
    Mayfair
    W1K 6AD London
    Geschäftsführer
    110 Park Street
    Mayfair
    W1K 6AD London
    United KingdomBritishFinance Director14634220001
    VINEY, Mark Nigel Merriam
    Plumtree Cottage
    Hudnall Lane
    HP4 1QQ Little Gaddesden
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    Plumtree Cottage
    Hudnall Lane
    HP4 1QQ Little Gaddesden
    Hertfordshire
    BritishManaging Director34472870001
    WHARTON, Malcolm Brian
    43 Frewin Road
    SW18 3LR London
    Geschäftsführer
    43 Frewin Road
    SW18 3LR London
    BritishCompany Director37417390001

    Hat PAISLEY 1989 PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge over deposit
    Erstellt am 05. Juli 2007
    Geliefert am 18. Juli 2007
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The deposit,. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Mayor and Burgesses of the London Borough of Croydon
    Transaktionen
    • 18. Juli 2007Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Dez. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (MG02)
    Charge and assignment between the company gemstand limited arrowcroft limited and the chargee
    Erstellt am 31. Jan. 2001
    Geliefert am 15. Feb. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness monies obligations and liabilities of the chargors to the chargee and/or any transferee (as defined in the charge) under the terms of the facility letter and/or the guarantee documents and/or under any other security documents (all as defined) together with all expenses and interest thereon and all other present and/or future indebtedness on any account
    Kurze Angaben
    The chargors charge (pursuant to the charge and assignment dated 9 january 2001 between the parties hereto) all right title and interest from time to time in and to the building contract and appointments. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge assignment dated 9TH january 2001 (the "charge") between the chargor, gemstand limited, arrowcroft limited (together the "chargors") and n m rothschild & sons limited (the "chargee")
    Erstellt am 09. Jan. 2001
    Geliefert am 25. Jan. 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All indebtedness, monies and obligations and liabilities due or to become due from the company and/or any chargors to the chargee and/or any transferee (as defined in the charge), arising whether directly or indirectly under the terms of the facility letter and/or in connection with the facility thereby granted and/or under the charge and/or the guarantee documents and/or under any other security documents
    Kurze Angaben
    The chargors charge with full title guarantee by way of first fixed charge all the chargor's right title and interest from time to time in and to the related documents, all agreements, contracts, deeds, licences, undertakings, guarantees, covenants, warranties, representations and other documents, now or in the future. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited
    Transaktionen
    • 25. Jan. 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 09. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Dez. 2000
    Geliefert am 29. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 7 church terrace wisbech fenland cambridgeshire PE14 8RQ - CB187322.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A charge of securities
    Erstellt am 02. März 2000
    Geliefert am 09. März 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from arrowcroft leisure limited to the chargee under the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    The securities: two ordinary shares of £1 each in arrowcroft leisure limited and all income derived therefrom and all rights attaching thereto.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 09. März 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    A supplemental memorandum of deposit pursuant to a loan agreement dated 30TH may 1996 issued by the company
    Erstellt am 07. Juli 1999
    Geliefert am 21. Juli 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement (as amended and supplemented by a supplemental agreement of the 6TH july 1999) and/or in connection with the facility continued and/or granted thereby and/or under this supplemental memorandum of deposit or any other security document (as defined in the loan agreement as amended and supplemented by the supplemental agreement)
    Kurze Angaben
    At the request of the company it has been agreed that a second facility of up to £750.000 be added to the facility pursuant to a supplemental agreement dated 6/7/99,. see the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Depfa Deutsche Pfandbriefbank Ag
    Transaktionen
    • 21. Juli 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental mortgage
    Erstellt am 16. Aug. 1996
    Geliefert am 20. Aug. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies intended to be secured by the mortgage dated 28TH november 1979 due or to become due from the company to the chargee as varied by the deeds of variation dated 8TH august 1991, 17TH january 1992 and a deed of release dated 8TH july 1992
    Kurze Angaben
    The sum of £23,100 on deposit at bank of scotland PLC.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Royal Insurance PLC
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of deposit
    Erstellt am 31. Mai 1996
    Geliefert am 12. Juni 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan facility agreement and/or in connection with the facility thereby granted and/or under this charge or any other security documents as defined in the loan agreement
    Kurze Angaben
    First fixed charge all the company's right title and interest in and to 100 ordinary shares of £1 each in the issued share capital of the company comprising all of the issued share capital of the company and all dividends interest and other monies deriving from the shares.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Deutsche Pfandbrief-Und Hypothekenbank Ag
    Transaktionen
    • 12. Juni 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of substitution
    Erstellt am 15. Aug. 1995
    Geliefert am 16. Aug. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "principal charge" dated 28 december 1979 and as varied by various deeds (as therein defined)
    Kurze Angaben
    L/H property on the west side of acornfield road kirby knowsley merseyside t/n MS353281.
    Berechtigte Personen
    • Royal Insurance PLC
    Transaktionen
    • 16. Aug. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 03. Jan. 1995
    Geliefert am 11. Jan. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Kemley house prospect street kingston upon hull humberside t/no HS22077.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Memorandum of charge
    Erstellt am 29. Apr. 1993
    Geliefert am 13. Mai 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from central area redevelopment enterprises limited and/or arrowcroft (dominion) investments limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All stocks shares and other securities and all dividends interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Charterhouse Bank Limited
    Transaktionen
    • 13. Mai 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 1992
    Geliefert am 11. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company and arrowcroft (finland) limited to the chargee under the loan agreement and the guarantee
    Kurze Angaben
    F/H 20/22A st marks lane and 34/35A lombard street newark notts and all fixtures plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Unitas Bank LTD
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 1992
    Geliefert am 11. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company and arrowcroft (finland) limited to the chargee under the loan agreement and the guarantee
    Kurze Angaben
    Unf/h units 1-6 carrwood rd t/no.DY144521 and all fixtures fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Unitas Bank LTD
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Dez. 1992
    Geliefert am 11. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due from the company and arrowcroft (finland) limited to the chargee under the loan agreement and guarantee
    Kurze Angaben
    F/H 7-11 carrwood rd t/no. DY206439 and all fixtures plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Unitas Bank LTD
    Transaktionen
    • 11. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 04. März 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of memorandum of deposit
    Erstellt am 29. Mai 1992
    Geliefert am 08. Juni 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement and the deed
    Kurze Angaben
    The entire issued share capital of arrowcroft (UK) investments limited and all dividends and interest and all rights moneys or property accruing.
    Berechtigte Personen
    • County Natwest Limited (As Agent and Trustee for the Banks)
    Transaktionen
    • 08. Juni 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Mai 1990
    Geliefert am 23. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    1,3 & 5 coventry road market harborough leicestershire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 25. März 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Mai 1990
    Geliefert am 23. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    7, church terrace wisbech, cambridgeshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 20. Jan. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of subsitutions
    Erstellt am 27. Apr. 1990
    Geliefert am 01. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a mortgage dated 28.12.79 a deed of charge dated 3.3.82 and a deed of subsitution dated 7.12.89
    Kurze Angaben
    All that piece of parcel of land containing 4411 metres together with the building thereon forming part of the chesterfield trading estate derbyshire all that property k/a 34A lombard street and 22A st marks lane and 34/35A lombard street, newark.
    Berechtigte Personen
    • Royal Insurances PLC
    Transaktionen
    • 01. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 18. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of substitution
    Erstellt am 07. Dez. 1989
    Geliefert am 11. Dez. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a mortgage dated 28/12/79
    Kurze Angaben
    Property k/a units 1 to 6 carrwood rd chesterfield derbyshire shown edged with red in the filed plan of title no dy 144521.
    Berechtigte Personen
    • Royal Insurance Public Limited Company
    Transaktionen
    • 11. Dez. 1989Registrierung einer Belastung
    • 18. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Jan. 1989
    Geliefert am 26. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Units 22/22A st mark's lane and 34/35A lombard street new on trent staffordshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 25. März 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Dez. 1988
    Geliefert am 06. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a westmorland house 5 & 5A highgate kendal cumbria. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 06. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 28. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. März 1988
    Geliefert am 10. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    5-5A highgate kendal cumbria.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 10. März 1988Registrierung einer Belastung
    • 19. Aug. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. Jan. 1988
    Geliefert am 03. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    27 homesdale road bromley l/b of bromley t/no sgl 81127.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    • 25. März 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of substitution
    Erstellt am 31. Dez. 1986
    Geliefert am 07. Jan. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage dated 28.12.79 a deed of release dated 4.11.86 a deed of postponement dated 31.12.86
    Kurze Angaben
    Piece or parcel of land containing an area of four acres or thereabouts adjoining leverington road wisbech county of cambridge & isle of ely.
    Berechtigte Personen
    • Royal Insurance Public Limited Company
    Transaktionen
    • 07. Jan. 1987Registrierung einer Belastung
    • 18. Feb. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 10. Jan. 1985
    Geliefert am 30. Jan. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Jan. 1985Registrierung einer Belastung
    • 25. März 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0