PAISLEY 1989 PLC
Überblick
Unternehmensname | PAISLEY 1989 PLC |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Aktiengesellschaft |
Unternehmensnummer | 01340285 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von PAISLEY 1989 PLC?
- Andere Geschäftsdienstleistungsaktivitäten n.a. (82990) / Verwaltung und unterstützende Dienstleistungen
Wo befindet sich PAISLEY 1989 PLC?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Brookfield House 44-48 Davies Street W1K 5JA London |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von PAISLEY 1989 PLC?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
ARROWCROFT GROUP PLC | 28. Sept. 2010 | 28. Sept. 2010 |
CCR INVESTMENT GROUP PLC | 09. März 2009 | 09. März 2009 |
ARROWCROFT GROUP PLC | 04. Aug. 1987 | 04. Aug. 1987 |
ARROWCROFT GROUP PLC | 31. Dez. 1979 | 31. Dez. 1979 |
ARROWCROFT GROUP PLC | 31. Dez. 1979 | 31. Dez. 1979 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von PAISLEY 1989 PLC?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2013 |
Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für PAISLEY 1989 PLC?
Jahresabschluss |
|
---|
Welche sind die letzten Einreichungen für PAISLEY 1989 PLC?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed arrowcroft group PLC\certificate issued on 05/06/14 | 3 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
| ||||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 110 Park Street Mayfair London W1K 6AD am 28. März 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Stuart Neil Eppel als Sekretär am 17. März 2014 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Daniel Richard Edward Carter als Geschäftsführer am 17. März 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Jones als Sekretär am 17. März 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Alan Jones als Geschäftsführer am 17. März 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von James Lawrence Burchell als Geschäftsführer am 28. Okt. 2013 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr James Lawrence Burchell am 17. Sept. 2013 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr James Lawrence Burchell als Direktor am 17. Jan. 2013 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Leonard Cedric Eppel als Geschäftsführer am 12. Aug. 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse verlegt | 1 Seiten | AD03 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 15 Seiten | AA | ||||||||||
Gesellschaftsvertrag und Satzung | 49 Seiten | MEM/ARTS | ||||||||||
Bescheinigung über die Änderung der Firma Company name changed ccr investment group PLC\certificate issued on 28/09/10 | 2 Seiten | CERTNM | ||||||||||
| ||||||||||||
Hinweis auf Namensänderung | 2 Seiten | CONNOT | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von PAISLEY 1989 PLC?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
EPPEL, Stuart Neil | Sekretär | 44-48 Davies Street W1K 5JA London Brookfield House United Kingdom | 186049970001 | |||||||
EPPEL, Stuart Neil | Geschäftsführer | Park Street Mayfair W1K 6AD London 110 United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 36660410004 | ||||
HAI, Nicholas Paul | Geschäftsführer | 44-48 Davies Street W1K 5JA London Brookfield House United Kingdom | England | British | Chartered Surveyor | 14697390002 | ||||
JONES, Alan | Sekretär | 110 Park Street Mayfair W1K 6AD London | British | 14634220001 | ||||||
BURCHELL, James Lawrence | Geschäftsführer | 110 Park Street Mayfair W1K 6AD London | United Kingdom | British | Chief Executive | 37364960006 | ||||
CAMPBELL HORNE, Iain David | Geschäftsführer | Cato Street W1H 5JF London 17 | British | Chartered Surveyor | 73859540001 | |||||
CARTER, Daniel Richard Edward | Geschäftsführer | 110 Park Street Mayfair W1K 6AD London | England | British | Development Surveyor | 14697360004 | ||||
EPPEL, Barbara Priscilla | Geschäftsführer | Flat 1 Summit Lodge 9 Lower Terrace Hampstead NW3 6RF London | British | Company Director | 15234090003 | |||||
EPPEL, Leonard Cedric | Geschäftsführer | 110 Park Street Mayfair W1K 6AD London | British | Property Developer | 28121430001 | |||||
FOX, Christopher Paul | Geschäftsführer | 7 Larchways Appleton Park WA4 5EN Warrington Cheshire | British | Managing Director | 49798200002 | |||||
JONES, Alan | Geschäftsführer | 110 Park Street Mayfair W1K 6AD London | United Kingdom | British | Finance Director | 14634220001 | ||||
VINEY, Mark Nigel Merriam | Geschäftsführer | Plumtree Cottage Hudnall Lane HP4 1QQ Little Gaddesden Hertfordshire | British | Managing Director | 34472870001 | |||||
WHARTON, Malcolm Brian | Geschäftsführer | 43 Frewin Road SW18 3LR London | British | Company Director | 37417390001 |
Hat PAISLEY 1989 PLC Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Charge over deposit | Erstellt am 05. Juli 2007 Geliefert am 18. Juli 2007 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The deposit,. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge and assignment between the company gemstand limited arrowcroft limited and the chargee | Erstellt am 31. Jan. 2001 Geliefert am 15. Feb. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness monies obligations and liabilities of the chargors to the chargee and/or any transferee (as defined in the charge) under the terms of the facility letter and/or the guarantee documents and/or under any other security documents (all as defined) together with all expenses and interest thereon and all other present and/or future indebtedness on any account | |
Kurze Angaben The chargors charge (pursuant to the charge and assignment dated 9 january 2001 between the parties hereto) all right title and interest from time to time in and to the building contract and appointments. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge assignment dated 9TH january 2001 (the "charge") between the chargor, gemstand limited, arrowcroft limited (together the "chargors") and n m rothschild & sons limited (the "chargee") | Erstellt am 09. Jan. 2001 Geliefert am 25. Jan. 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All indebtedness, monies and obligations and liabilities due or to become due from the company and/or any chargors to the chargee and/or any transferee (as defined in the charge), arising whether directly or indirectly under the terms of the facility letter and/or in connection with the facility thereby granted and/or under the charge and/or the guarantee documents and/or under any other security documents | |
Kurze Angaben The chargors charge with full title guarantee by way of first fixed charge all the chargor's right title and interest from time to time in and to the related documents, all agreements, contracts, deeds, licences, undertakings, guarantees, covenants, warranties, representations and other documents, now or in the future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 21. Dez. 2000 Geliefert am 29. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 7 church terrace wisbech fenland cambridgeshire PE14 8RQ - CB187322. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A charge of securities | Erstellt am 02. März 2000 Geliefert am 09. März 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from arrowcroft leisure limited to the chargee under the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben The securities: two ordinary shares of £1 each in arrowcroft leisure limited and all income derived therefrom and all rights attaching thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A supplemental memorandum of deposit pursuant to a loan agreement dated 30TH may 1996 issued by the company | Erstellt am 07. Juli 1999 Geliefert am 21. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies, obligations and liabilities due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan agreement (as amended and supplemented by a supplemental agreement of the 6TH july 1999) and/or in connection with the facility continued and/or granted thereby and/or under this supplemental memorandum of deposit or any other security document (as defined in the loan agreement as amended and supplemented by the supplemental agreement) | |
Kurze Angaben At the request of the company it has been agreed that a second facility of up to £750.000 be added to the facility pursuant to a supplemental agreement dated 6/7/99,. see the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental mortgage | Erstellt am 16. Aug. 1996 Geliefert am 20. Aug. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies intended to be secured by the mortgage dated 28TH november 1979 due or to become due from the company to the chargee as varied by the deeds of variation dated 8TH august 1991, 17TH january 1992 and a deed of release dated 8TH july 1992 | |
Kurze Angaben The sum of £23,100 on deposit at bank of scotland PLC.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Memorandum of deposit | Erstellt am 31. Mai 1996 Geliefert am 12. Juni 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the loan facility agreement and/or in connection with the facility thereby granted and/or under this charge or any other security documents as defined in the loan agreement | |
Kurze Angaben First fixed charge all the company's right title and interest in and to 100 ordinary shares of £1 each in the issued share capital of the company comprising all of the issued share capital of the company and all dividends interest and other monies deriving from the shares.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of substitution | Erstellt am 15. Aug. 1995 Geliefert am 16. Aug. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the "principal charge" dated 28 december 1979 and as varied by various deeds (as therein defined) | |
Kurze Angaben L/H property on the west side of acornfield road kirby knowsley merseyside t/n MS353281. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 03. Jan. 1995 Geliefert am 11. Jan. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Kemley house prospect street kingston upon hull humberside t/no HS22077. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Memorandum of charge | Erstellt am 29. Apr. 1993 Geliefert am 13. Mai 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from central area redevelopment enterprises limited and/or arrowcroft (dominion) investments limited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All stocks shares and other securities and all dividends interest and other distributions. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Dez. 1992 Geliefert am 11. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and arrowcroft (finland) limited to the chargee under the loan agreement and the guarantee | |
Kurze Angaben F/H 20/22A st marks lane and 34/35A lombard street newark notts and all fixtures plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Dez. 1992 Geliefert am 11. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and arrowcroft (finland) limited to the chargee under the loan agreement and the guarantee | |
Kurze Angaben Unf/h units 1-6 carrwood rd t/no.DY144521 and all fixtures fixed plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. Dez. 1992 Geliefert am 11. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from the company and arrowcroft (finland) limited to the chargee under the loan agreement and guarantee | |
Kurze Angaben F/H 7-11 carrwood rd t/no. DY206439 and all fixtures plant and machinery. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of memorandum of deposit | Erstellt am 29. Mai 1992 Geliefert am 08. Juni 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the loan agreement and the deed | |
Kurze Angaben The entire issued share capital of arrowcroft (UK) investments limited and all dividends and interest and all rights moneys or property accruing. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 14. Mai 1990 Geliefert am 23. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 1,3 & 5 coventry road market harborough leicestershire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 14. Mai 1990 Geliefert am 23. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 7, church terrace wisbech, cambridgeshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of subsitutions | Erstellt am 27. Apr. 1990 Geliefert am 01. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a mortgage dated 28.12.79 a deed of charge dated 3.3.82 and a deed of subsitution dated 7.12.89 | |
Kurze Angaben All that piece of parcel of land containing 4411 metres together with the building thereon forming part of the chesterfield trading estate derbyshire all that property k/a 34A lombard street and 22A st marks lane and 34/35A lombard street, newark. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of substitution | Erstellt am 07. Dez. 1989 Geliefert am 11. Dez. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a mortgage dated 28/12/79 | |
Kurze Angaben Property k/a units 1 to 6 carrwood rd chesterfield derbyshire shown edged with red in the filed plan of title no dy 144521. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 12. Jan. 1989 Geliefert am 26. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Units 22/22A st mark's lane and 34/35A lombard street new on trent staffordshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 23. Dez. 1988 Geliefert am 06. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a westmorland house 5 & 5A highgate kendal cumbria. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 02. März 1988 Geliefert am 10. März 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 5-5A highgate kendal cumbria. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 18. Jan. 1988 Geliefert am 03. Feb. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 27 homesdale road bromley l/b of bromley t/no sgl 81127. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of substitution | Erstellt am 31. Dez. 1986 Geliefert am 07. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee supplemental to a mortgage dated 28.12.79 a deed of release dated 4.11.86 a deed of postponement dated 31.12.86 | |
Kurze Angaben Piece or parcel of land containing an area of four acres or thereabouts adjoining leverington road wisbech county of cambridge & isle of ely. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & debenture | Erstellt am 10. Jan. 1985 Geliefert am 30. Jan. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0