RUDA HOLIDAY PARK LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRUDA HOLIDAY PARK LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01347793
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RUDA HOLIDAY PARK LIMITED?

    • Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen

    Wo befindet sich RUDA HOLIDAY PARK LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RUDA HOLIDAY PARK LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    CLEAVEWOOD HOLIDAY PARK LIMITED 22. Mai 198422. Mai 1984
    MEMCASTLE LIMITED12. Jan. 197812. Jan. 1978

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RUDA HOLIDAY PARK LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2016

    Welche sind die letzten Einreichungen für RUDA HOLIDAY PARK LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    9 SeitenLIQ13

    Beendigung der Bestellung von John Anthony Waterworth als Geschäftsführer am 31. März 2019

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Michael John Wilmot als Geschäftsführer am 19. Juli 2018

    1 SeitenTM01

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    7 SeitenLIQ01

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 26. Juni 2018

    LRESSP

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    4 Seiten600

    Beendigung der Bestellung von Ian Alan Bull als Geschäftsführer am 29. Juni 2018

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Gesellschaftsvertrag und Satzung

    12 SeitenMA

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    resolution

    Beschluss zur Kapitalisierung oder Ausgabe von Gratisaktien

    That authority is hereby granted for the directors to capitalise and appropriate as capital the sum of £11,912,549 being the total amount of the company's reserves and to apply such sum in paying up in full 11,912,549 ordinary shares of £1.00 each in the capital of the company 20/12/2017
    RES14
    incorporation

    Beschluss zur Änderung der Gesellschaftervereinbarung

    RES01

    Kapitalaufstellung am 21. Dez. 2017

    • Kapital: GBP 1.00
    3 SeitenSH19

    legacy

    1 SeitenSH20

    legacy

    1 SeitenCAP-SS

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Herabsetzung des gezeichneten Kapitals

    RES06

    Kapitalaufstellung nach einer Aktienemission am 20. Dez. 2017

    • Kapital: GBP 11,922,549
    3 SeitenSH01

    Die Adresse der Registerinspektion wurde vom 3 Bunhill Row London EC1Y 8YZ England zum C/O Womble Bond Dickinson (Uk) Llp St Ann's Wharf 112 Quayside Newcastle upon Tyne NE1 3DX geändert

    1 SeitenAD02

    Register(s) wurden an die registrierte Inspektionsadresse 3 Bunhill Row London EC1Y 8YZ verlegt

    1 SeitenAD03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2016

    6 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 31. Dez. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Ernennung von Mr Ian Alan Bull als Direktor am 13. Juni 2016

    2 SeitenAP01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2015

    5 SeitenAA

    Die Adresse der Registerinspektion wurde auf 3 Bunhill Row London EC1Y 8YZ geändert

    1 SeitenAD02

    Jahresrückblick erstellt bis 31. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital05. Jan. 2016

    Kapitalaufstellung am 05. Jan. 2016

    • Kapital: GBP 10,000
    SH01

    Aktueller Abrechnungszeitraum verkürzt von 31. Jan. 2016 bis 31. Dez. 2015

    1 SeitenAA01

    Wer sind die Geschäftsführer von RUDA HOLIDAY PARK LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ARCHIBOLD, Judith Ann
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Sekretär
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    British85878920001
    NORDEN, Michael Robert
    85 Neale Street
    SR6 9EY Sunderland
    Tyne & Wear
    Sekretär
    85 Neale Street
    SR6 9EY Sunderland
    Tyne & Wear
    BritishDirector121560410001
    YATES, Jill Susan
    Summerfield Higher Park Road
    EX33 2LG Braunton
    Devon
    Sekretär
    Summerfield Higher Park Road
    EX33 2LG Braunton
    Devon
    British2449950001
    BAMSEY, Darrin
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishSales Director123369200006
    BULL, Ian Alan
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    Geschäftsführer
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    England
    EnglandBritishDirector210299090001
    MCDONNELL, Bernard Neillus
    16 Malone Valley Park
    BT9 5PZ Belfast
    County Antrim
    Geschäftsführer
    16 Malone Valley Park
    BT9 5PZ Belfast
    County Antrim
    Northern IrelandIrishDirector123369120001
    NORDEN, Michael Robert
    85 Neale Street
    SR6 9EY Sunderland
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    85 Neale Street
    SR6 9EY Sunderland
    Tyne & Wear
    EnglandBritishDirector121560410001
    WATERWORTH, John Anthony
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishDirector203710900001
    WILMOT, Michael John
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    Geschäftsführer
    2nd Floor One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    United KingdomBritishAccountant91108150004
    WILSON, Robert Graham
    8 Oaklands Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9PH Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    Geschäftsführer
    8 Oaklands Darras Hall
    Ponteland
    NE20 9PH Newcastle Upon Tyne
    Tyne And Wear
    United KingdomBritishDirector6564660002
    YATES, Jill Susan
    Summerfield Higher Park Road
    EX33 2LG Braunton
    Devon
    Geschäftsführer
    Summerfield Higher Park Road
    EX33 2LG Braunton
    Devon
    BritishCompany Director2449950001
    YATES, Paul Anthony
    Summerfield Higher Park Road
    EX33 2LG Braunton
    Devon
    Geschäftsführer
    Summerfield Higher Park Road
    EX33 2LG Braunton
    Devon
    BritishDirector2449960001

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei RUDA HOLIDAY PARK LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    United Kingdom
    06. Apr. 2016
    One Gosforth Park Way
    Gosforth Business Park
    NE12 8ET Newcastle Upon Tyne
    2nd Floor
    United Kingdom
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RegistrierungslandEngland & Wales
    RechtsgrundlageEnglish Law
    RegistrierungsortCompanies House
    Registrierungsnummer04086679
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat RUDA HOLIDAY PARK LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    A registered charge
    Erstellt am 28. März 2014
    Geliefert am 04. Apr. 2014
    Vollständig erfüllt
    Kurzbeschreibung
    Intellectual property including tm 2392814, tm 2603583, tm 2604489 & tm 2604490 please see image for details of further land (including buildings), ship, aircraft or intellectual property charged.
    Blankettverschreibung umfasst alles: Ja
    Enthält eine Negativzusicherung: Ja
    Enthält eine Blankettverschreibung: Ja
    Enthält eine Pfandverschreibung: Ja
    Berechtigte Personen
    • Ares Management Limited (In Its Capacity as Security Trustee for the Beneficiaries)
    Transaktionen
    • 04. Apr. 2014Registrierung einer Belastung (MR01)
    • 23. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Debenture
    Erstellt am 03. Mai 2006
    Geliefert am 10. Mai 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and all the other companies named in the debenture to the beneficiaries on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Crantock beach holiday park crantock beach newquay cornwall t/n CL72935,CL64619,CL58334 holywell bay holiday park holywell bay newquay cornwall t/n CL163998 and CL146183 st minver holiday park nr rock wadebridge cornwall t/n CL167364 for details of further properties charged please refer to form 395 equitable mortgage the investments in each and all of the occupational leases any hedging agreement all fixtures and fittings the accounts all monies uncalled capital floating charge all the assets property and undertaking. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC as Security Trustee
    Transaktionen
    • 10. Mai 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 13. Nov. 2015Erfüllung einer Belastung (MR04)
    Composite debenture and guarantee
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 28. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from parkdean holidays limited to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Paul Anthony Yates and Jill Susan Yates
    Transaktionen
    • 28. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 15. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 15. März 2002
    Geliefert am 21. März 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from teach obligor to each finance party under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The property at ruda holiday park devon. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • N M Rothschild & Sons Limited (As Agent and Trustee for Itself and Each Ofthe Other Finance Parties (the Security Trustee))
    Transaktionen
    • 21. März 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. März 2005Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Feb. 1997
    Geliefert am 20. Feb. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Premises k/a the byron complex croyde bay croyde devon (f/h) with the benefit of all rights licences guarantees, any goodwill of any business, any rental and all other payments. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Feb. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 26. Feb. 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. März 1996
    Geliefert am 03. Apr. 1996
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The beach & 8 apartments off moor lane croyde bay north devon and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Apr. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 13. Nov. 1995
    Geliefert am 24. Nov. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Foreshore to the north and south of croyde bay beach croyde north devon. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Nov. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Okt. 1995
    Geliefert am 04. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Croyde bay holiday park croyde bay north devon. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 21. Feb. 1995
    Geliefert am 11. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a 6.51 acres approx off moor lane croyde north devon. Together with all fixtures and fittings now or at any time hereafter on the property. The benefits of all rights licences and the goodwill of the mortgagor in relation to the business from time to time carried on at the property.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge
    Erstellt am 21. Feb. 1995
    Geliefert am 25. Feb. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed charge on all goodwill and uncalled capital for the time being of the company; and all patents patent applications inventions trade marks trade names etc.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Chattels mortgage
    Erstellt am 02. Dez. 1991
    Geliefert am 05. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Details of static caravans* 24 bk brookwood 28' x 10' 1989 40 bk brookwood 30' x 10' 1988 23 bk brookwood 30' x 10' 1987 7 bluebird cardinal 35' x 10' 1987 17 bluebird cardinal 35' x 10' 1989.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Dez. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 08. Jan. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    • 06. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 28. Jan. 1990
    Geliefert am 13. Feb. 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold property k/as ruda holiday park, croyde, georgeham, north devon.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Feb. 1990Registrierung einer Belastung
    • 06. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Juli 1986
    Geliefert am 09. Aug. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H lands hereditaments and premises being dwellinghouse k/a summerfield higher park road, braunton, devon.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. Aug. 1986Registrierung einer Belastung
    • 06. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of consent of charge
    Erstellt am 20. Mai 1986
    Geliefert am 23. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 24.4.86
    Kurze Angaben
    All the estate and interest and all the rights present and future of the company in and over cleavenwood holiday park, woolacombe north devon. And the proceeds of sale thereof.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 23. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    • 11. Jan. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 22. Apr. 1986
    Geliefert am 28. Apr. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including book debts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 28. Apr. 1986Registrierung einer Belastung
    • 06. Nov. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat RUDA HOLIDAY PARK LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    26. Juni 2018Beginn der Liquidation
    30. Aug. 2019Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Emma Cray
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Toby Scott Underwood
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    Central Square 29 Wellington Street
    LS1 4DL Leeds
    West Yorkshire

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0