GALLERY COSMETICS LIMITED
Überblick
Unternehmensname | GALLERY COSMETICS LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01351893 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GALLERY COSMETICS LIMITED?
- Herstellung von pharmazeutischen Grundstoffen (21100) / Verarbeitendes Gewerbe
Wo befindet sich GALLERY COSMETICS LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Cms Business Park Station Lane WF7 6EQ Featherstone West Yorkshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GALLERY COSMETICS LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2014 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GALLERY COSMETICS LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2014 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2013 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2012 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tracey Craik als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * the Gables Goostrey Lane Twemlow Green Holmes Chapel Cheshire CW4 8BH United Kingdom* am 19. Dez. 2012 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Ian Wade Cushnie als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Ian Wade Cushie als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tracey Craik als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Tracey Craik als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2011 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 16. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Miss Tracey Anne Craik am 01. Okt. 2009 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 2 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288c | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GALLERY COSMETICS LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CUSHIE, Ian Wade | Sekretär | Katrina Grove WF7 5NT Featherstone 202 West Yorkshire United Kingdom | British | 172849640001 | ||||||
CUSHNIE, Ian Wade | Geschäftsführer | Katrina Grove WF7 5NT Featherstone 202 West Yorkshire United Kingdom | England | British | None | 64559910001 | ||||
CRAIK, Tracey Anne | Sekretär | La Manga Club Los Belones 30389 Cartagena Villa 182 Murcia Spain | British | Company Director | 134905070002 | |||||
CRAIK, Tracey Ann | Sekretär | The Goodman Suite Vale Royal Drive Whitegate CW8 2BA Northwich Apartment 12 Cheshire | British | Company Director | 133854440003 | |||||
HEYES, Winifred Mary | Sekretär | Alum Court Holmes Chapel CW4 7PJ Crewe 22 Cheshire United Kingdom | British | 56380510002 | ||||||
MCGEAGH, John Alexander | Sekretär | 12 Cedar Road M33 5NW Sale Cheshire | British | 4596880001 | ||||||
NUTTALL, Anthony Frank | Sekretär | 3 Spring Rise High Crompton Shaw OL2 7QB Oldham Lancashire Uk | British | 64957010001 | ||||||
RAYSON, John William | Sekretär | 1 Turncliffe Crescent SK6 6JP Marple Cheshire | British | Accountant | 76725260001 | |||||
COMER, Paul Francis | Geschäftsführer | 4 Broadwalk SK9 5PJ Wilmslow Cheshire Uk | British | Company Director | 64957000001 | |||||
CRAIK, Tracey Anne | Geschäftsführer | La Manga Club Los Belones 30389 Cartagena Villa 182 Murcia Spain | Spain | British | Company Director | 134905070002 | ||||
EASTWOOD, Jill | Geschäftsführer | 4 The Towers Pavilion Way SK10 3LT Macclesfield Cheshire | British | Company Director | 94177810004 | |||||
MCGEAGH, John Alexander | Geschäftsführer | 12 Cedar Road M33 5NW Sale Cheshire | British | Accountant | 4596880001 | |||||
MEHTA, Rabinder Nath | Geschäftsführer | 31 Brambling Way Lowton WA3 2GS Warrington Cheshire | British | Merchant | 17912910001 | |||||
SHENTON, Daniel Michael | Geschäftsführer | 11 Woodland Close Chelford SK11 9BZ Macclesfield Cheshire | British | Company Director | 6511710001 | |||||
WRIGHT, Bernard | Geschäftsführer | Wood Place Woodside Aspley Guise MK17 8ER Milton Keynes Bedfordshire | United Kingdom | British | Company Director | 58580560001 |
Hat GALLERY COSMETICS LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Guarantee & debenture | Erstellt am 20. Juli 1999 Geliefert am 28. Juli 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or liberty cosmeticslimited to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 11. Aug. 1998 Geliefert am 19. Aug. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Equitable charge | Erstellt am 24. März 1997 Geliefert am 09. Apr. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £75,000 due or to become due from the company to the chargee as documented in a letter dated 24TH march 1997 as subsequently supplemented by a letter of 26TH march 1997 (together the "finance documents") | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and assets and revenues present and future. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Fixed charge on discounted debts and a floating charge on the receipts of other debts | Erstellt am 26. Feb. 1997 Geliefert am 01. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed equitable charge over all debts the subject of an invoice discounting agreement that fail to vest and all rights/other amounts thereon; floating charge over monies received in respect of the said amounts. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 29. Juni 1994 Geliefert am 01. Juli 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. März 1991 Geliefert am 10. Apr. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a guarantee dated 22ND march 1991 | |
Kurze Angaben (See doc 395 tc ref M38L for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 22. März 1991 Geliefert am 26. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a gaueny house, haig road, parkgate industrial estate knutsford cheshire. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 22. März 1991 Geliefert am 26. März 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 29. Apr. 1988 Geliefert am 17. Mai 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £500,000 due from the company to the chargee under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Office & warehouse premises at haig road, knutsford, cheshire by way of specific equitable charge all estate/unterest in any f/h or l/h property. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 03. Okt. 1985 Geliefert am 04. Okt. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Inc: all heritable property and assets in scotland (please see doc M20).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0