HUWS-GRAY (FFLINT) LTD

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHUWS-GRAY (FFLINT) LTD
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01353756
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HUWS-GRAY (FFLINT) LTD?

    • (7499) /

    Wo befindet sich HUWS-GRAY (FFLINT) LTD?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    68 Argyle Street
    Birkenhead
    CH41 6AF Merseyside
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HUWS-GRAY (FFLINT) LTD?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    ABER BUILDING SUPPLIES LIMITED20. Feb. 197820. Feb. 1978

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HUWS-GRAY (FFLINT) LTD?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2009

    Welche sind die letzten Einreichungen für HUWS-GRAY (FFLINT) LTD?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    5 SeitenDS01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 14. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital25. Mai 2010

    Kapitalaufstellung am 25. Mai 2010

    • Kapital: GBP 100
    SH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Terence Owen am 14. Mai 2010

    2 SeitenCH01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    5 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    legacy

    2 Seiten288c

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2007

    5 SeitenAA

    legacy

    4 Seiten363a

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2006

    5 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    1 Seiten288c

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2005

    5 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2004

    6 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten363a

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2003

    6 SeitenAA

    legacy

    7 Seiten363s

    Jahresabschluss für ein kleines Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2002

    7 SeitenAA

    legacy

    2 Seiten288a

    legacy

    2 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von HUWS-GRAY (FFLINT) LTD?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    OWEN, Terence
    7 Cwr Y Coed
    LL77 7JG Llangefni
    Gwynedd
    Sekretär
    7 Cwr Y Coed
    LL77 7JG Llangefni
    Gwynedd
    British122564390001
    WAGSTAFF, Andrew Thomas
    Kinder
    Rhosybol
    LL68 9TS Amlwch
    Gwynedd
    Sekretär
    Kinder
    Rhosybol
    LL68 9TS Amlwch
    Gwynedd
    British73122860002
    JONES, John Llewelyn
    Cilmeri
    Yr Ala
    LL53 5BL Pwllheli
    Gwynedd
    Geschäftsführer
    Cilmeri
    Yr Ala
    LL53 5BL Pwllheli
    Gwynedd
    WalesWelsh38012960001
    OWEN, Terence
    7 Cwr Y Coed
    LL77 7JG Llangefni
    Gwynedd
    Geschäftsführer
    7 Cwr Y Coed
    LL77 7JG Llangefni
    Gwynedd
    United KingdomBritish122564390001
    BARNETT, Richard Edward
    2 The Cottages Bron-Y-Wendon
    Llanddulas
    LL22 8HG Abergele
    Clwyd
    Sekretär
    2 The Cottages Bron-Y-Wendon
    Llanddulas
    LL22 8HG Abergele
    Clwyd
    British12688990001
    BEDFORD, Philip Gordon
    401 Chester Road
    Oakenholt
    CH6 5SF Flint
    Clwyd
    Sekretär
    401 Chester Road
    Oakenholt
    CH6 5SF Flint
    Clwyd
    British74841490001
    DEAKIN, Paul
    15 Llys Argoed
    Mynydd Isa
    CH7 6TX Mold
    Clwyd
    Sekretär
    15 Llys Argoed
    Mynydd Isa
    CH7 6TX Mold
    Clwyd
    British44716540001
    HOPKINS, Jill
    Leabank Halkyn Road
    CH6 5HT Flint
    Clwyd
    Sekretär
    Leabank Halkyn Road
    CH6 5HT Flint
    Clwyd
    British42019390001
    KENDRICK, John Edward
    5 Yeoford Drive
    WA14 4UP Altrincham
    Cheshire
    Sekretär
    5 Yeoford Drive
    WA14 4UP Altrincham
    Cheshire
    British37891720001
    WILLIAMS, David Simon
    10 Ambleside Close
    Bromborough
    L62 7JF Wirral
    Merseyside
    Sekretär
    10 Ambleside Close
    Bromborough
    L62 7JF Wirral
    Merseyside
    British35433860001
    BARNETT, Richard Edward
    2 The Cottages Bron-Y-Wendon
    Llanddulas
    LL22 8HG Abergele
    Clwyd
    Geschäftsführer
    2 The Cottages Bron-Y-Wendon
    Llanddulas
    LL22 8HG Abergele
    Clwyd
    British12688990001
    BEDFORD, Philip Gordon
    401 Chester Road
    Oakenholt
    CH6 5SF Flint
    Clwyd
    Geschäftsführer
    401 Chester Road
    Oakenholt
    CH6 5SF Flint
    Clwyd
    British74841490001
    FOSTER, William Roy
    The Firs Mold Road
    Northop
    CH7 6BX Mold
    Clwyd
    Geschäftsführer
    The Firs Mold Road
    Northop
    CH7 6BX Mold
    Clwyd
    British46891140001
    HOPKINS, Jill
    Leabank Halkyn Road
    CH6 5HT Flint
    Clwyd
    Geschäftsführer
    Leabank Halkyn Road
    CH6 5HT Flint
    Clwyd
    British42019390001
    HOPKINS, William David
    Leabank
    Halkyn Road
    CH6 5HT Flint
    Clwyd
    Geschäftsführer
    Leabank
    Halkyn Road
    CH6 5HT Flint
    Clwyd
    British12689000001
    WILLIAMS, David Simon
    10 Ambleside Close
    Bromborough
    L62 7JF Wirral
    Merseyside
    Geschäftsführer
    10 Ambleside Close
    Bromborough
    L62 7JF Wirral
    Merseyside
    British35433860001

    Hat HUWS-GRAY (FFLINT) LTD Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 28. Juni 2000
    Geliefert am 30. Juni 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The property at lease of land and buildings on the south side of holywell road,flint,flintshire.. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Juni 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 17. Mai 2000
    Geliefert am 19. Mai 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from huws gray fitlock limited to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The lease of land and buildings on the south side of holywell road flint flintshire. With the benefit of all rights licences guarantees rent deposits contracts deeds undertakings and warranties relating. To the property any shares or membership rights in any management company for the property any goodwill of any business from time to time carried on at the property any rental and other money payable under any lease licence or other interest created in respect of the property and all other payments whatever in respect of the property.
    Berechtigte Personen
    • Hsbc Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Mai 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Feb. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Fixed charge on discounted debts and a floating charge on the receipts of other debts
    Erstellt am 22. Mai 1997
    Geliefert am 07. Juni 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee whether arising under an invoice discounting agreement (as therein defined) or otherwise
    Kurze Angaben
    Fixed equitable charge (I) all debts the subject of an invoice discounting agreement between the company and the chargee that fail to vest in the chargee and all rights in favour of the company related to such debts and (ii) all other amounts owing and all rights relating to such amounts, floating charge such of the moneys received in respect of amounts referred to in (ii) above as shall stand released from the fixed equitable charge.
    Berechtigte Personen
    • Confidential Invoice Discounting Limited
    Transaktionen
    • 07. Juni 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 08. Okt. 1996
    Geliefert am 26. Okt. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £150,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 8TH october 1996
    Kurze Angaben
    Floating charge over all the undertaking property both present and future including uncalled caputal of the company. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Huws Gray Limited
    Transaktionen
    • 26. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 08. Okt. 1996
    Geliefert am 11. Okt. 1996
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £89,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a facility agreement dated 8TH october 1996
    Kurze Angaben
    Floating charge over all the undertaking and property both present and future including uncalled capital of the company.. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • John Llewelyn Jones
    Transaktionen
    • 11. Okt. 1996Registrierung einer Belastung (395)
    Fixed and floating charge
    Erstellt am 30. Jan. 1995
    Geliefert am 03. Feb. 1995
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital goodwill bookdebts and patents.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 03. Feb. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 14. Feb. 1994
    Geliefert am 25. Feb. 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at holywell road flint clwyd t/n WA607369.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Feb. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 10. Nov. 1992
    Geliefert am 26. Nov. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See doc ref M524C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 03. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Further guarantee & debenture
    Erstellt am 13. Sept. 1984
    Geliefert am 24. Sept. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All that property undertaking and assets charges by the principal deed and further deed.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Sept. 1984Registrierung einer Belastung
    • 03. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 31. Okt. 1979
    Geliefert am 12. Nov. 1979
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land & buildings adjoining aber road & holywell road, flint, clwyd.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Nov. 1979Registrierung einer Belastung
    • 14. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 30. Juni 1978
    Geliefert am 13. Juli 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charges on the undertaking and all property and assets present and future including goodwill & bookdebts uncalled capital, with all buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 13. Juli 1978Registrierung einer Belastung
    • 03. Feb. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0