STANNARD HOMES LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSTANNARD HOMES LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01359469
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von STANNARD HOMES LIMITED?

    • (7011) /
    • (7020) /

    Wo befindet sich STANNARD HOMES LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von STANNARD HOMES LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    GRAPHIC LINK LIMITED11. Sept. 199111. Sept. 1991
    CFH SERVICE FORMS LIMITED03. Feb. 198703. Feb. 1987
    SERVICE COMPUTER FORMS LIMITED31. Dez. 197831. Dez. 1978
    ALBANWORTH LIMITED22. März 197822. März 1978

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von STANNARD HOMES LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2007

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für STANNARD HOMES LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für STANNARD HOMES LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. März 2016

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gläubigerliquidation

    16 Seiten4.72

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Sept. 2015

    21 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 03. Sept. 2015

    5 Seiten4.68

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order INSOLVENCY:re block transfer replacement of liq
    19 SeitenLIQ MISC OC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 04. Sept. 2014

    27 Seiten2.24B

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Mitteilung über den Übergang vom Verwaltungsfall zur freiwilligen Liquidation der Gläubiger

    1 Seiten2.34B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. März 2014

    26 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Sept. 2013

    28 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. März 2013

    28 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Sept. 2012

    24 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. März 2012

    23 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Sept. 2011

    25 Seiten2.24B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    1 Seiten2.31B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. März 2011

    18 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. Sept. 2010

    17 Seiten2.24B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 11. März 2010

    17 Seiten2.24B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Mcr Corporate Restructuring 11 St James Square Manchester M2 6DN am 29. Juni 2010

    2 SeitenAD01

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    23 Seiten2.31B

    Mitteilung über die Verlängerung des Zeitraums der Verwaltung

    23 Seiten2.31B

    Wer sind die Geschäftsführer von STANNARD HOMES LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    STANNARD, Justin Paul
    Dawes Bank
    Holcombe Old Road
    BL8 4NQ Holcombe
    Lancashire
    Sekretär
    Dawes Bank
    Holcombe Old Road
    BL8 4NQ Holcombe
    Lancashire
    BritishCompany Director55915870005
    STANNARD, Justin Paul
    Dawes Bank
    Holcombe Old Road
    BL8 4NQ Holcombe
    Lancashire
    Geschäftsführer
    Dawes Bank
    Holcombe Old Road
    BL8 4NQ Holcombe
    Lancashire
    BritishCompany Director55915870005
    STANNARD, Michael Johnson
    89 The Bowls
    Vicarage Lane
    IG7 6ND Chigwell
    Essex
    Geschäftsführer
    89 The Bowls
    Vicarage Lane
    IG7 6ND Chigwell
    Essex
    EnglandBritishCompany Director3993320002
    MAY, David John
    35 Claverton Road
    Saltford
    BS31 3DW Bristol
    Sekretär
    35 Claverton Road
    Saltford
    BS31 3DW Bristol
    British59947700001
    THRELFALL, Christopher Richard
    54 Kings Road
    RG45 7BG Crowthorne
    Berkshire
    Sekretär
    54 Kings Road
    RG45 7BG Crowthorne
    Berkshire
    English42981470001
    WHITTAKER, Colin
    Coeur Joyeux La Rue Des Sapins
    St Peter
    JE3 7AD Jersey
    Sekretär
    Coeur Joyeux La Rue Des Sapins
    St Peter
    JE3 7AD Jersey
    British62179640001
    BROADWAY, Geoffrey Thomas
    Firbank Primrose Terrace
    Midsomer Norton
    BA3 2UF Bath
    Somerset
    Geschäftsführer
    Firbank Primrose Terrace
    Midsomer Norton
    BA3 2UF Bath
    Somerset
    United KingdomBritishCompany Chairman7270060003
    MASTERS, Jonathan Patrick
    18 Cavendish Road
    Henleaze
    BS9 4DZ Bristol
    Avon
    Geschäftsführer
    18 Cavendish Road
    Henleaze
    BS9 4DZ Bristol
    Avon
    United KingdomBritishFinancial Director17532350002
    MAY, David John
    35 Claverton Road
    Saltford
    BS31 3DW Bristol
    Geschäftsführer
    35 Claverton Road
    Saltford
    BS31 3DW Bristol
    BritishAccountant59947700001
    POTTER, Terence Sefton
    Temple Court
    Cathedral Road
    CF11 9HA Cardiff
    Geschäftsführer
    Temple Court
    Cathedral Road
    CF11 9HA Cardiff
    WalesBritishLtd Company92613690001
    THRELFALL, Christopher Richard
    54 Kings Road
    RG45 7BG Crowthorne
    Berkshire
    Geschäftsführer
    54 Kings Road
    RG45 7BG Crowthorne
    Berkshire
    EnglandEnglishDirector42981470001

    Hat STANNARD HOMES LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Charge legal charge
    Erstellt am 10. Juli 2008
    Geliefert am 15. Juli 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £400,000.00 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H property being 35 bromwich street bolton t/n LA350047 together with all incumberances l/hproperty k/a 39 bromwich street bolton t/n LA147851 together with all incumbrances see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Mjs Properties Limited
    Transaktionen
    • 15. Juli 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 12. Feb. 2008
    Geliefert am 26. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    56 laith street burnley lancashire, 11 laithe street burnley lancashire, 140 healey wood road burnley lancashire, see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Oakbridge Financial Services PLC
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 12. Feb. 2008
    Geliefert am 26. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details.
    Berechtigte Personen
    • Oakbridge Financial Services PLC
    Transaktionen
    • 26. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Jan. 2008
    Geliefert am 08. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    225 leigh road westhoughton bolton.
    Berechtigte Personen
    • Oakbridge Financial Services PLC
    Transaktionen
    • 08. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 25. Jan. 2008
    Geliefert am 05. Feb. 2008
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    £155,000.00 and all other monies due or to become due
    Kurze Angaben
    Fixed charge over all property present and future, including uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant and machinery, bookdebts, goodwill. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Oakbridge Financial Services PLC
    Transaktionen
    • 05. Feb. 2008Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Mai 2007
    Geliefert am 01. Juni 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a kinghorne building, halifax road, todmorden t/no WYK528264. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Juni 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Mai 2007
    Geliefert am 26. Mai 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a the flying horseshoe hotel station road clapham t/no NYK244163. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 26. Mai 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 02. Feb. 2007
    Geliefert am 15. Feb. 2007
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    941 walmsley road, ramsbottom, lancashire t/n LA175294. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Feb. 2007Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 08. Aug. 2006
    Geliefert am 11. Aug. 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Property k/a 14 halstead street burnley t/no LA707953. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 11. Aug. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Juni 2006
    Geliefert am 01. Juli 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a cottage and barns at higher cleggswood farm, hollingsworth road, littleborough, rochdale. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 01. Juli 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Debenture
    Erstellt am 19. Juni 2006
    Geliefert am 24. Juni 2006
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 24. Juni 2006Registrierung einer Belastung (395)
    Deed of assignment by way of charge of rental income
    Erstellt am 29. März 2005
    Geliefert am 11. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and each and every one of its subsidiary companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The assigned rights being all the rights, titles, benefits and interests to all monies under the leases. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal and general charge
    Erstellt am 29. März 2005
    Geliefert am 11. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and each and every one of its subsidiary companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises at 39 bromwich street, bolton, greater manchester t/no LA147851, uncalled capital, book debts, undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal and general charge
    Erstellt am 29. März 2005
    Geliefert am 11. Apr. 2005
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee and each and every one of its subsidiary companies on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H premises at 35 bromwich street bolton greater manchester t/no LA350047, uncalled capital, book debts, undertaking and assets. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Abbey National PLC
    Transaktionen
    • 11. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juni 2004
    Geliefert am 17. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    37 bromwich street bolton t/no LA354421.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juni 2004
    Geliefert am 17. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    41 bromwich street bolton t/no GM583941.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juni 2004
    Geliefert am 17. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    10 bromwich street bolton t/no 325051.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 11. Juni 2004
    Geliefert am 17. Juni 2004
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    22 bromwich street bolton t/no GM50104.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 17. Juni 2004Registrierung einer Belastung (395)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 06. Nov. 1991
    Geliefert am 12. Nov. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Nov. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 16. Dez. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 28. Apr. 1986
    Geliefert am 07. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge all f/h & l/h properties and the proceeds of sale thereof. Fixed & floaring charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 07. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    • 16. Dez. 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Corporate mortgage
    Erstellt am 21. März 1984
    Geliefert am 27. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 9.3.84
    Kurze Angaben
    The goods (as described) the benefit of all contracts, conditions warranties and agreements pertaining thereto. All logbooks, maintenance records, record books handbooks and other documents relating to the goods. The benefit of all insurances - force in relation to the mortgaged property. Any moneys payable to the co. In connection with sale of proposed sale of any of the goods. One john morgan, 2 unit printing press serial no. 8408QR.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. März 1984Registrierung einer Belastung
    Debenture
    Erstellt am 21. März 1984
    Geliefert am 27. März 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a facility letter dated 9/3/84
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 27. März 1984Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 24. Nov. 1982
    Geliefert am 30. Nov. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including book & other debts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1982Registrierung einer Belastung

    Hat STANNARD HOMES LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    12. Sept. 2008Beginn der Verwaltung
    04. Sept. 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Whitehouse
    11 St James Square
    M2 6WH Manchester
    Praktiker
    11 St James Square
    M2 6WH Manchester
    Steven Muncaster
    11 St James Square
    M2 6DN Manchester
    Praktiker
    11 St James Square
    M2 6DN Manchester
    2
    DatumTyp
    04. Sept. 2014Beginn der Liquidation
    30. Juni 2016Aufgelöst am
    Gläubiger-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    David John Whitehouse
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    Praktiker
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    Steven Muncaster
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EQ Manchester
    Praktiker
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EQ Manchester
    Steven Muncaster
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Vorgeschlagener Liquidator
    The Chancery
    58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    David John Whitehouse
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    Vorgeschlagener Liquidator
    The Chancery, 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    England
    Sarah Helen Bell
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester
    Praktiker
    The Chancery 58 Spring Gardens
    M2 1EW Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0