COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01359521 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Countryside House The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Essex |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| COUNTRYSIDE BUILD (SOUTHERN) LIMITED | 31. Dez. 1978 | 31. Dez. 1978 |
| MADMILD LIMITED | 23. März 1978 | 23. März 1978 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Sept. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Gary Neville Whitaker am 02. Aug. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2018 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael Ian Scott am 04. Feb. 2019 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2017 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Graham Stewart Cherry als Geschäftsführer am 30. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Gary Neville Whitaker als Direktor am 01. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael Ian Scott als Direktor am 01. Okt. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard Stephen Cherry als Geschäftsführer am 30. Sept. 2017 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Sept. 2016 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 28. März 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2014 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Richard Stephen Cherry am 23. Sept. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2013 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 28. März 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Sept. 2012 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | MG02 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WARREN, Tracy Marina | Sekretär | Hollow Road Felsted CM6 3JF Dunmow The Molehill Essex United Kingdom | British | 132463120001 | ||||||
| SCOTT, Michael Ian | Geschäftsführer | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex | United Kingdom | British | 290228130001 | |||||
| WHITAKER, Gary Neville | Geschäftsführer | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex | United Kingdom | British | 238965410002 | |||||
| HOYLES, Robin Patrick | Sekretär | 12 Springpark Drive BR3 6QD Beckenham Kent | British | 34860250001 | ||||||
| PEARCE, Michael Frank | Sekretär | Ashdale 18 Longaford Way Hutton Mount CM13 2LT Brentwood Essex | British | 33032910001 | ||||||
| SHILLINGLAW, Gary Preston | Sekretär | Wynsdale 9 Monkshanger GU9 8BU Farnham Surrey | British | 66825690001 | ||||||
| CHERRY, Alan Herbert | Geschäftsführer | Harvesters Green Street Fryerning CM4 ONS Ingatestone Essex | England | British | 2026150001 | |||||
| CHERRY, Graham Stewart | Geschäftsführer | Fridays Fox Road Mashbury CM1 4TJ Chelmsford Essex | England | British | 7228590002 | |||||
| CHERRY, Richard Stephen | Geschäftsführer | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House Essex | United Kingdom | British | 68733260003 | |||||
| PEARCE, Michael Frank | Geschäftsführer | Ashdale 18 Longaford Way Hutton Mount CM13 2LT Brentwood Essex | England | British | 33032910001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Countryside Properties (Uk) Limited | 06. Apr. 2016 | The Drive Great Warley CM13 3AT Brentwood Countryside House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat COUNTRYSIDE COMMERCIAL & INDUSTRIAL PROPERTIES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Legal mortgage | Erstellt am 31. Jan. 1995 Geliefert am 21. Feb. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or countryside properties PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land at prospect royal edinburgh way harlow essex and the proceeds of sale thereof and goodwill of the company in connection of any business or businesses carried on at the property. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 14. Juni 1993 Geliefert am 25. Juni 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property 19-37 (odd numbers only) goods station yard tunbridge wells and the proceeds of sale thereof, title no:- K678728 and an assignment of the goodwill and connection of any business,together with the full benefit of all licences.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Okt. 1989 Geliefert am 20. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of any facility letter or other agreement or agreements (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 03. Okt. 1989 Geliefert am 11. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H land with the buildings erected thereon or on some part or parts thereof situate at and fronting goods station road, and belgrave road, tunbridge wells, county of kent. K/a 19/37 (odd nos) goods station road, tunbridge wells, kent. T/n:- K607298. Together with. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Mai 1986 Geliefert am 20. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or countryside properties public limited to the chargee on any account whtsoever. | |
Kurze Angaben F/H land on the east side of oakhill road savenoaks, kent. Part of title no:- K470174. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Mai 1986 Geliefert am 20. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or countryside properties public limited to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben F/H land on the east side of oakhill road sevenoaks, kent, title no:- k 470174 (part of). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Apr. 1985 Geliefert am 30. Apr. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or countryside properties public limited to the chargee on any account whatsover. | |
Kurze Angaben Land and buildings known as 16A st. Johns road tunbridge wells kent title no. K 484471. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 18. März 1985 Geliefert am 26. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the and/or countryside properties public limited company to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben 20 st john's road, tunbridge wells, kent title no. K 484471. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 02. Nov. 1984 Geliefert am 20. Nov. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the countryside properties public limited company to the chargee on any account whatsoever. | |
Kurze Angaben 33 & 35 eleanor cross road, waltham cross, broxbourne, hertfordshire title no. Hd 153666 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 02. Nov. 1984 Geliefert am 09. Nov. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from countryside properties PLC on any account whatsoever and from the company under the terms of the charge | |
Kurze Angaben F/H land on the southside of st james road brentwood, essex. Title no ex 262151. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 08. Apr. 1981 Geliefert am 21. Apr. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H 94 the heights,foxgrove rd.,beckenham borough of bramley title no.sgl 56991. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 24. Juli 1980 Geliefert am 28. Juli 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at the rear of birling road, tunbridge wells kent. (Nos 23-30 birling rd.) Title no. K 498489. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Sept. 1978 Geliefert am 02. Okt. 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land adjoining 14 castle street ongar essex. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0