ROBERT WOODHEAD LIMITED
Überblick
Unternehmensname | ROBERT WOODHEAD LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Liquidation |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01360957 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ROBERT WOODHEAD LIMITED?
- Bau von Geschäftsgebäuden (41201) / Bauwesen
- Bau von Wohngebäuden (41202) / Bauwesen
- Bestattungsdienste und verwandte Tätigkeiten (96030) / Sonstige Dienstleistungsbereiche
Wo befindet sich ROBERT WOODHEAD LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Rivermead House 7 Lewis Court Grove Park LE19 1SD Enderby Leicestershire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ROBERT WOODHEAD LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
BOOTONE LIMITED | 03. Apr. 1978 | 03. Apr. 1978 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ROBERT WOODHEAD LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Nächster Jahresabschluss | |
Ende des nächsten Geschäftsjahres am | 04. Nov. 2022 |
Fälligkeit des nächsten Jahresabschlusses am | 04. Aug. 2023 |
Letzter Jahresabschluss | |
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2021 |
Wie lautet der Status der letzten Bestätigung für ROBERT WOODHEAD LIMITED?
Überfällig | Ja |
---|---|
Letzte Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Juli 2023 |
Fälligkeit der nächsten Bescheinigung | 04. Aug. 2023 |
Letzte Bestätigungsbescheinigung | |
Nächste Bestätigungsbescheinigung erstellt bis | 21. Juli 2022 |
Überfällig | Ja |
Welche sind die letzten Einreichungen für ROBERT WOODHEAD LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Okt. 2024 | 21 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 17. Okt. 2023 | 24 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Änderung der Zusammensetzung des Gläubiger- oder Liquidationsausschusses | 11 Seiten | COM2 | ||||||||||
Vermögensübersicht | 19 Seiten | LIQ02 | ||||||||||
Gründung eines Gläubiger- oder Liquidationsausschusses | 7 Seiten | COM1 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Edwinstowe House High Street Edwinstowe Mansfield Nottinghamshire NG21 9PR zum Rivermead House 7 Lewis Court Grove Park Enderby Leicestershire LE19 1SD am 09. Nov. 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erfüllung der Belastung 013609570018 vollständig | 4 Seiten | MR04 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juli 2022 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Paul Woodhead am 01. Aug. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Hilary Ailsa Cheshire am 07. Juli 2022 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2021 | 28 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr David Paul Woodhead am 01. Dez. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Hilary Ailsa Cheshire am 01. Dez. 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2020 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 21. Juli 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 14. Jan. 2021 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Samantha Jane Sargent am 18. Dez. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Okt. 2019 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr David Paul Woodhead als Direktor am 01. Juli 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Hilary Ailsa Cheshire am 01. Juli 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von David Paul Woodhead als Geschäftsführer am 01. Juli 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Janine Borderick am 14. Feb. 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Craig Daniel Pygall als Geschäftsführer am 07. Mai 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ROBERT WOODHEAD LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
CHESHIRE, Hilary Ailsa | Sekretär | High Street Edwinstowe NG21 9PR Mansfield Edwinstowe House Nottinghamshire United Kingdom | British | 5758820002 | ||||||
BORDERICK, Janine | Geschäftsführer | 7 Lewis Court Grove Park LE19 1SD Enderby Rivermead House Leicestershire | England | British | People Development Director | 256364810002 | ||||
CHESHIRE, Hilary Ailsa | Geschäftsführer | 7 Lewis Court Grove Park LE19 1SD Enderby Rivermead House Leicestershire | England | British | Non Executive Director | 5758820004 | ||||
SARGENT, Samantha Jane | Geschäftsführer | 7 Lewis Court Grove Park LE19 1SD Enderby Rivermead House Leicestershire | United Kingdom | British | Finance Director | 268611220002 | ||||
SLATER, Glenn Simon | Geschäftsführer | 7 Lewis Court Grove Park LE19 1SD Enderby Rivermead House Leicestershire | England | British | Chief Visionary Officer | 132542000001 | ||||
WESTWOOD, Teresa Anne | Geschäftsführer | 7 Lewis Court Grove Park LE19 1SD Enderby Rivermead House Leicestershire | England | British | Managing Director | 193150140002 | ||||
WOODHEAD, David Paul | Geschäftsführer | 7 Lewis Court Grove Park LE19 1SD Enderby Rivermead House Leicestershire | England | British | Non Executive Director | 6175230007 | ||||
WOODHEAD, Leo Robert | Geschäftsführer | High Street Edwinstowe NG21 9PR Mansfield Edwinstowe House Nottinghamshire | United Kingdom | British | Business Development Director | 249042800001 | ||||
WOODHEAD, Thomas Philip | Geschäftsführer | 7 Lewis Court Grove Park LE19 1SD Enderby Rivermead House Leicestershire | England | British | Business Services Director | 238409860001 | ||||
GRIBBY, Stephen Paul | Geschäftsführer | Nicker Hill Keyworth NG12 5ED Nottingham Whiteways England | England | British | Construction Director (R&M) | 179680920002 | ||||
JOHNSON, Robert Eric | Geschäftsführer | Hawthorn Cottage Toad Hole Farm Crescent Road NG16 6DR Selston Nottinghamshire | England | British | Director | 77024200001 | ||||
MAISEY, Alan Leonard | Geschäftsführer | St Edmonds Close Green Lane Walesby Newark NG21 9PA Nottingham Nottinghamshire | England | British | Company Director | 41533970001 | ||||
MCGRATH, Derek John | Geschäftsführer | Parkway West Main Street NG14 7GH Bleasby Nottinghamshire | England | British | Chartered Surveyor | 114175710001 | ||||
PYGALL, Craig Daniel | Geschäftsführer | High Street Edwinstowe NG21 9PR Mansfield Edwinstowe House Nottinghamshire | England | British | Director | 179664870001 | ||||
RHODES, Peter Michael | Geschäftsführer | 73 Mansfield Road Edwinstowe NG21 Mansfield Notts | British | Director | 23202290001 | |||||
WOODHEAD, David Paul | Geschäftsführer | High Street Edwinstowe NG21 9PR Mansfield Edwinstowe House Nottinghamshire | United Kingdom | British | Chairman | 6175230002 | ||||
WOODHEAD, Margaret Alice | Geschäftsführer | 12 Church Street Edwinstowe NG21 9QA Mansfield Nottinghamshire | British | Director | 23202280001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ROBERT WOODHEAD LIMITED?
Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Robert Woodhead (Holdings) Ltd | 06. Apr. 2016 | High Street Edwinstowe NG21 9PR Mansfield Edwinstowe House England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
|
Hat ROBERT WOODHEAD LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
A registered charge | Erstellt am 31. März 2016 Geliefert am 06. Apr. 2016 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung F/H land and property k/a the former cavendish public house cavendish road carlton nottingham t/no NT16665. Enthält eine Negativzusicherung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 02. Okt. 2013 Geliefert am 05. Okt. 2013 | Vollständig erfüllt | ||
Kurzbeschreibung Edwinstowe house high street edwinstowe nottinghamshire t/no's NT331643.NT324744 and NT329746. Notification of addition to or amendment of charge. Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
A registered charge | Erstellt am 08. Aug. 2013 Geliefert am 13. Aug. 2013 | Ausstehend | ||
Kurzbeschreibung Notification of addition to or amendment of charge. Blankettverschreibung umfasst alles: Ja Enthält eine Blankettverschreibung: Ja Enthält eine Pfandverschreibung: Ja | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Charge of deposit | Erstellt am 18. Okt. 2011 Geliefert am 25. Okt. 2011 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The deposit of £161,355 and all amounts in the future credited to account number 36133310 with the bank. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 25. Feb. 2005 Geliefert am 26. Feb. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 65 watson road worksop notts. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 21. Sept. 1999 Geliefert am 08. Okt. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land at ekring road wellow nottinghamshire t/n NT337014. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 16. Juli 1999 Geliefert am 04. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Freehold property k/a residential land at eakring road wellow nottinghamshire part t/n NT337014. And the proceeds of sale thereof floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 03. März 1997 Geliefert am 11. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H k/a willene eakring road wellow nottinghamshre and the proceeds of sale thereof and A. floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 28. Feb. 1997 Geliefert am 07. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The freehold property known as jadon eakring road wellow nottinghamshire title number NT305780 the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 28. Feb. 1997 Geliefert am 07. März 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £100,000 due from the company to the chargee | |
Kurze Angaben Land at eakring road wellow nottinghamshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 27. Nov. 1995 Geliefert am 30. Nov. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The f/h property k/a 27 cyprus road mapperley park nottingham nottinghamshire t/n nt 36060 and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 28. Apr. 1992 Geliefert am 13. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £40,000.00 | |
Kurze Angaben Plot 6 dukeries park main street walesby near newark nottinghamshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 31. März 1989 Geliefert am 07. Apr. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £34,000 | |
Kurze Angaben All that piece of land situate at brailwood road on bilsthorpe industrial estate eakring nottinghamshire. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 20. Jan. 1989 Geliefert am 27. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Land at main street walesby nottingham title no nt 234830 and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal charge | Erstellt am 19. Jan. 1989 Geliefert am 21. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £266,000 | |
Kurze Angaben Land at main street walesby, notts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 12. Jan. 1989 Geliefert am 23. Jan. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben The pastures, rampton, nottinghamshire (title no: nt 223299) and/or the proceeds thereof:-. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Legal mortgage | Erstellt am 17. Feb. 1987 Geliefert am 26. Feb. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land at boy lane edwinstowe, mansfield nottinghamshire and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage debenture | Erstellt am 02. Mai 1985 Geliefert am 22. Mai 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge on all f/h & l/h property and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts f/h property k/a land at bay lane edwinstowe nottinghamshire and the proceeds of sale thereof. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Hat ROBERT WOODHEAD LIMITED Insolvenzverfahren?
Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 |
| Gläubiger-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0