SG LEASING (UTILITIES) LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | SG LEASING (UTILITIES) LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01364426 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
- Finanzleasing (64910) / Finanz- und Versicherungsdienstleistungen
Wo befindet sich SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place EC4M 7RB London |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| BMI (NO.3) LIMITED | 31. Dez. 1980 | 31. Dez. 1980 |
| DANNYWELANT LIMITED | 21. Apr. 1978 | 21. Apr. 1978 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 27. Juni 2022 | 7 Seiten | LIQ03 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss | 104 Seiten | LIQ10 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 10 Fleet Place London EC4M 7QS zum C/O Interpath Ltd 10 Fleet Place London EC4M 7RB am 04. Juli 2022 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 15 Canada Square London E14 5GL zum 10 Fleet Place London EC4M 7QS am 14. Dez. 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG England zum 15 Canada Square London E14 5GL am 14. Juli 2021 | 2 Seiten | AD01 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 5 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Lindsay Ginnette Sides als Geschäftsführer am 04. Juni 2021 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Die Adresse der Registerinspektion wurde vom C/O C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG United Kingdom zum C/O Group Legal One Bank Street London E14 4SG geändert | 1 Seiten | AD02 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2020 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2019 bis 30. Juni 2020 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom C/O C/O Group Legal Sg House 41 Tower Hill London EC3N 4SG zum One Bank Street Canary Wharf London E14 4SG am 18. Nov. 2019 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 30 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2019 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Paul Shields als Geschäftsführer am 20. Mai 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stuart Donald Cook als Geschäftsführer am 05. Apr. 2019 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2017 | 27 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2018 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Stephen Lethbridge Fowler am 20. Sept. 2018 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Ernennung von Mr. Paul Shields als Direktor am 19. März 2018 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2017 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| BALINSKA-JUNDZILL, Catherine | Sekretär | 10 Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Ltd | 191477830001 | |||||||
| DENT, Nicholas Michael | Geschäftsführer | 10 Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Ltd | United Kingdom | British | 43922780002 | |||||
| FOWLER, Stephen Lethbridge | Geschäftsführer | 10 Fleet Place EC4M 7RB London C/O Interpath Ltd | England | British | 135237620002 | |||||
| RUFFELL, Lara Catherine | Sekretär | 23 Meadowlands Chineham RG24 8XL Basingstoke Hampshire | British | 69140140002 | ||||||
| SHOOLBRED, Charles Frederick | Sekretär | Timbers Dean Oak Lane RH2 8PZ Leigh Surrey | British | 540290002 | ||||||
| BARCOSEC LIMITED | Sekretär | 1 Churchill Place E14 5HP London | 49004930002 | |||||||
| AKRAM, Mohammed | Geschäftsführer | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 169142800001 | |||||
| BOOBYER, Christopher Leslie Richard | Geschäftsführer | 54 Lombard Street EC3P 3AH London | British | 92233050001 | ||||||
| BOX, Sarah | Geschäftsführer | Court Lodge Lower Road West Farleigh ME15 0PD Maidstone Kent | British | 47381630004 | ||||||
| CALLENDER, John Dalrymple | Geschäftsführer | Fairway Heights GU15 1NJ Camberley 14 Surrey | United Kingdom | British | 2444200001 | |||||
| CLARK, Thomas Martin | Geschäftsführer | Hatch Hill Hatch Lane Kingsley Green GU27 3LJ Haslemere Surrey | British | 5529800001 | ||||||
| COOK, Stuart Donald | Geschäftsführer | c/o C/O Group Legal House 41 Tower Hill EC3N 4SG London Sg United Kingdom | United Kingdom | British | 191477240004 | |||||
| DOWDING, Eric Robert | Geschäftsführer | 23 Waldorf Heights Blackwater Howley Hill GU17 9JH Camberley Surrey | British | 46728970001 | ||||||
| ELLIS, David James | Geschäftsführer | Batts Row Cottage Laverstoke Lane, Laverstoke RG28 7PA Whitchurch Hampshire | England | British | 113760650001 | |||||
| EVANS, Christopher Hewitt | Geschäftsführer | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 121774150001 | ||||||
| HARE, Darren Mark | Geschäftsführer | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 127470250001 | |||||
| HUCKLE, Jonathan Mark | Geschäftsführer | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 163223760001 | |||||
| LEATHER, Jonathan Terence | Geschäftsführer | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | British | 69140360004 | |||||
| LEWIS, Barry Randall | Geschäftsführer | 37 Main Road Littleton SO22 6QJ Winchester Hampshire | England | British | 145163830001 | |||||
| MACINTOSH, Gordon Paterson | Geschäftsführer | 7 Paddock Field Chilbolton SO20 6AU Stockbridge Hampshire | British | 25737780001 | ||||||
| MCMILLAN, Richard John | Geschäftsführer | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 68601920003 | ||||||
| MILES, Martin Graham | Geschäftsführer | 1 Churchill Place E14 5HP London | United Kingdom | British | 108439150001 | |||||
| MILLINER, Craig | Geschäftsführer | 21 Smithson Close Talbot Village BH12 5EY Poole Dorset | British | 144700710001 | ||||||
| NIMMO, Mark Alexander | Geschäftsführer | c/o C/O Group Legal House 41 Tower Hill EC3N 4SG London Sg United Kingdom | England | British | 33420600001 | |||||
| RIDOUT, Thomas Geoffrey | Geschäftsführer | Churchill Place E14 5HP London 1 England | England | British | 155056490001 | |||||
| ROSE, Stephen George | Geschäftsführer | 1 Churchill Place E14 5HP London | British | 143870380001 | ||||||
| ROWAN, Charles Paul | Geschäftsführer | 32 Queens Park West Drive Queens Park BH8 9DD Bournemouth Dorset | British | 49237910001 | ||||||
| ROWBERRY, Duncan John | Geschäftsführer | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | British | 49237880004 | |||||
| SHIELDS, Paul | Geschäftsführer | c/o C/O Group Legal House 41 Tower Hill EC3N 4SG London Sg | England | British | 244361960001 | |||||
| SIDES, Lindsay Ginnette | Geschäftsführer | Canary Wharf E14 4SG London One Bank Street England | England | British | 212141970001 | |||||
| SILCOCK, Frank Avis | Geschäftsführer | Charleston 74 Wellhouse Road Beech GU34 4AG Alton Hampshire | British | 32895910001 | ||||||
| SIMPSON, Gavin John | Geschäftsführer | Churchill Place E14 5HP London 1 England | United Kingdom | British | 149333050001 | |||||
| WATSON, Hazel Anne Marie | Geschäftsführer | 1 Churchill Place E14 5HP London | England | Irish | 122291210001 | |||||
| WEAL, Barry | Geschäftsführer | Orchard Gate Mill Lane Bramley GU5 0HW Guildford Surrey | British | 40203100001 | ||||||
| WEAVING, John Martin | Geschäftsführer | 57 Bridle Way Colehill BH21 2UP Wimborne Dorset | British | 58523120001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei SG LEASING (UTILITIES) LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Société Générale | 06. Apr. 2016 | Boulevard Haussmann 75009 Paris 29 France | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat SG LEASING (UTILITIES) LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Secondary lease security assignment | Erstellt am 30. Dez. 1992 Geliefert am 14. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due from i/s scantrack and/or ole soeberg to the chargee under the terms of the loan agreement dated 30.12.92 | |
Kurze Angaben All rights,title and interest in the agreements and all sums payable...............see form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Sub-lessee security agreement | Erstellt am 30. Dez. 1992 Geliefert am 14. Jan. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The performance of certain covenants due or to become due from the company to the chargee under the terms of the sublease and the head lease both dated 24.11.92 | |
Kurze Angaben All rights,title and interest under the agreements......all proceeds receivable.....see form 395. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First priority statutory mortgage | Erstellt am 18. Dez. 1986 Geliefert am 07. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under the terms of a financial agreement dated 11.10.85 as amended by a supplemental financial agreement and a deed of covenant both dated 18.12.86 | |
Kurze Angaben 64/64TH shares of and in the motor vessel "arco avon" registered in the name of the company at the port of southampton. Under official no 711642. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of covenant | Erstellt am 18. Dez. 1986 Geliefert am 07. Jan. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £5,800,000 all monies due or to become due from the company to the chargee secured by a charge dated 18.12.86 and all other monies due or to become due under the terms of a financial agreement dated 11.10.85 as amended by a supplemental financial agreement dated 18.12.86 and this deed | |
Kurze Angaben The motor vessel "arco avon" registered at the port of southampton under official no 711642 including any share of interest therein and her engines machinery boats tackle outfit share gear fuel consumable or other stores belongings and appurtenances whether on board ar ashore (the "ship") all the companys joint on other interests in and all benefits of policies and contracts of insurance (please see doc for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Financial agreement | Erstellt am 11. Okt. 1985 Geliefert am 14. Okt. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £5,800,000 and all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a building contract dated 31 may '85 and novation agreement dated 11 oct 1985 | |
Kurze Angaben All the company's beneficial interest and all its rights and titles in the contract including the vessel and all moneys payable (see doc M37 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Shipowners agreement | Erstellt am 01. Okt. 1985 Geliefert am 14. Okt. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a shipowners agreement | |
Kurze Angaben Any moneys payable to the company in accordance with the terms of clause 9(b) or 15(b) of the financial agreement dated 11.10.85 (for full details see doc M36). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of covenant | Erstellt am 18. März 1985 Geliefert am 03. Apr. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from ugland brothers limited to the chargee secured by a mortgage 18.3.85 under the terms of a guarantee facility agreement 18.3.85 | |
Kurze Angaben All the companys interest in M.v "itm installer" see doc for fuller details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| First priority statutory mortgage | Erstellt am 18. März 1985 Geliefert am 03. Apr. 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys due or to become due from ugland brothers limited to the chargee on an account current under the terms of a deed of covenant 18.3.85 and pursuant to a guarantee facility agreement 18.3.85 | |
Kurze Angaben 64/64TH shares in M.V. "itm installer" registered number 703418 together with her boats and appurtenances. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Assignment | Erstellt am 28. Feb. 1985 Geliefert am 12. März 1985 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on behalf of the banks under clause 3.01 of the interim boeing counter indemnity agreement dated 28 february 1985 | |
Kurze Angaben All the company's right title, interest and benefits in and to all moneys that may be or become payable by the boeing company to the company under articles 2.1(d) and 5.4 of part b of the purchase agreement dated 28.2.85 between the boeing company, british airways PLC and the company. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat SG LEASING (UTILITIES) LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0