ANKER SYSTEMS
Überblick
| Unternehmensname | ANKER SYSTEMS |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung ohne Aktienkapital |
| Unternehmensnummer | 01365105 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von ANKER SYSTEMS?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich ANKER SYSTEMS?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Oracle Parkway Thames Valley Park RG6 1RA Reading Berkshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von ANKER SYSTEMS?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| ANKER SYSTEMS LIMITED | 31. März 2000 | 31. März 2000 |
| RIVA SYSTEMS LIMITED | 26. Sept. 1988 | 26. Sept. 1988 |
| RIVA TURNKEY COMPUTER SYSTEMS LIMITED | 31. Dez. 1978 | 31. Dez. 1978 |
| BENCHWORLD LIMITED | 25. Apr. 1978 | 25. Apr. 1978 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von ANKER SYSTEMS?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2016 |
Welche sind die letzten Einreichungen für ANKER SYSTEMS?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung erstellt bis zum 30. Juni 2016 | 11 Seiten | AA | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Bescheinigung über die Umregistrierung von beschränkt haftend in unbeschränkt haftend | 1 Seiten | CERT3 | ||||||||||
Zustimmung zur Umwandlung | 1 Seiten | FOA-RR | ||||||||||
Neuregistrierung von Gesellschaftsvertrag und Satzung | 38 Seiten | MAR | ||||||||||
Umwandlung von einer Gesellschaft mit beschränkter Haftung in eine Gesellschaft mit unbeschränkter Haftung | 1 Seiten | RR05 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 05. Dez. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2015 | 22 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2014 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Walder als Geschäftsführer am 26. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Cynthia Russo als Geschäftsführer am 26. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Frank Peter Ward als Geschäftsführer am 26. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Walder als Sekretär am 26. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kaweh Niroomand als Geschäftsführer am 26. Nov. 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Oracle Corporation Nominees Limited als Direktor am 26. Nov. 2014 | 2 Seiten | AP02 | ||||||||||
Ernennung von Mr David James Hudson als Direktor am 26. Nov. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 6-8 the Grove Slough Berkshire SL1 1QP zum Oracle Parkway Thames Valley Park Reading Berkshire RG6 1RA am 01. Dez. 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2013 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 05. Dez. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2012 | 25 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von ANKER SYSTEMS?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HUDSON, David James | Geschäftsführer | Thames Valley Park RG6 1RA Reading Oracle Parkway Berkshire England | England | British | 100987010002 | |||||||||
| ORACLE CORPORATION NOMINEES LIMITED | Geschäftsführer | Thames Valley Park RG6 1RA Reading Oracle Parkway Berkshire England |
| 118326710001 | ||||||||||
| ALEXANDER, Neil Brough | Sekretär | Brook House Osbaston SY10 8HT Oswestry Shropshire | British | 3699700001 | ||||||||||
| COOKSLEY, Graeme Roy | Sekretär | Chamer Russweg 19 6300 Zug Switzerland | New Zealander | 126903810001 | ||||||||||
| HORN, Nigel David | Sekretär | Featherbow House Ratley OX15 6DS Banbury Oxfordshire | British | 109926660001 | ||||||||||
| ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr. | Sekretär | 1110 Fox Glen Drive St Charles Illinois 60174 Usa | Other | 123425810001 | ||||||||||
| ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr. | Sekretär | 1110 Fox Glen Drive St Charles Illinois 60174 Usa | Other | 123425810001 | ||||||||||
| JOHNSON, Robin Simon | Sekretär | 25 Thirlmere Road Muswell Hill N10 2DL London | British | 11498320001 | ||||||||||
| JONES, Stephen Philip | Sekretär | 11 Pownall Avenue Bramhall SK7 2HE Stockport Cheshire | British | 39173700002 | ||||||||||
| LEEK, Marcus | Sekretär | 7 Gloster Drive CV8 2TU Kenilworth Warwickshire | British | 115960470001 | ||||||||||
| WALDER, Stephen | Sekretär | Thames Valley Park RG6 1RA Reading Oracle Parkway Berkshire | British | 169959800001 | ||||||||||
| ABDO, Ashley | Geschäftsführer | 63 West Ranch Trail CO80465 Morrison Colorado Usa | American | 90157130001 | ||||||||||
| ALEXANDER, Neil Brough | Geschäftsführer | Brook House Osbaston SY10 8HT Oswestry Shropshire | British | 3699700001 | ||||||||||
| APPLETON, Colin Arthur | Geschäftsführer | 15 The Coppice Cuddington CW8 2XF Northwich Cheshire | England | British | 19964370001 | |||||||||
| BAILEY, James R | Geschäftsführer | 1000 Rock Ridge Lane Loveland Colorado 80537 Usa | American | 69700010001 | ||||||||||
| BAKER, Jeremy David | Geschäftsführer | 16 Bonville Chase WA14 4QA Altrincham Cheshire | British | 51244270001 | ||||||||||
| BUTCHER, Steve John | Geschäftsführer | Lower Laithe Cottage Providence Lane, Oakworth BD22 7QS Keighley West Yorkshire | United Kingdom | British | 203318870001 | |||||||||
| CALLAGHAN, Stephen James | Geschäftsführer | The Grove SL1 1QP Slough 6-8 Berkshire | England | British | 87418990003 | |||||||||
| COOKSLEY, Graeme Roy | Geschäftsführer | Chamer Russweg 19 6300 Zug Switzerland | New Zealander | 126903810001 | ||||||||||
| COOKSLEY, Graeme | Geschäftsführer | 19 Charmer Fussweg Zug 6300 Switzerland | New Zealander | 122786180001 | ||||||||||
| DOBIE, Timothy Arthur Ross | Geschäftsführer | 1 St Andrews Road Brockhall Village Old Langho BB6 8BP Blackburn Lancashire | England | British | 97704830001 | |||||||||
| DOBSON, Melvyn John | Geschäftsführer | 42 Ravens Wood Chorley New Road Heaton BL1 5TL Bolton | British | 45852970001 | ||||||||||
| DURKIN, Ivan Paul | Geschäftsführer | 11 Stapleford Close BL8 2UG Bury Lancashire | British | 51244360001 | ||||||||||
| EARHART, Stephen | Geschäftsführer | Brittens Lane Salford MK17 8BE Milton Keynes 1 Buckinghamshire United Kingdom | United States | 133153450001 | ||||||||||
| FOULKES, John Harold | Geschäftsführer | Cank Farmhouse Welford Road NN6 8AH Chapel Brampton Northamptonshire | British | 1657980007 | ||||||||||
| GILDART, Steven | Geschäftsführer | 12 Ennerdale Road Astley Tyldesley M29 7AR Manchester | British | 51244420001 | ||||||||||
| GILES, Peter Hardwick | Geschäftsführer | Arden House Lamb Lane Ashley WA14 3QG Altrincham Cheshire | England | British | 35521860001 | |||||||||
| GRADDEN, Amanda Jane | Geschäftsführer | Flat 2 10a Market Mews W1J 7BZ London | England | British | 77425910003 | |||||||||
| GREENOUGH, Michael | Geschäftsführer | 711 Pintail Court Granbury Texas 76049 Usa | Canadian | 123427350001 | ||||||||||
| HAYES, Laurence | Geschäftsführer | 15 Heald Cottages Judith Street Lowerfold OL12 7HS Rochdale Lancashire | British | 51244430001 | ||||||||||
| HIRANO, Michael | Geschäftsführer | 139 Eagle Canyon Circle PO BOX 1925 CO80540 Lyons Colorado Usa | American | 90157180001 | ||||||||||
| HOLLENBECK, David Arthur | Geschäftsführer | 5166 Buckingham Road CO80301 Boulder Colorado Usa | American | 90157320001 | ||||||||||
| HORN, Nigel David | Geschäftsführer | Featherbow House Ratley OX15 6DS Banbury Oxfordshire | British | 109926660001 | ||||||||||
| ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr. | Geschäftsführer | 1110 Fox Glen Drive St Charles Illinois 60174 Usa | Usa | Other | 123425810001 | |||||||||
| JONES, Stephen Philip | Geschäftsführer | 11 Pownall Avenue Bramhall SK7 2HE Stockport Cheshire | England | British | 39173700002 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei ANKER SYSTEMS?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Torex Retail Holdings Limited | 06. Apr. 2016 | Thames Valley Park RG6 1RA Reading Oracle Parkway Berkshire England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat ANKER SYSTEMS Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 21. Okt. 2009 Geliefert am 02. Nov. 2009 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor to the chargee on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture (the "agreement") | Erstellt am 28. Jan. 2000 Geliefert am 09. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the finance documents (including the agreement) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 18. Aug. 1999 Geliefert am 24. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of adherence | Erstellt am 12. Mai 1992 Geliefert am 14. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter DATED13TH april 1992 the composite debenture dated 26TH april 1990 and any other security documents (as defined) | |
Kurze Angaben The charged assets as defined in the original charge see form 395 ref M563C. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Second supplemental deed | Erstellt am 12. Mai 1992 Geliefert am 14. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter DATED13 april 1992 the composite debenture dated 26 april 1990 or any other security document (as defined) | |
Kurze Angaben The charges and assignments contained inclause 2 of the original debenture DATED26 april 1990. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 13. Apr. 1992 Geliefert am 30. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from theriva group PLC and/or all or any of the other companies named therein to the chargees under the terms of the finance documents as defined | |
Kurze Angaben See form 395 ref M90. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed | Erstellt am 12. Aug. 1991 Geliefert am 20. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility to the dated 23RD april 1990 and any other security document (as defined) | |
Kurze Angaben (See form 395- ref M135 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 13. Mai 1991 Geliefert am 29. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from riva group PLC to the chargee under each of the finance documents as defined | |
Kurze Angaben (See doc M148 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantees & mortgage debenture | Erstellt am 26. Apr. 1990 Geliefert am 08. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter and this charge and any other security document | |
Kurze Angaben (See doc M228 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 09. Nov. 1989 Geliefert am 30. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from hugin sweda group (as defined) under the terms of each of the finance documents and/or the swedish loan agreements as defined to the chargee. | |
Kurze Angaben All dividends paid or payable after the date of the debenture and all or any of the shares and all stocks, shares, securities (and the dividends or interest thereon) rights, money or property. (See form m 395 ref m 849C for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 11. Sept. 1987 Geliefert am 22. Sept. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £133,000.00 and all other monies due or to become due from the and alistair scott petrie and barbara ann petrie company to the chargee | |
Kurze Angaben 1, the farthings, marcham abingdon, oxfordshire. T/n:- on 60470. and all fixtures thereon and additions thereto. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. Jan. 1982 Geliefert am 04. Feb. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed amd floating charge on undertaking and all property and assets present and future including goodwill, bookdebts & uncalled capital. With all buildings, fixtures, fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 20. Juni 1980 Geliefert am 24. Juni 1980 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge undertaking and all property and assets present and future including goodwill uncalled capital. And all fixtures (including trade fixtures) fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0