REVOLVER RECORDS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | REVOLVER RECORDS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01370220 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von REVOLVER RECORDS LIMITED?
- Nicht handelndes Unternehmen (74990) / Wissenschaftliche und technische Dienstleistungen
Wo befindet sich REVOLVER RECORDS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Windsor House Spittal Street SL7 3HJ Marlow Buckinghamshire United Kingdom |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von REVOLVER RECORDS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| DAGGERMOOR LIMITED | 24. Mai 1978 | 24. Mai 1978 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von REVOLVER RECORDS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 28. Apr. 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für REVOLVER RECORDS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Beendigung der Liquidation | 1 Seiten | L64.07 | ||||||||||
Gerichtsbeschluss zur Liquidation | 2 Seiten | COCOMP | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung | 1 Seiten | GAZ1 | ||||||||||
Ernennung von Mr Henry William Foster als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Paul Patrick Mcgowan als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Ian Kenyon als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Trevor Moore als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elaine Marriner als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Elaine Marriner als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Ernennung von Mr Ian Peter Kenyon als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Trevor Philip Moore als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Simon Fox als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 28. Apr. 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 3 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Beendigung der Bestellung von Denise Tomblin als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Shelley House, 2-4 York Road Maidenhead Berkshire SL6 1SR* am 13. März 2012 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 30. Apr. 2011 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mrs Denise Tomblin als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Humphrey Kadaner als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Harvey Berkley als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Bright als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 24. Apr. 2010 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 10. Mai 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von REVOLVER RECORDS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSTER, Henry William | Geschäftsführer | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 162122230001 | |||||
| MCGOWAN, Paul Patrick | Geschäftsführer | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | Ireland | Irish | 132951490003 | |||||
| BRIGHT, Neil Irvine | Sekretär | Pound End Cedar Drive, Cookham SL6 9DZ Maidenhead Berkshire | British | 180993450001 | ||||||
| CAMPBELL, Laurence James | Sekretär | Mellbreak Dell Grove Frimley GU16 5PZ Camberley Surrey | British | 27960300001 | ||||||
| CAMPBELL, Laurence James | Sekretär | Mellbreak Dell Grove Frimley GU16 5PZ Camberley Surrey | British | 27960300001 | ||||||
| HOWELL, Peter Graham | Sekretär | 76 Kings Road SW19 8QW London | British | 62634010001 | ||||||
| LYMATH, Michael Gerald | Sekretär | Windsor Cottage Temple Park Farm SL6 5LT Hurley Berkshire | British | 76768320001 | ||||||
| MARRINER, Elaine | Sekretär | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | British | 40470020001 | ||||||
| RITCHIE, Ian | Sekretär | 66 Cherwell Drive Marston OX3 0LZ Oxford Oxfordshire | British | 68246050001 | ||||||
| SMITH, George Marsden | Sekretär | 18 Bevin Square SW17 7BB London | British | 15729150003 | ||||||
| TOMBLIN, Denise Lynne | Sekretär | 20 Bell Crescent Longwick HP27 9SE Princes Risborough Buckinghamshire | British | 63502600001 | ||||||
| BELL, Duncan Charles | Geschäftsführer | Longwood Queen Annes Road SL4 2BJ Windsor Berkshire | British | 9950440002 | ||||||
| BERKLEY, Harvey Mark | Geschäftsführer | Shelley House, 2-4 York Road Maidenhead SL6 1SR Berkshire | Canada | British | 70061320002 | |||||
| BRIGHT, Neil Irvine | Geschäftsführer | Shelley House, 2-4 York Road Maidenhead SL6 1SR Berkshire | United Kingdom | British | 180993450001 | |||||
| CLARK, John Robert Morton | Geschäftsführer | 20 Mount Avenue Ealing W5 2RG London | England | British | 79328330001 | |||||
| FOX, Simon Richard | Geschäftsführer | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 58101280002 | |||||
| GILES, Alan James | Geschäftsführer | Tanglewood Crowsley Road RG9 3LE Shiplake Oxfordshire | England | British | 156046020001 | |||||
| HOWELL, Peter Graham | Geschäftsführer | 76 Kings Road SW19 8QW London | Uk | British | 62634010001 | |||||
| KADANER, Humphrey Howard | Geschäftsführer | Shelley House, 2-4 York Road Maidenhead SL6 1SR Berkshire | Canada | Canadian | 91849490002 | |||||
| KENYON, Ian Peter | Geschäftsführer | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 107735600001 | |||||
| LUCKHURST, Peter Martin | Geschäftsführer | 423 Walmer Road Toronto Ontario M5p 2x9 Canada | British | 70061260001 | ||||||
| LYMATH, Michael Gerald | Geschäftsführer | Windsor Cottage Temple Park Farm SL6 5LT Hurley Berkshire | England | British | 76768320001 | |||||
| MARRINER, Elaine | Geschäftsführer | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | England | British | 40470020001 | |||||
| MCALLISTER, Stuart | Geschäftsführer | The Granary 38 Wellington Street OX9 3BN Thame Oxfordshire | British | 9406880001 | ||||||
| MCLAUGHLIN, Brian Finbar | Geschäftsführer | Pangbourne Lodge Tidmarsh Road RG8 7AZ Pangbourne Berkshire | United Kingdom | British | 9950470002 | |||||
| MOORE, Trevor Philip | Geschäftsführer | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 113047410001 | |||||
| TOMBLIN, Denise | Geschäftsführer | Spittal Street SL7 3HJ Marlow Windsor House Buckinghamshire United Kingdom | United Kingdom | British | 163065540001 | |||||
| TOMBLIN, Denise Lynne | Geschäftsführer | 20 Bell Crescent Longwick HP27 9SE Princes Risborough Buckinghamshire | United Kingdom | British | 63502600001 | |||||
| WALKER, Chris | Geschäftsführer | C/O Hmv Hong Kong 5th Floor Sands Building 17 Hankow Road Tsimshatsui Kowloon Hong Kong | Australian | 83965230001 |
Hat REVOLVER RECORDS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Debenture | Erstellt am 22. Mai 1998 Geliefert am 04. Juni 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the high yield documents (as defined) and this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Amendment and restatement deed (to a debenture incorporating fixed and floating charges dated 28TH march 1998) | Erstellt am 14. Mai 1998 Geliefert am 15. Mai 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee (as security agent for itself and emi group finance PLC) under or pursuant to the finance documents (including the amended and restated debenture) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all undertaking property and assets present and future including all buildings fixtures plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. März 1998 Geliefert am 09. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever under or pursuant to the finance documents and this charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 28. März 1998 Geliefert am 09. Apr. 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag In favour of swiss bank corporation as "security agent", which expression shall include any person for the time being appointed as security trustee or as an additional trustee for the purpose of, and in accordance with, the senior facility agreement, the company shall discharge each and every liability which the company may now or hereafter have to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries under or pursuant to the senior facility agreement (including the debenture) including any liability in respect of any further advances made thereunder and pay to the security agent when due and payable every sum (of principal, intererst or otherwise) now or hereafter owing, due or incurred by the company to the security agent (whether for its own account or as trustee for the beneficiaries) or any of the other beneficiaries in respect of any such liabilities | |
Kurze Angaben By way of fixed charge (I) principal property owned by it at the date of this debenture other than (a) any heritable or leasehold property in scotland and all buildings trade and other fixtures fixed plant machinery installations and apparatus from time to time on any such property in scotland and (b) any principal property in northern ireland.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Juli 1984 Geliefert am 15. Aug. 1984 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H - property 38/39 four seasons, shopping centre mansfield, nottinghamshire title no:- nt 69200. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 11. Okt. 1982 Geliefert am 12. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill, book debts uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery, all stocks shares & other securities. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 27. März 1982 Geliefert am 16. Apr. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 39 spring lane arndale centre wellingborough. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Apr. 1981 Geliefert am 29. Apr. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Premises known as no. 67/69, gold street, kettering. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Apr. 1981 Geliefert am 29. Apr. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Premises known as 59, market place, leicester. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. Apr. 1981 Geliefert am 29. Apr. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H premises known as unit 62, the broadmcush centre, nottingham. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat REVOLVER RECORDS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Zwangsliquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0