NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED

NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameNEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01370566
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?

    • (2524) /

    Wo befindet sich NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Brooks House
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Warwickshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    SWISH BUILDING PRODUCTS LIMITED 05. März 199805. März 1998
    BREVILLE EUROPE LIMITED31. Dez. 197831. Dez. 1978
    DROWLEN LIMITED25. Mai 197825. Mai 1978

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2010

    Welche sind die letzten Einreichungen für NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Sept. 2013

    6 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    5 Seiten4.71

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 27. Sept. 2012

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    3 Seiten4.70

    Beendigung der Bestellung von Adrian Egerton Darling als Geschäftsführer am 31. Mai 2012

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Jan-Feie Zwiers als Direktor am 31. Mai 2012

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Robert Leslie Nash als Geschäftsführer am 26. März 2012

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von John Mcfaull als Geschäftsführer am 26. März 2012

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Paul Thomas Moss als Direktor am 26. März 2012

    2 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital27. Okt. 2011

    Kapitalaufstellung am 27. Okt. 2011

    • Kapital: GBP 25,866,666.7
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010

    1 SeitenAA

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009

    1 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Änderung der Details des Direktors für John Mcfaull am 28. Sept. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Robert Leslie Nash am 28. Sept. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Egerton Darling am 28. Sept. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Karen Roberts am 27. Sept. 2010

    2 SeitenCH03

    Geänderte Geschäftsanschrift vom 16 Stanier Way Wyvern Business Park Derby Derbyshire DE21 6BF England am 27. Sept. 2010

    1 SeitenAD01

    Änderung der Details des Direktors für Robert Leslie Nash am 13. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Egerton Darling am 13. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Direktors für John Mcfaull am 13. Jan. 2010

    2 SeitenCH01

    Änderung der Details des Sekretärs für Karen Roberts am 13. Jan. 2010

    1 SeitenCH03

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008

    1 SeitenAA

    Wer sind die Geschäftsführer von NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    ROBERTS, Karen Dawn
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Sekretär
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    British126457090001
    MOSS, Paul Thomas
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    EnglandBritish167898270001
    ZWIERS, Jan-Feie
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    England
    Geschäftsführer
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    England
    NetherlandsDutch169623550001
    BOND, Sarah Caroline
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    Sekretär
    Hillside
    37 Rise End, Middleton
    DE4 4LS Wirksworth
    Derbyshire
    British90181180006
    CHAPMAN, Christopher John
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    Sekretär
    5 The Willows
    Walmley
    B76 2PX Sutton Coldfield
    West Midlands
    British50769680003
    LOWE, Tracey
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    Sekretär
    149 Smalley Drive
    Oakwood
    DE21 2SQ Derby
    Derbyshire
    British86697030001
    PERKINS, Michael William
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    Sekretär
    38 Cubbington Road
    CV32 7AB Leamington Spa
    Warwickshire
    British30958650001
    STRATTON, Malcolm
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    Sekretär
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    British30601260018
    STRATTON, Malcolm
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    Sekretär
    White Rose Grange Hollington Road
    Stubwood
    ST14 5HY Uttoxeter
    Staffordshire
    British30601260002
    DARLING, Adrian Egerton
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Geschäftsführer
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish13813980005
    DAVIES, Michael Thomas
    Dadlington House Farm
    Shenton Lane
    CV13 6JD Dadlington
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Dadlington House Farm
    Shenton Lane
    CV13 6JD Dadlington
    Warwickshire
    British50770000002
    EDWARDS, Mark John
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    Geschäftsführer
    The Glen
    35 Hazelwood Road
    DE56 4DP Duffield
    Derby
    United KingdomBritish56562210001
    GODDARD, David Peter
    The Hollies
    Ivy House Lane
    HP4 2PP Berkhamsted
    Hertfordshire
    Geschäftsführer
    The Hollies
    Ivy House Lane
    HP4 2PP Berkhamsted
    Hertfordshire
    United KingdomBritish8828350002
    HANRAHAN, Shaun Patrick
    19 Wollaton Vale
    Wollaton
    NG8 2PD Nottingham
    Geschäftsführer
    19 Wollaton Vale
    Wollaton
    NG8 2PD Nottingham
    British49298590002
    MCFAULL, John
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    British83628430003
    NASH, Robert Leslie
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    Geschäftsführer
    Coventry Road
    CV34 4LL Warwick
    Brooks House
    Warwickshire
    England
    United KingdomBritish83397580001
    PURCHASE, Roger
    8 Moorfield Avenue
    Knowle
    B93 9RE Solihull
    West Midlands
    Geschäftsführer
    8 Moorfield Avenue
    Knowle
    B93 9RE Solihull
    West Midlands
    EnglandBritish49298600001
    SIMPSON, Kenneth
    Copton Ash Cottage
    Sheepy Road, Twycross
    CV9 3PG Atherstone
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    Copton Ash Cottage
    Sheepy Road, Twycross
    CV9 3PG Atherstone
    Warwickshire
    British27376570002
    STRATTON, Malcolm
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Flat 40
    Manor Park Court, Uttoxeter New Road
    DE22 3NG Derby
    Derbyshire
    British30601260018
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363930002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002
    NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    57363780002
    WESTMINSTER SECURITIES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    33480800001
    WILLIAMS MANAGEMENT SERVICES LIMITED
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    Geschäftsführer
    Pentagon House
    Sir Frank Whittle Road
    DE21 4XA Derby
    Derbyshire
    6125640001

    Hat NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Guarantee and debenture made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined) pursuant to the intercreditor agreement (as defined)
    Erstellt am 05. Dez. 2000
    Geliefert am 12. Dez. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) including the guarantee and debenture
    Kurze Angaben
    .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 12. Dez. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 25. März 2004Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 27. Feb. 1998
    Geliefert am 16. März 1998
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the finance parties (as therein defined) (or any of them) under each or any of the finance documents (as therein defined) on any account whatsoever provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured liabilities" to the extent that, if it were included, supplemental debenture or the debenture (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Grenfell & Co Limited
    Transaktionen
    • 16. März 1998Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Accession agreement relating to a debenture dated 4/12/96
    Erstellt am 31. Dez. 1996
    Geliefert am 09. Jan. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each chargor (as defined) to the finance parties or any of them under each or any of the finance documents (as defined)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Morgan Grenfell & Co. Limited,as Agent for the Chargors
    Transaktionen
    • 09. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Dez. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    21. Jan. 2014Aufgelöst am
    27. Sept. 2012Beginn der Liquidation
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Peter James Greaves
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Timothy Gerard Walsh
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham
    Praktiker
    Cornwall Court 19 Cornwall Street
    B3 2DT Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0