NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01370566 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?
- (2524) /
Wo befindet sich NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Brooks House Coventry Road CV34 4LL Warwick Warwickshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SWISH BUILDING PRODUCTS LIMITED | 05. März 1998 | 05. März 1998 |
| BREVILLE EUROPE LIMITED | 31. Dez. 1978 | 31. Dez. 1978 |
| DROWLEN LIMITED | 25. Mai 1978 | 25. Mai 1978 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2010 |
Welche sind die letzten Einreichungen für NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 26. Sept. 2013 | 6 Seiten | 4.68 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 5 Seiten | 4.71 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 3 Seiten | 4.70 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Adrian Egerton Darling als Geschäftsführer am 31. Mai 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jan-Feie Zwiers als Direktor am 31. Mai 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Robert Leslie Nash als Geschäftsführer am 26. März 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von John Mcfaull als Geschäftsführer am 26. März 2012 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Paul Thomas Moss als Direktor am 26. März 2012 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2010 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Sept. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für John Mcfaull am 28. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Robert Leslie Nash am 28. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Egerton Darling am 28. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Karen Roberts am 27. Sept. 2010 | 2 Seiten | CH03 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom 16 Stanier Way Wyvern Business Park Derby Derbyshire DE21 6BF England am 27. Sept. 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Robert Leslie Nash am 13. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Adrian Egerton Darling am 13. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für John Mcfaull am 13. Jan. 2010 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Karen Roberts am 13. Jan. 2010 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 1 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ROBERTS, Karen Dawn | Sekretär | Coventry Road CV34 4LL Warwick Brooks House Warwickshire England | British | 126457090001 | ||||||
| MOSS, Paul Thomas | Geschäftsführer | Coventry Road CV34 4LL Warwick Brooks House Warwickshire | England | British | 167898270001 | |||||
| ZWIERS, Jan-Feie | Geschäftsführer | Coventry Road CV34 4LL Warwick Brooks House England | Netherlands | Dutch | 169623550001 | |||||
| BOND, Sarah Caroline | Sekretär | Hillside 37 Rise End, Middleton DE4 4LS Wirksworth Derbyshire | British | 90181180006 | ||||||
| CHAPMAN, Christopher John | Sekretär | 5 The Willows Walmley B76 2PX Sutton Coldfield West Midlands | British | 50769680003 | ||||||
| LOWE, Tracey | Sekretär | 149 Smalley Drive Oakwood DE21 2SQ Derby Derbyshire | British | 86697030001 | ||||||
| PERKINS, Michael William | Sekretär | 38 Cubbington Road CV32 7AB Leamington Spa Warwickshire | British | 30958650001 | ||||||
| STRATTON, Malcolm | Sekretär | Flat 40 Manor Park Court, Uttoxeter New Road DE22 3NG Derby Derbyshire | British | 30601260018 | ||||||
| STRATTON, Malcolm | Sekretär | White Rose Grange Hollington Road Stubwood ST14 5HY Uttoxeter Staffordshire | British | 30601260002 | ||||||
| DARLING, Adrian Egerton | Geschäftsführer | Coventry Road CV34 4LL Warwick Brooks House Warwickshire England | United Kingdom | British | 13813980005 | |||||
| DAVIES, Michael Thomas | Geschäftsführer | Dadlington House Farm Shenton Lane CV13 6JD Dadlington Warwickshire | British | 50770000002 | ||||||
| EDWARDS, Mark John | Geschäftsführer | The Glen 35 Hazelwood Road DE56 4DP Duffield Derby | United Kingdom | British | 56562210001 | |||||
| GODDARD, David Peter | Geschäftsführer | The Hollies Ivy House Lane HP4 2PP Berkhamsted Hertfordshire | United Kingdom | British | 8828350002 | |||||
| HANRAHAN, Shaun Patrick | Geschäftsführer | 19 Wollaton Vale Wollaton NG8 2PD Nottingham | British | 49298590002 | ||||||
| MCFAULL, John | Geschäftsführer | Coventry Road CV34 4LL Warwick Brooks House Warwickshire | British | 83628430003 | ||||||
| NASH, Robert Leslie | Geschäftsführer | Coventry Road CV34 4LL Warwick Brooks House Warwickshire England | United Kingdom | British | 83397580001 | |||||
| PURCHASE, Roger | Geschäftsführer | 8 Moorfield Avenue Knowle B93 9RE Solihull West Midlands | England | British | 49298600001 | |||||
| SIMPSON, Kenneth | Geschäftsführer | Copton Ash Cottage Sheepy Road, Twycross CV9 3PG Atherstone Warwickshire | British | 27376570002 | ||||||
| STRATTON, Malcolm | Geschäftsführer | Flat 40 Manor Park Court, Uttoxeter New Road DE22 3NG Derby Derbyshire | British | 30601260018 | ||||||
| NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED | Geschäftsführer | Pentagon House Sir Frank Whittle Road DE21 4XA Derby Derbyshire | 57363930002 | |||||||
| NEWMOND ADMINISTRATION LIMITED | Geschäftsführer | Pentagon House Sir Frank Whittle Road DE21 4XA Derby Derbyshire | 57363930002 | |||||||
| NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Pentagon House Sir Frank Whittle Road DE21 4XA Derby Derbyshire | 57363780002 | |||||||
| NEWMOND MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Pentagon House Sir Frank Whittle Road DE21 4XA Derby Derbyshire | 57363780002 | |||||||
| WESTMINSTER SECURITIES LIMITED | Geschäftsführer | Pentagon House Sir Frank Whittle Road DE21 4XA Derby | 33480800001 | |||||||
| WILLIAMS MANAGEMENT SERVICES LIMITED | Geschäftsführer | Pentagon House Sir Frank Whittle Road DE21 4XA Derby Derbyshire | 6125640001 |
Hat NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee and debenture made between the company and the royal bank of scotland PLC as agent and trustee for the secured parties (as defined) pursuant to the intercreditor agreement (as defined) | Erstellt am 05. Dez. 2000 Geliefert am 12. Dez. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag The actual contingent present and/or future obligations and liabilities of the company to any of the secured parties under or pursuant to all or any of the secured documents (as defined) including the guarantee and debenture | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental debenture | Erstellt am 27. Feb. 1998 Geliefert am 16. März 1998 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor (as therein defined) to the chargee as agent and trustee for itself and each of the finance parties (as therein defined) (or any of them) under each or any of the finance documents (as therein defined) on any account whatsoever provided that no obligation or liability shall be included in the definition of "secured liabilities" to the extent that, if it were included, supplemental debenture or the debenture (or any part thereof) would constitute unlawful financial assistance within the meaning of sections 151 and 152 of the companies act 1985 | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Accession agreement relating to a debenture dated 4/12/96 | Erstellt am 31. Dez. 1996 Geliefert am 09. Jan. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each chargor (as defined) to the finance parties or any of them under each or any of the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat NEWMOND BUILDING PRODUCTS LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0