CHG DESIGN LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | CHG DESIGN LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01372655 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von CHG DESIGN LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich CHG DESIGN LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Roke Manor Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Hampshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von CHG DESIGN LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| SPLASHDOWN LIMITED | 06. Okt. 1995 | 06. Okt. 1995 |
| LEWIN & WARNER LIMITED | 31. Dez. 1979 | 31. Dez. 1979 |
| RAWPRENT LIMITED | 09. Juni 1978 | 09. Juni 1978 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von CHG DESIGN LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Okt. 2017 |
Welche sind die letzten Einreichungen für CHG DESIGN LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2017 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Michael James Flowers als Geschäftsführer am 30. Juni 2018 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2016 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2017 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Andrew Gregory Lewis als Direktor am 19. Jan. 2017 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Sarah Louise Ellard am 03. Jan. 2017 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Steven John Bowers als Geschäftsführer am 30. Sept. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2015 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2016 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2014 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Michael James Flowers am 13. März 2015 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Feb. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Sarah Louise Ellard am 09. Dez. 2014 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Änderung der Details des Sekretärs für Sarah Louise Ellard am 09. Dez. 2014 | 1 Seiten | CH03 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Okt. 2013 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Sarah Louise Ellard als Direktor am 24. Juli 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Michael James Flowers als Direktor am 24. Juli 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Harry Papworth als Geschäftsführer am 24. Juli 2014 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom * Cherming House 1500 Parkway Whiteley Fareham Hampshire PO15 7AF* am 01. Juli 2014 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Steven John Bowers als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von CHG DESIGN LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ELLARD, Sarah Louise | Sekretär | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | British | 43855640011 | ||||||
| ELLARD, Sarah Louise | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | 43855640013 | |||||
| LEWIS, Andrew Gregory | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire | United Kingdom | British | 222848510001 | |||||
| HOTHAM, Edward Durand | Sekretär | Ashcroft Furlong Chadlington OX7 3NY Chipping Norton Oxon | British | 29531580001 | ||||||
| LEIGHTON, Iain Gordon Kerr | Sekretär | 71 Rectory Grove Clapham Common SW4 0DS London | British | 42841660001 | ||||||
| ARMSTRONG, John Arthur | Geschäftsführer | 6 Firtree Lane Swinford LE17 6BH Lutterworth Leicestershire | British | 11951100001 | ||||||
| ATTWOOD, David John | Geschäftsführer | 27 Buckingham Drive WA16 8LH Knutsford Cheshire | British | 50715130001 | ||||||
| BILLINGTON, Philip Gordon | Geschäftsführer | 25 Carbis Close Port Solent Cosham PO6 4TW Portsmouth Hampshire | British | 18247670001 | ||||||
| BOWERS, Steven John | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 176189250001 | |||||
| EATON, John George | Geschäftsführer | 66 Glemsford Road IP14 2PW Stowmarket Suffolk | British | 24249280001 | ||||||
| EVANS, David Roger | Geschäftsführer | Yoxhall Lodge 10 Worsley Road PO5 3DY Southsea Hampshire | England | British | 4471420003 | |||||
| FERRIS, David | Geschäftsführer | 31 Coniston Road SN14 0PX Chippenham Wiltshire | British | 50715150001 | ||||||
| FLOWERS, Michael James | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | United Kingdom | Australian | 188873370002 | |||||
| GIBBS, Raymond John | Geschäftsführer | Bridge House 7 Uxbridge Close SO31 7LP Sarisbury Soton Hampshire | British | 85421380001 | ||||||
| HOTHAM, Edward Durand | Geschäftsführer | Ashcroft Furlong Chadlington OX7 3NY Chipping Norton Oxon | British | 29531580001 | ||||||
| KENNEDY, Ian Gordon | Geschäftsführer | 53 Kingsley Road IG10 3TU Loughton Essex | British | 29531590001 | ||||||
| LEVERATT, Bryan Creagh | Geschäftsführer | Hunters Lodge Hall Road Bedingfield Eye IP23 7QE Ipswich Suffolk | British | 24249290001 | ||||||
| LEWIN, David Charles Pearman | Geschäftsführer | Mulberry West Quay CM0 8AS Burnham On Crouch Essex | United Kingdom | British | 150605700001 | |||||
| PAPWORTH, Mark Harry | Geschäftsführer | Old Salisbury Lane SO51 0LZ Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | England | British | 103085690002 | |||||
| PRICE, David John | Geschäftsführer | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 75259760004 | |||||
| RAYNER, Paul Adrian | Geschäftsführer | 1500 Parkway Whiteley PO15 7AF Fareham Chemring House Hampshire United Kingdom | United Kingdom | British | 45628680002 | |||||
| WARNER, Philip Courtenay Thomas, Sir | Geschäftsführer | Marden Grange Marden SN10 3RQ Devizes Wiltshire | United Kingdom | British | 7356840001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei CHG DESIGN LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Chemring Group Plc | 30. Juni 2016 | Old Salisbury Lane SO51 0ZN Romsey Roke Manor Hampshire United Kingdom | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat CHG DESIGN LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 19. Nov. 2009 Geliefert am 30. Nov. 2009 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charge over the undertaking and all property and assets present and future, including goodwill, book debts, uncalled capital, buildings, fixtures, fixed plant & machinery see image for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 12. Nov. 2007 Geliefert am 20. Nov. 2007 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to any of the secured parties on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 05. Feb. 2001 Geliefert am 14. Feb. 2001 | Ausstehend | Gesicherter Betrag All obligations and liabilities due or to become due from the obligors to the chargee under or pursuant to the financing documents (all terms defined therein) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge over book debts | Erstellt am 23. Jan. 1996 Geliefert am 13. Feb. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All book/other debts from time to time. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. Nov. 1994 Geliefert am 05. Dez. 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of charge over credit balances | Erstellt am 01. Nov. 1993 Geliefert am 16. Nov. 1993 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A fixed charge over all the "deposit(s)" referred to in the schedule. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Letter of charge | Erstellt am 03. Dez. 1991 Geliefert am 13. Dez. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben All moneys now or at any time hereafter standing to the credit of any account(s)of the company with the bank designated barclays bank PLC re: lewin & warner limited. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 24. Okt. 1991 Geliefert am 07. Nov. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from thecompany and/or philip courtenay thomas warner to the chargee under the terms of the facility agreement dated 29TH august 1991 and this debenture | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over all the freehold and leasehold property and all the goodwill and uncalled capital,all bookdebts ans other debts, undertaking, property and assets (see doc ref M534C for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Feb. 1990 Geliefert am 21. Feb. 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben (Including trade fixtures). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0