GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED

GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Personen mit maßgeblichem Einfluss
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameGOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01375864
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED?

    • Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
    • Lizensierte Restaurants (56101) / Gastgewerbe

    Wo befindet sich GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Jubilee House
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Staffordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis18. Aug. 2018

    Welche sind die letzten Einreichungen für GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    7 SeitenLIQ13

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    3 Seiten600

    Beschlüsse

    Resolutions
    1 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    liquidation

    Sonderbeschluss zur Vergleichsverfahren am 09. März 2020

    LRESSP

    Erklärung der Zahlungsfähigkeit

    6 SeitenLIQ01

    Beendigung der Bestellung von Stephen Peter Dando als Geschäftsführer am 05. März 2020

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2019 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 18. Aug. 2018

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2018 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 19. Aug. 2017

    3 SeitenAA

    Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2017 mit Aktualisierungen

    4 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 20. Aug. 2016

    3 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Neil Robert Ceidrych Griffiths als Geschäftsführer am 30. Nov. 2016

    1 SeitenTM01

    Bestätigungserklärung erstellt am 30. Aug. 2016 mit Aktualisierungen

    5 SeitenCS01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 22. Aug. 2015

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital28. Sept. 2015

    Kapitalaufstellung am 28. Sept. 2015

    • Kapital: GBP 10,000
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 23. Aug. 2014

    6 SeitenAA

    Ernennung von Mr Edward Michael Bashforth als Direktor am 07. Okt. 2014

    2 SeitenAP01

    Ernennung von Francesca Appleby als Sekretär am 07. Okt. 2014

    2 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Claire Louise Harris als Sekretär am 07. Okt. 2014

    1 SeitenTM02

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 17. Aug. 2013

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 30. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital23. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 23. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 10,000
    SH01

    Ernennung von Neil Robert Ceidruch Griffiths als Direktor

    2 SeitenAP01

    Beendigung der Bestellung von Roger Whiteside als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Wer sind die Geschäftsführer von GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    APPLEBY, Francesca
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    191627770001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    AKERS, Bridget Margaret
    The Croft
    London Road
    DN22 7EB Retford
    Nottinghamshire
    Sekretär
    The Croft
    London Road
    DN22 7EB Retford
    Nottinghamshire
    British55908990001
    HARRIS, Claire Louise
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    175488250001
    KENDALL, Timothy James
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    Sekretär
    31 Canterbury Close
    Erdington
    B23 7QL Birmingham
    West Midlands
    British117397470002
    MILLS, Michael Peter
    Hillside High Street
    Pavenham
    MK43 7PD Bedford
    Bedfordshire
    Sekretär
    Hillside High Street
    Pavenham
    MK43 7PD Bedford
    Bedfordshire
    British23098320003
    PARRATT, Christopher Joseph
    Church Field House
    Bicester Road
    HP18 9QF Oakley
    Buckinghamshire
    Sekretär
    Church Field House
    Bicester Road
    HP18 9QF Oakley
    Buckinghamshire
    British151402840001
    RUDD, Susan Clare
    23 Whitehouse Drive
    WS13 8FE Lichfield
    Staffordshire
    Sekretär
    23 Whitehouse Drive
    WS13 8FE Lichfield
    Staffordshire
    British81789210002
    STEWART, Claire Susan
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Ninth Avenue
    DE14 3JZ Burton Upon Trent
    Sunrise House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Other130369890001
    THOMPSON, Robert Keth Fimay
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Bedfordshire
    Sekretär
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Bedfordshire
    British90824440001
    TYRRELL, Helen
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    161624040001
    AKERS, Bridget Margaret
    The Croft
    London Road
    DN22 7EB Retford
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    The Croft
    London Road
    DN22 7EB Retford
    Nottinghamshire
    British55908990001
    AKERS, Frederick
    The Croft London Road
    DN22 7EB Retford
    Nottinghamshire
    Geschäftsführer
    The Croft London Road
    DN22 7EB Retford
    Nottinghamshire
    British15454950001
    BASHFORTH, Edward Michael
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish131551840002
    DANDO, Stephen Peter
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish152083750001
    DUTTON, Philip
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish141395280001
    GRANGER, Robert Paul
    19 Meadow Close
    Compton
    RG20 6QQ Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    19 Meadow Close
    Compton
    RG20 6QQ Newbury
    Berkshire
    British55506440001
    GRIFFITHS, Neil Robert Ceidrych
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish55975990001
    KENNEDY, Samual Edward
    Beaulieu House
    Roman Road
    RH4 3ET Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Beaulieu House
    Roman Road
    RH4 3ET Dorking
    Surrey
    EnglandBritish149343140001
    MCDONALD, Robert James
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    Geschäftsführer
    46 Wentworth Drive
    WS14 9HN Lichfield
    Staffordshire
    British42019620001
    MILLS, Michael Peter
    Hillside High Street
    Pavenham
    MK43 7PD Bedford
    Bedfordshire
    Geschäftsführer
    Hillside High Street
    Pavenham
    MK43 7PD Bedford
    Bedfordshire
    British23098320003
    PARRATT, Christopher Joseph
    Church Field House
    Bicester Road
    HP18 9QF Oakley
    Buckinghamshire
    Geschäftsführer
    Church Field House
    Bicester Road
    HP18 9QF Oakley
    Buckinghamshire
    EnglandBritish151402840001
    PRESTON, Neil David
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish63043630002
    SNOOK, David Philip
    The Manor House
    Burnett
    BS31 2TF Keynsham
    Geschäftsführer
    The Manor House
    Burnett
    BS31 2TF Keynsham
    United KingdomBritish86850310001
    THOMSON, Robert Keith Finlay
    Hill Copse
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    Geschäftsführer
    Hill Copse
    92 Tebworth Road
    LU7 9QH Wingfield
    United KingdomBritish51167890002
    THORLEY, Giles Alexander
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    United KingdomBritish81928120002
    WHITESIDE, Roger Mark
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    Geschäftsführer
    Second Avenue
    DE14 2WF Burton Upon Trent
    Jubilee House
    Staffordshire
    United Kingdom
    EnglandBritish128819260001
    WILLIAMS, Robert Geoffrey
    Yeat Wood Farm
    Wotton Underwood
    HP18 0RL Aylesbury
    Geschäftsführer
    Yeat Wood Farm
    Wotton Underwood
    HP18 0RL Aylesbury
    United KingdomBritish55506280003

    Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED?

    Personen mit maßgeblichem Einfluss
    NameBenachrichtigt amAdresseAufgehört
    Mill House Inns (Retford) Limited
    Second Avenue
    Centrum One Hundred
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    England
    06. Apr. 2016
    Second Avenue
    Centrum One Hundred
    DE14 2WF Burton-On-Trent
    Jubilee House
    England
    Nein
    RechtsformPrivate Limited Company
    RechtsgrundlageCompanies Act 2006
    Arten der Kontrolle
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Anteile an der Gesellschaft.
    • Die Person hält, direkt oder indirekt, mehr als 75% der Stimmrechte im Unternehmen.
    • Die Person hat das Recht, direkt oder indirekt, die Mehrheit des Vorstands der Gesellschaft zu ernennen oder zu entlassen.

    Hat GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    First ranking fixed and floating security document
    Erstellt am 08. Dez. 2006
    Geliefert am 18. Dez. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland as Security Agent for the Benefit of the Finance Parties
    Transaktionen
    • 18. Dez. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2007Erklärung, dass ein Teil oder das gesamte Eigentum aus einer schwebenden Belastung freigegeben wurde (403b)
    • 25. Apr. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 19. März 2005
    Geliefert am 01. Apr. 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due by any group company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    The elms hotel london road retford notti. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland (The Security Trustee)
    Transaktionen
    • 01. Apr. 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Apr. 2007Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 02. Mai 2003
    Geliefert am 09. Mai 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Anglo Irish Bank Corporation PLC (The Agent)
    Transaktionen
    • 09. Mai 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Aug. 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed supplemental to a composite guarantee and debenture dated 7TH august 2000
    Erstellt am 18. Aug. 2000
    Geliefert am 21. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All moneys and obligations and liabilities due owing or incurred to the chargee (on behalf of itself and the banks and financial institutions from time to time parties to the secured documents) and to the finance parties by it or any other chargor under the secured documents (as defined)
    Kurze Angaben
    As described in the composite guarantee and debenture save that the title for site no 48 in the table for freehold properties shall be deleted and replaced with CH445871 and CH432365 and the title for site no 34 in the table for l/h properties shall be deleted and replaced with GM781708. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee and debenture
    Erstellt am 07. Aug. 2000
    Geliefert am 21. Aug. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies obligations and liabilities from time to time due owing or incurred by the company to the royal bank of scotland PLC (as security trustee on behalf of itself and the banks and the financial institutions from time to time parties to the secured documents) under or pursuant to the secured documents (as defined) as the same may be amended,varied,novated,supplemented or replaced and this debenture
    Kurze Angaben
    See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 21. Aug. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Mai 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental mortgage debenture
    Erstellt am 27. Nov. 1997
    Geliefert am 05. Dez. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever as defined in a facilities agreement dated 16TH september 1996
    Kurze Angaben
    F/H and l/h land and buildings k/a the elms hotel london road retford nottinghamshire t/no NT295236.
    Berechtigte Personen
    • Nm Rothschild & Sons Limited (As Trustee and Agent for the Banks)
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 12. Okt. 2001Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 25. Okt. 1995
    Geliefert am 27. Okt. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £29,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee and/or its present or future subsidiary companies or any other person nominated by the company or their assigns under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Elms hotel london road retford, all fixtures and fittings (not being personal chattel within the bills of sale acts) the goodwill of the businessand the benefit of the justices licence. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle PLC
    Transaktionen
    • 27. Okt. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal and floating charge
    Erstellt am 27. Mai 1994
    Geliefert am 14. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £53,000 and all other monies due from the company to the chargee and/or its then or future subsidiary companies
    Kurze Angaben
    The elms hotel retford nottinghamshire & fixtures & fittings the goodwill of the business the benefit of all licences & a floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Scottish & Newcastle PLC
    Transaktionen
    • 14. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 27. Mai 1994
    Geliefert am 08. Juni 1994
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a the elms hotel london road retford nottinghamshire and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Juni 1994Registrierung einer Belastung (395)
    • 19. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 23. Okt. 1987
    Geliefert am 12. Nov. 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H "the croft" london rd, retford nottingham and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 12. Nov. 1987Registrierung einer Belastung
    • 02. Juni 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 30. Juni 1978
    Geliefert am 21. Juli 1978
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Piece of land forming part of the garden of no.219 Chellaston road, shelton lock, derby with the bungalow erected thereon.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank Limited
    Transaktionen
    • 21. Juli 1978Registrierung einer Belastung
    • 19. Juli 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Hat GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    09. März 2020Beginn der Liquidation
    20. Juni 2021Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Steven Sherry
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp, 7 More London Riverside
    SE1 2RT London
    Emma Cray
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham
    Praktiker
    Pricewaterhousecoopers Llp One Chamberlain Square
    B3 3AX Birmingham

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0