GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01375864 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED?
- Hotels und ähnliche Unterkünfte (55100) / Gastgewerbe
- Lizensierte Restaurants (56101) / Gastgewerbe
Wo befindet sich GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Jubilee House Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Staffordshire |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 18. Aug. 2018 |
Welche sind die letzten Einreichungen für GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 6 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephen Peter Dando als Geschäftsführer am 05. März 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2019 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 18. Aug. 2018 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2018 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 19. Aug. 2017 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 20. Sept. 2017 mit Aktualisierungen | 4 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 20. Aug. 2016 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Neil Robert Ceidrych Griffiths als Geschäftsführer am 30. Nov. 2016 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Aug. 2016 mit Aktualisierungen | 5 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 22. Aug. 2015 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Aug. 2015 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 23. Aug. 2014 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Ernennung von Mr Edward Michael Bashforth als Direktor am 07. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Francesca Appleby als Sekretär am 07. Okt. 2014 | 2 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Claire Louise Harris als Sekretär am 07. Okt. 2014 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Aug. 2014 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 17. Aug. 2013 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 30. Aug. 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung von Neil Robert Ceidruch Griffiths als Direktor | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Roger Whiteside als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| APPLEBY, Francesca | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 191627770001 | |||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| AKERS, Bridget Margaret | Sekretär | The Croft London Road DN22 7EB Retford Nottinghamshire | British | 55908990001 | ||||||
| HARRIS, Claire Louise | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 175488250001 | |||||||
| KENDALL, Timothy James | Sekretär | 31 Canterbury Close Erdington B23 7QL Birmingham West Midlands | British | 117397470002 | ||||||
| MILLS, Michael Peter | Sekretär | Hillside High Street Pavenham MK43 7PD Bedford Bedfordshire | British | 23098320003 | ||||||
| PARRATT, Christopher Joseph | Sekretär | Church Field House Bicester Road HP18 9QF Oakley Buckinghamshire | British | 151402840001 | ||||||
| RUDD, Susan Clare | Sekretär | 23 Whitehouse Drive WS13 8FE Lichfield Staffordshire | British | 81789210002 | ||||||
| STEWART, Claire Susan | Sekretär | Ninth Avenue DE14 3JZ Burton Upon Trent Sunrise House Staffordshire United Kingdom | Other | 130369890001 | ||||||
| THOMPSON, Robert Keth Fimay | Sekretär | 92 Tebworth Road LU7 9QH Wingfield Bedfordshire | British | 90824440001 | ||||||
| TYRRELL, Helen | Sekretär | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | 161624040001 | |||||||
| AKERS, Bridget Margaret | Geschäftsführer | The Croft London Road DN22 7EB Retford Nottinghamshire | British | 55908990001 | ||||||
| AKERS, Frederick | Geschäftsführer | The Croft London Road DN22 7EB Retford Nottinghamshire | British | 15454950001 | ||||||
| BASHFORTH, Edward Michael | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 131551840002 | |||||
| DANDO, Stephen Peter | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 152083750001 | |||||
| DUTTON, Philip | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 141395280001 | |||||
| GRANGER, Robert Paul | Geschäftsführer | 19 Meadow Close Compton RG20 6QQ Newbury Berkshire | British | 55506440001 | ||||||
| GRIFFITHS, Neil Robert Ceidrych | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | England | British | 55975990001 | |||||
| KENNEDY, Samual Edward | Geschäftsführer | Beaulieu House Roman Road RH4 3ET Dorking Surrey | England | British | 149343140001 | |||||
| MCDONALD, Robert James | Geschäftsführer | 46 Wentworth Drive WS14 9HN Lichfield Staffordshire | British | 42019620001 | ||||||
| MILLS, Michael Peter | Geschäftsführer | Hillside High Street Pavenham MK43 7PD Bedford Bedfordshire | British | 23098320003 | ||||||
| PARRATT, Christopher Joseph | Geschäftsführer | Church Field House Bicester Road HP18 9QF Oakley Buckinghamshire | England | British | 151402840001 | |||||
| PRESTON, Neil David | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 63043630002 | |||||
| SNOOK, David Philip | Geschäftsführer | The Manor House Burnett BS31 2TF Keynsham | United Kingdom | British | 86850310001 | |||||
| THOMSON, Robert Keith Finlay | Geschäftsführer | Hill Copse 92 Tebworth Road LU7 9QH Wingfield | United Kingdom | British | 51167890002 | |||||
| THORLEY, Giles Alexander | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | United Kingdom | British | 81928120002 | |||||
| WHITESIDE, Roger Mark | Geschäftsführer | Second Avenue DE14 2WF Burton Upon Trent Jubilee House Staffordshire United Kingdom | England | British | 128819260001 | |||||
| WILLIAMS, Robert Geoffrey | Geschäftsführer | Yeat Wood Farm Wotton Underwood HP18 0RL Aylesbury | United Kingdom | British | 55506280003 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mill House Inns (Retford) Limited | 06. Apr. 2016 | Second Avenue Centrum One Hundred DE14 2WF Burton-On-Trent Jubilee House England | Nein | ||||
| |||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||
Hat GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| First ranking fixed and floating security document | Erstellt am 08. Dez. 2006 Geliefert am 18. Dez. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from a chargor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 19. März 2005 Geliefert am 01. Apr. 2005 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due by any group company to the security beneficiaries (or any of them) on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben The elms hotel london road retford notti. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 02. Mai 2003 Geliefert am 09. Mai 2003 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to any of the beneficiaries | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental deed supplemental to a composite guarantee and debenture dated 7TH august 2000 | Erstellt am 18. Aug. 2000 Geliefert am 21. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All moneys and obligations and liabilities due owing or incurred to the chargee (on behalf of itself and the banks and financial institutions from time to time parties to the secured documents) and to the finance parties by it or any other chargor under the secured documents (as defined) | |
Kurze Angaben As described in the composite guarantee and debenture save that the title for site no 48 in the table for freehold properties shall be deleted and replaced with CH445871 and CH432365 and the title for site no 34 in the table for l/h properties shall be deleted and replaced with GM781708. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Composite guarantee and debenture | Erstellt am 07. Aug. 2000 Geliefert am 21. Aug. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies obligations and liabilities from time to time due owing or incurred by the company to the royal bank of scotland PLC (as security trustee on behalf of itself and the banks and the financial institutions from time to time parties to the secured documents) under or pursuant to the secured documents (as defined) as the same may be amended,varied,novated,supplemented or replaced and this debenture | |
Kurze Angaben See form 395 for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Supplemental mortgage debenture | Erstellt am 27. Nov. 1997 Geliefert am 05. Dez. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever as defined in a facilities agreement dated 16TH september 1996 | |
Kurze Angaben F/H and l/h land and buildings k/a the elms hotel london road retford nottinghamshire t/no NT295236. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 25. Okt. 1995 Geliefert am 27. Okt. 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £29,500 and all other monies due or to become due from the company to the chargee and/or its present or future subsidiary companies or any other person nominated by the company or their assigns under the terms of the charge | |
Kurze Angaben Elms hotel london road retford, all fixtures and fittings (not being personal chattel within the bills of sale acts) the goodwill of the businessand the benefit of the justices licence. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal and floating charge | Erstellt am 27. Mai 1994 Geliefert am 14. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £53,000 and all other monies due from the company to the chargee and/or its then or future subsidiary companies | |
Kurze Angaben The elms hotel retford nottinghamshire & fixtures & fittings the goodwill of the business the benefit of all licences & a floating charge. Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 27. Mai 1994 Geliefert am 08. Juni 1994 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a the elms hotel london road retford nottinghamshire and the proceeds of sale. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment and an assignment of the goodwill and connection of any business together with the full benefit of all licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 23. Okt. 1987 Geliefert am 12. Nov. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H "the croft" london rd, retford nottingham and the proceeds of sale thereof.. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 30. Juni 1978 Geliefert am 21. Juli 1978 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Piece of land forming part of the garden of no.219 Chellaston road, shelton lock, derby with the bungalow erected thereon. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat GOLDEN PHEASANT RESTAURANT LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | |||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0