MANOR PROPERTY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Jahresabschluss
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameMANOR PROPERTY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01382764
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von MANOR PROPERTY LIMITED?

    • Entwicklung von Bauprojekten (41100) / Bauwesen

    Wo befindet sich MANOR PROPERTY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von MANOR PROPERTY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    TOWERMANOR LIMITED08. Aug. 197808. Aug. 1978

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MANOR PROPERTY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. Dez. 2011

    Wie lautet der Status des letzten Jahresabschlusses für MANOR PROPERTY LIMITED?

    Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss

    Welche sind die letzten Einreichungen für MANOR PROPERTY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 12. Dez. 2014

    22 Seiten2.24B

    Mitteilung über den Übergang von der Verwaltung zur Auflösung am 12. Dez. 2014

    22 Seiten2.35B

    Fortschrittsbericht des Verwalters bis 19. Juni 2014

    19 Seiten2.24B

    Beendigung der Bestellung von David Griffiths als Geschäftsführer am 24. Juni 2014

    4 SeitenTM01

    Mitteilung über die fiktive Genehmigung der Vorschläge

    1 SeitenF2.18

    Vorschlag des Verwalters

    35 Seiten2.17B

    Vermögensübersicht mit Formular 2.14B

    7 Seiten2.16B

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Office 41 Woodgates Lane North Ferriby East Yorkshire HU14 3JY am 05. Jan. 2014

    2 SeitenAD01

    Ernennung eines Verwalters

    2 Seiten2.12B

    Beendigung der Bestellung eines Geschäftsführers

    2 SeitenTM01
    Anmerkungen
    DatumAnmerkung
    27. Dez. 2013The form is a duplicate of the TM01 registered on 09/12/2013

    Beendigung der Bestellung von William Henry Addy als Geschäftsführer am 30. Nov. 2013

    1 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von John Barnes als Geschäftsführer am 30. Sept. 2013

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Mr David Griffiths als Direktor am 01. Juni 2013

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Manor Holdings International Ltd als Direktor am 11. Sept. 2013

    3 SeitenAP02

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Aug. 2013

    19 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital18. Sept. 2013

    Kapitalaufstellung am 18. Sept. 2013

    • Kapital: GBP 50,000
    SH01

    Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 31. Dez. 2012 bis 30. Juni 2013

    3 SeitenAA01

    Beendigung der Bestellung von Imco Secretary Limited als Sekretär am 02. Aug. 2013

    2 SeitenTM02

    Geänderte Geschäftsanschrift vom Riverside East 2 Millsands Sheffield South Yorkshire S3 8DT am 07. Aug. 2013

    2 SeitenAD01

    Ernennung von Mark Andrew Bailey als Direktor am 10. Okt. 2012

    3 SeitenAP01

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 31. Dez. 2011

    5 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 26. Aug. 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    17 SeitenAR01

    Ernennung von Mr John Barnes als Direktor am 08. Aug. 2012

    3 SeitenAP01

    Ernennung von Imco Secretary Limited als Sekretär am 16. Feb. 2012

    3 SeitenAP04

    Geänderte Geschäftsanschrift vom The Office 41 Woodgates Lane North Ferriby North Humberside HU14 3JY United Kingdom am 23. Feb. 2012

    2 SeitenAD01

    Wer sind die Geschäftsführer von MANOR PROPERTY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    AKRILL, Susan Penny Anne
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    EnglandEnglish111841670002
    BAILEY, Mark Andrew
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    EnglandBritish147036330001
    LANE, Robert Shales
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    EnglandBritish82808830001
    RIX, David Hilaire
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    United KingdomBritish148392520001
    MANOR HOLDINGS INTERNATIONAL LTD
    c/o Hassans
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57-63
    Gibraltar
    Geschäftsführer
    c/o Hassans
    Line Wall Road
    Gibraltar
    57-63
    Gibraltar
    RechtsformLIMITED COMPANY
    Art des AusweisesNicht-EWR
    RechtsgrundlageGIBRALTAR
    RegistrierungsnummerGICO 109451-78
    181701430001
    DENT, Andrew James
    3 Marshall Avenue
    Willerby
    HU10 6LL Hull
    North Humberside
    Sekretär
    3 Marshall Avenue
    Willerby
    HU10 6LL Hull
    North Humberside
    British78549900001
    GORDON, Anton Joel
    Main Street
    Shadwell
    LS17 8LA Leeds
    223
    West Yorkshire
    Sekretär
    Main Street
    Shadwell
    LS17 8LA Leeds
    223
    West Yorkshire
    British34929600002
    JOHNSON, Andrew Kevin
    Holderness House
    Market Place
    HU15 2AT South Cave
    North Humberside
    Sekretär
    Holderness House
    Market Place
    HU15 2AT South Cave
    North Humberside
    British37704690002
    IMCO SECRETARY LIMITED
    c/o Irwin Mitchell Llp
    Wellington Place
    LS1 4BZ Leeds
    2
    West Yorkshire
    England
    Sekretär
    c/o Irwin Mitchell Llp
    Wellington Place
    LS1 4BZ Leeds
    2
    West Yorkshire
    England
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer44449984
    167272620001
    LUPFAW SECRETARIAL LIMITED
    Yorkshire House
    East Parade
    LS1 5BD Leeds
    Lupton Fawcett,
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Sekretär
    Yorkshire House
    East Parade
    LS1 5BD Leeds
    Lupton Fawcett,
    West Yorkshire
    United Kingdom
    Art des AusweisesEuropäischer Wirtschaftsraum
    Registrierungsnummer04077390
    150192860001
    MANOR ADMINISTRATION LIMITED
    The Office
    41 Woodgates Lane
    HU14 3JY North Ferriby
    North Humberside
    Sekretär
    The Office
    41 Woodgates Lane
    HU14 3JY North Ferriby
    North Humberside
    119092430001
    SWANLAND HALL SECRETARIES LTD
    Providence House Navigation Road
    Burslem
    ST6 3BQ Stoke On Trent
    Sekretär
    Providence House Navigation Road
    Burslem
    ST6 3BQ Stoke On Trent
    42321320001
    ADDY, William Henry
    41 Woodgates Lane
    HU14 3JY North Ferriby
    The Office
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    41 Woodgates Lane
    HU14 3JY North Ferriby
    The Office
    East Yorkshire
    United KingdomBritish75193160003
    AKRILL, Amanda Jane
    8 Castle Hill
    LN1 3AA Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    8 Castle Hill
    LN1 3AA Lincoln
    Lincolnshire
    British40608240002
    AKRILL, Philip Robert
    41 Woodgates Lane
    North Ferriby
    HU14 3JY Hull
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    41 Woodgates Lane
    North Ferriby
    HU14 3JY Hull
    East Yorkshire
    EnglandBritish41447310002
    BARNES, John
    41 Woodgates Lane
    HU14 3JY North Ferriby
    The Office
    East Yorkshire
    Geschäftsführer
    41 Woodgates Lane
    HU14 3JY North Ferriby
    The Office
    East Yorkshire
    United KingdomBritish31573990001
    CARO, Michael Jon
    96 Station Road
    Waddington
    LN5 9QS Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    96 Station Road
    Waddington
    LN5 9QS Lincoln
    Lincolnshire
    British45536180003
    FIELDSEND, Richard Michael
    South Lawn House
    Aisthorpe
    LN1 2SG Lincoln
    Lincolnshire
    Geschäftsführer
    South Lawn House
    Aisthorpe
    LN1 2SG Lincoln
    Lincolnshire
    EnglandBritish16358690004
    GALBRAITH, David Benjamin
    63 Wolfreton Garth
    Kirk Ella
    HU10 7AB Hull
    North Humberside
    Geschäftsführer
    63 Wolfreton Garth
    Kirk Ella
    HU10 7AB Hull
    North Humberside
    British46704630002
    GALBRAITH, David Benjamin
    69 Oaklands Drive
    Willerby
    HU10 6BJ Hull
    North Humberside
    Geschäftsführer
    69 Oaklands Drive
    Willerby
    HU10 6BJ Hull
    North Humberside
    British46704630001
    GRIFFITHS, David
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    City Square
    LS1 2AL Leeds
    1
    West Yorkshire
    EnglandBritish63817680001
    MARTIN, Robert William
    c/o Lupton Fawcett
    East Parade
    LS1 5BD Leeds
    Yorkshire House
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    c/o Lupton Fawcett
    East Parade
    LS1 5BD Leeds
    Yorkshire House
    West Yorkshire
    UkBritish148392350001
    TURNER, David Kevin
    Brook House
    Longwater Lane
    RG11 4NT Finchampstead
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Brook House
    Longwater Lane
    RG11 4NT Finchampstead
    Berkshire
    British35307490002

    Hat MANOR PROPERTY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Legal mortgage
    Erstellt am 26. Mai 2005
    Geliefert am 04. Juni 2005
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Land on the west side of ladysmith road grimsby.
    Berechtigte Personen
    • Philip Robert Akrill and Amanda Jane Akrill
    Transaktionen
    • 04. Juni 2005Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 27. Feb. 2003
    Geliefert am 07. März 2003
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at melton/welton east yorkshire. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 07. März 2003Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 01. Mai 2002
    Geliefert am 03. Mai 2002
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Property k/a land on the west side of ladysmith road grimsby north east lincolnshire t/n HS293841. By way of fixed charge the benefit of all covenants and rights concerning the property and plant machinery fixtures fittings furniture equipment implements and utensils the goodwill of any business carried on at the property and the proceeds of any insurance affecting the property or assets.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC
    Transaktionen
    • 03. Mai 2002Registrierung einer Belastung (395)
    • 28. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 13. Juli 2001
    Geliefert am 26. Juli 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage land on the west side of ladysmith road grimsby t/n HS293841. Assigns the goodwill of all businesses from time to time carried on at the property with the benefit of all authorisations permits registration certificates or licences of any kind also by way of fixed charge the equipment and goods (if any) and all other fixtures fittings plant and machinery and by way of floating charge on other moveable plant machinery furniture equipment goods and other effects which from time to time on the property.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 02. Okt. 2003Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Apr. 2001
    Geliefert am 11. Mai 2001
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Yorkshire Bank PLC
    Transaktionen
    • 11. Mai 2001Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Mai 2002Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security
    Erstellt am 20. Apr. 1995
    Geliefert am 26. Apr. 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All and whole that area or pice of land in the city od edingburgh and the county of midlothian forming part of the subjects formerly k/a craigmillar creamery and lying on the south side of the road leading from edinburgh to musselburgh called niddrie mains road. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Apr. 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 23. Okt. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 27. Feb. 1995
    Geliefert am 02. März 1995
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank P.L.C.
    Transaktionen
    • 02. März 1995Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Nov. 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security
    Erstellt am 20. Juli 1993
    Geliefert am 10. Aug. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the guarantee of even date
    Kurze Angaben
    The property as detailed on the reverse of the form M395 ref M887C & continuation sheets.
    Berechtigte Personen
    • Rdm Factors Limited
    Transaktionen
    • 10. Aug. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 22. Sept. 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security
    Erstellt am 19. Juli 1993
    Geliefert am 29. Juli 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    All and whole that plot or area of ground extending to two thousand seven hundred and sixty five square feet or thereby being the plot or area of ground described on a plan.together with the fixtures and fittings. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 29. Juli 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 31. Dez. 1996Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Standard security
    Erstellt am 07. Jan. 1993
    Geliefert am 14. Jan. 1993
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Cold store at 98 niddrie mains road, craigmillar, edinburgh forming part of the subjects commonly k/a craigmillar creamery and lying on the south side of the road leading from edinburgh to mussleburgh (for full details see form 395 tc ref: M40C).
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 14. Jan. 1993Registrierung einer Belastung (395)
    • 17. Okt. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Dez. 1991
    Geliefert am 21. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at borrowash road derby t/n dy 121725.
    Berechtigte Personen
    • Darwin Limited
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. Dez. 1991
    Geliefert am 21. Dez. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land at derby road derby t/n dy 54902.
    Berechtigte Personen
    • Darwin Limited
    Transaktionen
    • 21. Dez. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 07. Dez. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. Apr. 1991
    Geliefert am 10. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Land at borrowash road spondon t/no: dy 121725.
    Berechtigte Personen
    • Darwin Limited
    Transaktionen
    • 10. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 18. Juli 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 09. Feb. 1988
    Geliefert am 29. Feb. 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H, l/h property k/as 164 derby road borrowash, derby title no. Dy 54902 together with all buildings & fixtures thereon. The goodwill of the business. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 29. Feb. 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 02. März 1987
    Geliefert am 10. März 1987
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £140,000 all monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of a principal charge.
    Kurze Angaben
    F/H property k/a spondon leisure centre, derby road, spondon, derbyshire title no. Dy 121726.
    Berechtigte Personen
    • Manns Northampton Brewery Company Limited.
    Transaktionen
    • 10. März 1987Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 11. Sept. 1986
    Geliefert am 15. Sept. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the east side of borrowash rd, spondon.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Sept. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 05. Sept. 1986
    Geliefert am 08. Sept. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a spondon leisure centre borrowash road, spondon derby.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 08. Sept. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 06. März 1985
    Geliefert am 08. März 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £100,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H spondon leisure centre derby road spondon derbyshire T.N. dy 121726.
    Berechtigte Personen
    • Manns Northampton Brewery Company Limited
    Transaktionen
    • 08. März 1985Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 03. Dez. 1984
    Geliefert am 07. Dez. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £37,519 and all monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north side of derby road spondon k/a spondon leisure centre t/n:- dy 121726.
    Berechtigte Personen
    • Manns Northampton Brewery Company Limited.
    Transaktionen
    • 07. Dez. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 20. Nov. 1984
    Geliefert am 26. Nov. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land on the east side of borrowash road spondon derby, derbyshire t/n:- dy 121725.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Nov. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 29. März 1984
    Geliefert am 05. Apr. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H the maltings, anglesey road, burton on trent, staffordshire.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Apr. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 28. Feb. 1983
    Geliefert am 09. März 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All those pieces of land together with the buildings situate in borrowash road, spondon, derbyshire. (Freehold).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 09. März 1983Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 07. Jan. 1982
    Geliefert am 14. Jan. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H premises situate at clarke street, derby T. no. Dy 25255.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Jan. 1982Registrierung einer Belastung

    Hat MANOR PROPERTY LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    20. Dez. 2013Beginn der Verwaltung
    12. Dez. 2014Ende der Verwaltung
    In Verwaltung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Daniel Francis Butters
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Praktiker
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    West Yorkshire
    Adrian Peter Berry
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds
    Praktiker
    Deloitte Llp
    1 City Square
    LS1 2AL Leeds

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0