RIVA GROUP LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameRIVA GROUP LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01384967
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von RIVA GROUP LIMITED?

    • (7415) /

    Wo befindet sich RIVA GROUP LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    Torex Houghton Hall Park
    Houghton Regis
    LU5 5YG Dunstable
    Bedfordshire
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von RIVA GROUP LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    RIVA COMPUTER SERVICES LIMITED SLATER HEELIS MANCHESTER21. Aug. 197821. Aug. 1978

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RIVA GROUP LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis30. Juni 2011

    Welche sind die letzten Einreichungen für RIVA GROUP LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    3 SeitenDS01
    A13AX6AZ

    Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2011

    6 SeitenAA
    AGNIVZQF

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital06. Sept. 2011

    Kapitalaufstellung am 06. Sept. 2011

    • Kapital: GBP 5,707,603.2
    SH01
    XOCLJXB9

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010

    14 SeitenAA
    LFL5DP7Z

    Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    4 SeitenAR01
    XYMTPMM7

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009

    13 SeitenAA
    LQNN9IQ2

    Beendigung der Bestellung von Kirk Isaacson als Sekretär

    1 SeitenTM02
    X2N88ICW

    Beendigung der Bestellung von Kirk Isaacson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01
    X2N7UICH

    legacy

    1 Seiten288a
    XF0OVDJR

    legacy

    1 Seiten288a
    XF0PRDJO

    legacy

    1 Seiten288b
    XF0O1DJX

    legacy

    3 Seiten363a
    X4HEWCIM

    Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008

    13 SeitenAA
    L9X5I7F0

    Eröffnungsbilanz

    4 SeitenSA
    RYQMY5VZ

    legacy

    2 Seiten88(2)
    APL7O5WG

    legacy

    2 Seiten88(2)
    APL7P5WH

    legacy

    1 Seiten403a
    ADCVZ50Y

    Beschlüsse

    Resolutions
    2 SeitenRESOLUTIONS
    Beschlüsse
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital

    Beschluss zur Zuteilung von Wertpapieren

    RES10

    Eröffnungsbilanz

    4 SeitenSA
    AN5694J4

    legacy

    2 Seiten88(2)
    AN5684J3

    legacy

    2 Seiten88(2)
    AWRTM46M

    legacy

    3 Seiten363a
    XQD222Z5

    legacy

    1 Seiten353
    XQD202Z3

    Wer sind die Geschäftsführer von RIVA GROUP LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    GRADDEN, Amanda Jane
    Flat 2 10a Market Mews
    W1J 7BZ London
    Geschäftsführer
    Flat 2 10a Market Mews
    W1J 7BZ London
    EnglandBritishChartered Accountant77425910003
    ALEXANDER, Neil Brough
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    Sekretär
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    British3699700001
    COOKSLEY, Graeme Roy
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    Sekretär
    Chamer Russweg 19
    6300 Zug
    Switzerland
    New ZealanderCompany Director126903810001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Sekretär
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector109926660001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Sekretär
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    OtherGeneral Counsel123425810001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Sekretär
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    OtherDirector123425810001
    JOHNSON, Robin Simon
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    Sekretär
    25 Thirlmere Road
    Muswell Hill
    N10 2DL London
    British11498320001
    JONES, Stephen Philip
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    Sekretär
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    British39173700002
    LEEK, Marcus
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    Sekretär
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    BritishCompany Director115960470001
    ALEXANDER, Neil Brough
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    Geschäftsführer
    Brook House Osbaston
    SY10 8HT Oswestry
    Shropshire
    BritishChartered Accountant3699700001
    BENDALL, David Austin
    18 Lower Common South
    SW15 1BP London
    Geschäftsführer
    18 Lower Common South
    SW15 1BP London
    BritishCompany Director71776320001
    BERRY, John Walter
    69 Albert Road
    Stechford
    B33 8AG Birmingham
    West Midlands
    Geschäftsführer
    69 Albert Road
    Stechford
    B33 8AG Birmingham
    West Midlands
    BritishCompany Director6358830002
    BRIGGS, Paul Andrew
    29 Hawthorn Avenue
    SK9 5BR Wilmslow
    Cheshire
    Geschäftsführer
    29 Hawthorn Avenue
    SK9 5BR Wilmslow
    Cheshire
    BritishCompany Director39980140003
    BUTCHER, Steve John
    Lower Laithe Cottage
    Providence Lane, Oakworth
    BD22 7QS Keighley
    West Yorkshire
    Geschäftsführer
    Lower Laithe Cottage
    Providence Lane, Oakworth
    BD22 7QS Keighley
    West Yorkshire
    United KingdomBritishManaging Director203318870001
    COOKSLEY, Graeme
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    Geschäftsführer
    19 Charmer Fussweg
    Zug
    6300
    Switzerland
    New ZealanderDirector122786180001
    CUMMINS, Andrew Douglas
    4 Argyll Road
    W8 7DB London
    Geschäftsführer
    4 Argyll Road
    W8 7DB London
    AustralianDirector1803330001
    CUMMINS, Andrew Douglas
    4 Argyll Road
    W8 7DB London
    Geschäftsführer
    4 Argyll Road
    W8 7DB London
    AustralianDirector1803330001
    DACE, David John
    Yew Tree Cottage
    Troutbeck
    LA23 1PL Windermere
    Cumbria
    Geschäftsführer
    Yew Tree Cottage
    Troutbeck
    LA23 1PL Windermere
    Cumbria
    BritishDirector60504740001
    DAWSON, Iain Norman
    17 Mayfield Close
    Holcombe Brook
    BL0 9TL Bury
    Lancashire
    Geschäftsführer
    17 Mayfield Close
    Holcombe Brook
    BL0 9TL Bury
    Lancashire
    EnglandBritishAcc/Finance Dir54428410001
    DOWNES, Paul William Edwin
    Seven Acres
    Horsell Common
    GU21 4XY Woking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Seven Acres
    Horsell Common
    GU21 4XY Woking
    Surrey
    United KingdomBritishChartered Accountant18135910002
    FOULKES, John Harold
    Cank Farmhouse
    Welford Road
    NN6 8AH Chapel Brampton
    Northamptonshire
    Geschäftsführer
    Cank Farmhouse
    Welford Road
    NN6 8AH Chapel Brampton
    Northamptonshire
    BritishDirector1657980007
    GILES, Peter Hardwick
    Arden House Lamb Lane
    Ashley
    WA14 3QG Altrincham
    Cheshire
    Geschäftsführer
    Arden House Lamb Lane
    Ashley
    WA14 3QG Altrincham
    Cheshire
    EnglandBritishCompany Director35521860001
    GREENHALGH, Michael
    8 Bective Road
    Putney
    SW15 2QA London
    Geschäftsführer
    8 Bective Road
    Putney
    SW15 2QA London
    British38402170001
    GREENOUGH, Michael
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    Geschäftsführer
    711 Pintail Court
    Granbury
    Texas 76049
    Usa
    CanadianDirector123427350001
    HORN, Nigel David
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    Featherbow House
    Ratley
    OX15 6DS Banbury
    Oxfordshire
    BritishDirector109926660001
    ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr.
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    Geschäftsführer
    1110 Fox Glen Drive
    St Charles
    Illinois 60174
    Usa
    UsaOtherDirector123425810001
    JONES, Stephen Philip
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    Geschäftsführer
    11 Pownall Avenue
    Bramhall
    SK7 2HE Stockport
    Cheshire
    EnglandBritishAccountant39173700002
    KELSO, Stuart James
    1 Osten Mews
    South Kensington
    SW7 4HW London
    Geschäftsführer
    1 Osten Mews
    South Kensington
    SW7 4HW London
    AustralianDirector1803350001
    LEEK, Marcus
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    7 Gloster Drive
    CV8 2TU Kenilworth
    Warwickshire
    BritishCompany Director115960470001
    MEADE, Michael Gerald
    54 Clapham Common North Side
    SW4 9RX London
    Geschäftsführer
    54 Clapham Common North Side
    SW4 9RX London
    EnglandBritish,IrishFinance Director142059750001
    MILNE, Thomas Adam
    19 Barnfield
    Urmston
    M41 9EW Manchester
    Lancashire
    Geschäftsführer
    19 Barnfield
    Urmston
    M41 9EW Manchester
    Lancashire
    United KingdomBritishDirector14460430001
    MITCHELL, Robert Neil Whyte
    50 Leckford Road
    Jericho
    OX2 6HY Oxford
    Oxfordshire
    Geschäftsführer
    50 Leckford Road
    Jericho
    OX2 6HY Oxford
    Oxfordshire
    BritishCompany Director116745740001
    NICHOLSON, Peter Charles
    Pinetrees Woodside Road
    KT11 2QR Cobham
    Surrey
    Geschäftsführer
    Pinetrees Woodside Road
    KT11 2QR Cobham
    Surrey
    EnglandBritishBanker13725560001
    PEARMAN, Mark Chalice
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    Geschäftsführer
    The Old Rectory
    Honiley
    CV8 1NP Kenilworth
    Warwickshire
    United KingdomBritishDirector57516220003
    PETRIE, Alastair Scott Andrew
    48 Brookland Drive
    Goostrey
    CW4 8JD Crewe
    Cheshire
    Geschäftsführer
    48 Brookland Drive
    Goostrey
    CW4 8JD Crewe
    Cheshire
    BritishDirector15131910001

    Hat RIVA GROUP LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Mortgage of shares
    Erstellt am 05. Jan. 2006
    Geliefert am 13. Jan. 2006
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge
    Kurze Angaben
    First legal mortgage all the shares,first fixed charge all related rights. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Royal Bank of Scotland PLC (The Facility Agent)
    Transaktionen
    • 13. Jan. 2006Registrierung einer Belastung (395)
    • 21. Nov. 2008Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture (the agreement)
    Erstellt am 28. Jan. 2000
    Geliefert am 09. Feb. 2000
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the finance documents (including the agreement)
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Commerzbank Ag London Branchas Trustee for the Beneficiaries (As Defined Inschedule 1)
    Transaktionen
    • 09. Feb. 2000Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. März 2006Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 18. Aug. 1999
    Geliefert am 24. Aug. 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank PLC
    Transaktionen
    • 24. Aug. 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of adherence
    Erstellt am 12. Mai 1992
    Geliefert am 14. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter dated 13 april 1992 the composite debenture dated 26 april 1990 and any other security documents
    Kurze Angaben
    The charged assets as defined in the original charge.
    Berechtigte Personen
    • Fbg Holdings (UK) Limitedpreviously Elders Ixl Holdings (UK) Limited
    Transaktionen
    • 14. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Second supplemental deed
    Erstellt am 12. Mai 1992
    Geliefert am 14. Mai 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter dated 13TH april 1992 the composite debenture dated 26 april 1990 as amended by supplemental deed dated 12 august 1991,or any other security document (as defined)
    Kurze Angaben
    The charges and assignments contained inclause 2 of the original charge dated 26 april 1990.
    Berechtigte Personen
    • Fbg Holdings (UK) Limitedpreviously Elders Ixl Holdings (UK) Limited
    Transaktionen
    • 14. Mai 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 06. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 13. Apr. 1992
    Geliefert am 30. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of each of the finance documents as defined
    Kurze Angaben
    See form 395 ref M89. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank Plcmilneas Agent and Trustee for Itself the Banks and Mr
    Transaktionen
    • 30. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 08. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental deed
    Erstellt am 12. Aug. 1991
    Geliefert am 20. Aug. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter dated 23RD april 1990 and any order security document (as defined).
    Kurze Angaben
    (See form 395. ref m 124 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Fbg Holdings (UK) Limited
    Transaktionen
    • 20. Aug. 1991Registrierung einer Belastung
    • 06. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Supplemental debenture
    Erstellt am 13. Mai 1991
    Geliefert am 29. Mai 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under each of the finance documents as defined
    Kurze Angaben
    (See doc M149 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Co-Operative Bank P.L.C.
    Transaktionen
    • 29. Mai 1991Registrierung einer Belastung
    • 08. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & mortgage debenture
    Erstellt am 26. Apr. 1990
    Geliefert am 08. Mai 1990
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter and this charge and any other security document
    Kurze Angaben
    (See doc M227 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences.
    Berechtigte Personen
    • Elders Ixl Holdings (UK) Limited
    Transaktionen
    • 08. Mai 1990Registrierung einer Belastung
    • 06. Jan. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture
    Erstellt am 09. Nov. 1989
    Geliefert am 30. Nov. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due etc. from hugin sweda group (as defined) under the terms of each of the finance documents and/or the swedish loan agreements as defined,to the chargee.
    Kurze Angaben
    All dividends paid or payable after the date of the debenture and all or any of the shares and all stocks, shares, securities (and the dividends or interest thereon) rights, money or property (see form M395 ref. M850C for full details).
    Berechtigte Personen
    • The Co-Operative Bank Plcas Agent for & on Behalf of the Banks,as Defined
    Transaktionen
    • 30. Nov. 1989Registrierung einer Belastung
    • 08. Feb. 2000Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 13. Juli 1981
    Geliefert am 20. Juli 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over goodwill & all fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery & heritable property in scotland (see doc M16). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • Lloyds Bank PLC
    Transaktionen
    • 20. Juli 1981Registrierung einer Belastung
    • 25. Aug. 1995Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0