RIVA GROUP LIMITED
Überblick
Unternehmensname | RIVA GROUP LIMITED |
---|---|
Unternehmensstatus | Aufgelöst |
Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
Unternehmensnummer | 01384967 |
Gerichtsbarkeit | England/Wales |
Gründungsdatum | |
Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
Hat Super Secure PSCs | Nein |
---|---|
Hat Belastungen | Ja |
Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von RIVA GROUP LIMITED?
- (7415) /
Wo befindet sich RIVA GROUP LIMITED?
Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Torex Houghton Hall Park Houghton Regis LU5 5YG Dunstable Bedfordshire |
---|---|
Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von RIVA GROUP LIMITED?
Unternehmensname | Von | Bis |
---|---|---|
RIVA COMPUTER SERVICES LIMITED SLATER HEELIS MANCHESTER | 21. Aug. 1978 | 21. Aug. 1978 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von RIVA GROUP LIMITED?
Letzter Jahresabschluss | |
---|---|
Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 30. Juni 2011 |
Welche sind die letzten Einreichungen für RIVA GROUP LIMITED?
Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresabschluss mit vollständiger Befreiung für kleine Unternehmen erstellt bis zum 30. Juni 2011 | 6 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2010 | 14 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 13. Aug. 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 4 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2009 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kirk Isaacson als Sekretär | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Kirk Isaacson als Geschäftsführer | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 30. Juni 2008 | 13 Seiten | AA | ||||||||||
Eröffnungsbilanz | 4 Seiten | SA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 88(2) | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 88(2) | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Eröffnungsbilanz | 4 Seiten | SA | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 88(2) | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 88(2) | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von RIVA GROUP LIMITED?
Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
GRADDEN, Amanda Jane | Geschäftsführer | Flat 2 10a Market Mews W1J 7BZ London | England | British | Chartered Accountant | 77425910003 | ||||
ALEXANDER, Neil Brough | Sekretär | Brook House Osbaston SY10 8HT Oswestry Shropshire | British | 3699700001 | ||||||
COOKSLEY, Graeme Roy | Sekretär | Chamer Russweg 19 6300 Zug Switzerland | New Zealander | Company Director | 126903810001 | |||||
HORN, Nigel David | Sekretär | Featherbow House Ratley OX15 6DS Banbury Oxfordshire | British | Director | 109926660001 | |||||
ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr. | Sekretär | 1110 Fox Glen Drive St Charles Illinois 60174 Usa | Other | General Counsel | 123425810001 | |||||
ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr. | Sekretär | 1110 Fox Glen Drive St Charles Illinois 60174 Usa | Other | Director | 123425810001 | |||||
JOHNSON, Robin Simon | Sekretär | 25 Thirlmere Road Muswell Hill N10 2DL London | British | 11498320001 | ||||||
JONES, Stephen Philip | Sekretär | 11 Pownall Avenue Bramhall SK7 2HE Stockport Cheshire | British | 39173700002 | ||||||
LEEK, Marcus | Sekretär | 7 Gloster Drive CV8 2TU Kenilworth Warwickshire | British | Company Director | 115960470001 | |||||
ALEXANDER, Neil Brough | Geschäftsführer | Brook House Osbaston SY10 8HT Oswestry Shropshire | British | Chartered Accountant | 3699700001 | |||||
BENDALL, David Austin | Geschäftsführer | 18 Lower Common South SW15 1BP London | British | Company Director | 71776320001 | |||||
BERRY, John Walter | Geschäftsführer | 69 Albert Road Stechford B33 8AG Birmingham West Midlands | British | Company Director | 6358830002 | |||||
BRIGGS, Paul Andrew | Geschäftsführer | 29 Hawthorn Avenue SK9 5BR Wilmslow Cheshire | British | Company Director | 39980140003 | |||||
BUTCHER, Steve John | Geschäftsführer | Lower Laithe Cottage Providence Lane, Oakworth BD22 7QS Keighley West Yorkshire | United Kingdom | British | Managing Director | 203318870001 | ||||
COOKSLEY, Graeme | Geschäftsführer | 19 Charmer Fussweg Zug 6300 Switzerland | New Zealander | Director | 122786180001 | |||||
CUMMINS, Andrew Douglas | Geschäftsführer | 4 Argyll Road W8 7DB London | Australian | Director | 1803330001 | |||||
CUMMINS, Andrew Douglas | Geschäftsführer | 4 Argyll Road W8 7DB London | Australian | Director | 1803330001 | |||||
DACE, David John | Geschäftsführer | Yew Tree Cottage Troutbeck LA23 1PL Windermere Cumbria | British | Director | 60504740001 | |||||
DAWSON, Iain Norman | Geschäftsführer | 17 Mayfield Close Holcombe Brook BL0 9TL Bury Lancashire | England | British | Acc/Finance Dir | 54428410001 | ||||
DOWNES, Paul William Edwin | Geschäftsführer | Seven Acres Horsell Common GU21 4XY Woking Surrey | United Kingdom | British | Chartered Accountant | 18135910002 | ||||
FOULKES, John Harold | Geschäftsführer | Cank Farmhouse Welford Road NN6 8AH Chapel Brampton Northamptonshire | British | Director | 1657980007 | |||||
GILES, Peter Hardwick | Geschäftsführer | Arden House Lamb Lane Ashley WA14 3QG Altrincham Cheshire | England | British | Company Director | 35521860001 | ||||
GREENHALGH, Michael | Geschäftsführer | 8 Bective Road Putney SW15 2QA London | British | 38402170001 | ||||||
GREENOUGH, Michael | Geschäftsführer | 711 Pintail Court Granbury Texas 76049 Usa | Canadian | Director | 123427350001 | |||||
HORN, Nigel David | Geschäftsführer | Featherbow House Ratley OX15 6DS Banbury Oxfordshire | British | Director | 109926660001 | |||||
ISAACSON, Kirk Jeffrey, Mr. | Geschäftsführer | 1110 Fox Glen Drive St Charles Illinois 60174 Usa | Usa | Other | Director | 123425810001 | ||||
JONES, Stephen Philip | Geschäftsführer | 11 Pownall Avenue Bramhall SK7 2HE Stockport Cheshire | England | British | Accountant | 39173700002 | ||||
KELSO, Stuart James | Geschäftsführer | 1 Osten Mews South Kensington SW7 4HW London | Australian | Director | 1803350001 | |||||
LEEK, Marcus | Geschäftsführer | 7 Gloster Drive CV8 2TU Kenilworth Warwickshire | British | Company Director | 115960470001 | |||||
MEADE, Michael Gerald | Geschäftsführer | 54 Clapham Common North Side SW4 9RX London | England | British,Irish | Finance Director | 142059750001 | ||||
MILNE, Thomas Adam | Geschäftsführer | 19 Barnfield Urmston M41 9EW Manchester Lancashire | United Kingdom | British | Director | 14460430001 | ||||
MITCHELL, Robert Neil Whyte | Geschäftsführer | 50 Leckford Road Jericho OX2 6HY Oxford Oxfordshire | British | Company Director | 116745740001 | |||||
NICHOLSON, Peter Charles | Geschäftsführer | Pinetrees Woodside Road KT11 2QR Cobham Surrey | England | British | Banker | 13725560001 | ||||
PEARMAN, Mark Chalice | Geschäftsführer | The Old Rectory Honiley CV8 1NP Kenilworth Warwickshire | United Kingdom | British | Director | 57516220003 | ||||
PETRIE, Alastair Scott Andrew | Geschäftsführer | 48 Brookland Drive Goostrey CW4 8JD Crewe Cheshire | British | Director | 15131910001 |
Hat RIVA GROUP LIMITED Belastungen?
Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
---|---|---|---|---|
Mortgage of shares | Erstellt am 05. Jan. 2006 Geliefert am 13. Jan. 2006 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from each obligor to any finance party on any account whatsoever under the terms of the aforementioned instrument creating or evidencing the charge | |
Kurze Angaben First legal mortgage all the shares,first fixed charge all related rights. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture (the agreement) | Erstellt am 28. Jan. 2000 Geliefert am 09. Feb. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the finance documents (including the agreement) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 18. Aug. 1999 Geliefert am 24. Aug. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Deed of adherence | Erstellt am 12. Mai 1992 Geliefert am 14. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter dated 13 april 1992 the composite debenture dated 26 april 1990 and any other security documents | |
Kurze Angaben The charged assets as defined in the original charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Second supplemental deed | Erstellt am 12. Mai 1992 Geliefert am 14. Mai 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from thecompany and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter dated 13TH april 1992 the composite debenture dated 26 april 1990 as amended by supplemental deed dated 12 august 1991,or any other security document (as defined) | |
Kurze Angaben The charges and assignments contained inclause 2 of the original charge dated 26 april 1990. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed | Erstellt am 13. Apr. 1992 Geliefert am 30. Apr. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargees under the terms of each of the finance documents as defined | |
Kurze Angaben See form 395 ref M89. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental deed | Erstellt am 12. Aug. 1991 Geliefert am 20. Aug. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee under the terms of a facility letter dated 23RD april 1990 and any order security document (as defined). | |
Kurze Angaben (See form 395. ref m 124 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Supplemental debenture | Erstellt am 13. Mai 1991 Geliefert am 29. Mai 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee under each of the finance documents as defined | |
Kurze Angaben (See doc M149 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Guarantee & mortgage debenture | Erstellt am 26. Apr. 1990 Geliefert am 08. Mai 1990 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever under the terms of the facility letter and this charge and any other security document | |
Kurze Angaben (See doc M227 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Debenture | Erstellt am 09. Nov. 1989 Geliefert am 30. Nov. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due etc. from hugin sweda group (as defined) under the terms of each of the finance documents and/or the swedish loan agreements as defined,to the chargee. | |
Kurze Angaben All dividends paid or payable after the date of the debenture and all or any of the shares and all stocks, shares, securities (and the dividends or interest thereon) rights, money or property (see form M395 ref. M850C for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Mortgage | Erstellt am 13. Juli 1981 Geliefert am 20. Juli 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed & floating charge over goodwill & all fixtures (inc trade fixtures) fixed plant & machinery & heritable property in scotland (see doc M16). Undertaking and all property and assets present and future including uncalled capital. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0