HENDERSON PHARMACY LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameHENDERSON PHARMACY LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01390581
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteNein
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von HENDERSON PHARMACY LIMITED?

    • Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften

    Wo befindet sich HENDERSON PHARMACY LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von HENDERSON PHARMACY LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    P & CE HENDERSON LIMITED25. Sept. 197825. Sept. 1978

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HENDERSON PHARMACY LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2012

    Welche sind die letzten Einreichungen für HENDERSON PHARMACY LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ2(A)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung

    1 SeitenGAZ1(A)

    Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister

    4 SeitenDS01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01
    Verknüpfte Einreichungen
    KategorieDatumBeschreibungTyp
    capital03. Juli 2013

    Kapitalaufstellung am 03. Juli 2013

    • Kapital: GBP 180
    SH01

    Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012

    3 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011

    9 SeitenAA

    Beendigung der Bestellung von Christopher James Giles als Geschäftsführer am 05. Sept. 2011

    1 SeitenTM01

    Ernennung von Mr Mark Francis Muller als Direktor am 05. Sept. 2011

    3 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    6 SeitenAR01

    Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010

    10 SeitenAA

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    5 SeitenAR01

    Ernennung von David Charles Geoffrey Foster als Direktor

    3 SeitenAP01

    Ernennung von David Charles Geoffrey Foster als Sekretär

    3 SeitenAP03

    Beendigung der Bestellung von Mark Muller als Sekretär

    2 SeitenTM02

    Beendigung der Bestellung von Patricia Kennerley als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Christopher Aylward als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Beendigung der Bestellung von Mark Muller als Geschäftsführer

    2 SeitenTM01

    Ernennung von Christopher James Giles als Direktor

    3 SeitenAP01

    Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre

    7 SeitenAR01

    legacy

    1 Seiten190

    legacy

    1 Seiten353

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    1 Seiten403a

    legacy

    2 Seiten403a

    Wer sind die Geschäftsführer von HENDERSON PHARMACY LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Sekretär
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    British150401690001
    FOSTER, David Charles Geoffrey
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Geschäftsführer
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish52040210004
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    Geschäftsführer
    1 Thane Road West
    NG2 3AA Nottingham
    D90
    United KingdomBritish63620010002
    HENDERSON, Cyraine Elizabeth
    10 Brighton Grove
    NE26 1QH Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Sekretär
    10 Brighton Grove
    NE26 1QH Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British16015100002
    HENDERSON, Susan
    53 The Broadway
    Tynemouth
    NE30 2LL North Shields
    Tyne & Wear
    Sekretär
    53 The Broadway
    Tynemouth
    NE30 2LL North Shields
    Tyne & Wear
    British43148360003
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Sekretär
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    British63620010002
    AYLWARD, Christopher David
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell
    Woking
    Geschäftsführer
    Buchan Cottage
    2 Cheapside
    GU21 4JG Horsell
    Woking
    United KingdomBritish59741430002
    GILES, Christopher James
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    Geschäftsführer
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    D90
    EnglandBritish149729660001
    HENDERSON, Cyraine Elizabeth
    10 Brighton Grove
    NE26 1QH Whitley Bay
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    10 Brighton Grove
    NE26 1QH Whitley Bay
    Tyne & Wear
    British16015100002
    HENDERSON, Philip
    53 The Broadway
    Tynemouth
    NE30 2LL North Shields
    Tyne & Wear
    Geschäftsführer
    53 The Broadway
    Tynemouth
    NE30 2LL North Shields
    Tyne & Wear
    United KingdomBritish16015110003
    KENNERLEY, Patricia Diane
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Geschäftsführer
    D90
    1 Thane Road West
    NG90 1BS Nottingham
    Great BritainBritish110727230002
    MULLER, Mark Francis, Mr.
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    Geschäftsführer
    Elm Lodge
    15 Oaken Coppice
    KT21 1DL Ashtead
    Surrey
    United KingdomBritish63620010002

    Hat HENDERSON PHARMACY LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Assignation of goodwill
    Erstellt am 09. März 1999
    Geliefert am 23. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Assigns all the beneficial interest and goodwill of the company in the business(es) carried out or to be carried on by the company at (a) the central pharmacy, 1 cattle market, hexham, northumberland NE46 1NJ (b) abbey chemists 4 hencotes hexham northumberland NE46 2EJ (c) pattinson pharmacy 77 front street prudhoe northumberland NE42 5PU. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 23. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 09. März 1999
    Geliefert am 13. März 1999
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    37/39 queen street amble northumberland t/no.ND99742. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. März 1999Registrierung einer Belastung (395)
    • 24. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 22. Aug. 1997
    Geliefert am 03. Sept. 1997
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 2 dean terrace ryton tyne and wear NE40 3HQ t/no;-TY281871. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 03. Sept. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 11/09/1991
    Erstellt am 02. Sept. 1991
    Geliefert am 13. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities covenanted to be paid or discharged by the company including costs and interest to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H k/a 48/48A front street prudhoe northumberland.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Sept. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 11/09/1991
    Erstellt am 02. Sept. 1991
    Geliefert am 13. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities covenanted to be paid or discharged by the company including costs and interest to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a bridge house 5 & 6 station road bedlington t/n nd 30312.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Sept. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 11/09/91
    Erstellt am 02. Sept. 1991
    Geliefert am 13. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities covenanted to be paid or discharged by the company including costs and interest to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H property k/a 286 & 288 chillingham road, heaton, newcastle upon tyne. T/n TY163202.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Sept. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Debenture as evidenced by a statutory declaration dated 11/09/91
    Erstellt am 02. Sept. 1991
    Geliefert am 13. Sept. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies and liabilities covenanted to be paid or discharged by the company including costs and interest to the chargee
    Kurze Angaben
    F/H & l/h property present & future fixed charge goodwill, uncalled capital,stocks floating charge and. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 13. Sept. 1991Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Sept. 2009Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. Jan. 1991
    Geliefert am 14. Feb. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H all that ground floor shop at premises k/a 6 in the precinct hadston in the county of northumberland & the proceed of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Feb. 1991Registrierung einer Belastung
    • 25. Sept. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Deed of legal mortgage
    Erstellt am 29. Sept. 1989
    Geliefert am 18. Okt. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    286/288 chillingham road heaton, newcastle upon tyne and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 18. Okt. 1989Registrierung einer Belastung
    • 25. Sept. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 31. März 1989
    Geliefert am 16. Apr. 1981
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/Hold, bridge house, bedlington, northumberland. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 16. Apr. 1981Registrierung einer Belastung
    • 25. Sept. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 12. Mai 1986
    Geliefert am 21. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property k/a 7/7A the broadway darras hall porteland newcastle upon tyne and tyne and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    • 25. Sept. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 12. Mai 1986
    Geliefert am 21. Mai 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge on the companys f/h & l/h property and the proceeds of sle thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 21. Mai 1986Registrierung einer Belastung
    • 25. Sept. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal mortgage
    Erstellt am 18. Dez. 1985
    Geliefert am 02. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H 286/288 chillingham road, newcastle upon tyne and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 22. Okt. 1982
    Geliefert am 22. Okt. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H property known as 93 95 and 97 park view whitley bay, tyne and wear and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 22. Okt. 1982Registrierung einer Belastung
    • 25. Sept. 1991Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0