HENDERSON PHARMACY LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | HENDERSON PHARMACY LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01390581 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von HENDERSON PHARMACY LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich HENDERSON PHARMACY LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 1 Thane Road West NG2 3AA Nottingham |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von HENDERSON PHARMACY LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| P & CE HENDERSON LIMITED | 25. Sept. 1978 | 25. Sept. 1978 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von HENDERSON PHARMACY LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2012 |
Welche sind die letzten Einreichungen für HENDERSON PHARMACY LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 4 Seiten | DS01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2013 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2012 | 3 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2012 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2011 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher James Giles als Geschäftsführer am 05. Sept. 2011 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Mark Francis Muller als Direktor am 05. Sept. 2011 | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2011 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 6 Seiten | AR01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2010 | 10 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Ernennung von David Charles Geoffrey Foster als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von David Charles Geoffrey Foster als Sekretär | 3 Seiten | AP03 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Muller als Sekretär | 2 Seiten | TM02 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Patricia Kennerley als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Christopher Aylward als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Mark Muller als Geschäftsführer | 2 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Christopher James Giles als Direktor | 3 Seiten | AP01 | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 01. Juli 2009 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 7 Seiten | AR01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 190 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 353 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 403a | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von HENDERSON PHARMACY LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| FOSTER, David Charles Geoffrey | Sekretär | 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham D90 | British | 150401690001 | ||||||
| FOSTER, David Charles Geoffrey | Geschäftsführer | 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham D90 | England | British | 52040210004 | |||||
| MULLER, Mark Francis, Mr. | Geschäftsführer | 1 Thane Road West NG2 3AA Nottingham D90 | United Kingdom | British | 63620010002 | |||||
| HENDERSON, Cyraine Elizabeth | Sekretär | 10 Brighton Grove NE26 1QH Whitley Bay Tyne & Wear | British | 16015100002 | ||||||
| HENDERSON, Susan | Sekretär | 53 The Broadway Tynemouth NE30 2LL North Shields Tyne & Wear | British | 43148360003 | ||||||
| MULLER, Mark Francis, Mr. | Sekretär | Elm Lodge 15 Oaken Coppice KT21 1DL Ashtead Surrey | British | 63620010002 | ||||||
| AYLWARD, Christopher David | Geschäftsführer | Buchan Cottage 2 Cheapside GU21 4JG Horsell Woking | United Kingdom | British | 59741430002 | |||||
| GILES, Christopher James | Geschäftsführer | 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham D90 | England | British | 149729660001 | |||||
| HENDERSON, Cyraine Elizabeth | Geschäftsführer | 10 Brighton Grove NE26 1QH Whitley Bay Tyne & Wear | British | 16015100002 | ||||||
| HENDERSON, Philip | Geschäftsführer | 53 The Broadway Tynemouth NE30 2LL North Shields Tyne & Wear | United Kingdom | British | 16015110003 | |||||
| KENNERLEY, Patricia Diane | Geschäftsführer | D90 1 Thane Road West NG90 1BS Nottingham | Great Britain | British | 110727230002 | |||||
| MULLER, Mark Francis, Mr. | Geschäftsführer | Elm Lodge 15 Oaken Coppice KT21 1DL Ashtead Surrey | United Kingdom | British | 63620010002 |
Hat HENDERSON PHARMACY LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Assignation of goodwill | Erstellt am 09. März 1999 Geliefert am 23. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Assigns all the beneficial interest and goodwill of the company in the business(es) carried out or to be carried on by the company at (a) the central pharmacy, 1 cattle market, hexham, northumberland NE46 1NJ (b) abbey chemists 4 hencotes hexham northumberland NE46 2EJ (c) pattinson pharmacy 77 front street prudhoe northumberland NE42 5PU. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 09. März 1999 Geliefert am 13. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 37/39 queen street amble northumberland t/no.ND99742. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 22. Aug. 1997 Geliefert am 03. Sept. 1997 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a 2 dean terrace ryton tyne and wear NE40 3HQ t/no;-TY281871. Fixed charge all buildings and other structures fixed to the property fixed charge any goodwill relating to the property fixed charge all plant machinery and other items affixed to the property assignment of the rental sums together with the benefit of all rights and remedies fixed charge the proceeds of any claim made under insurance policy relating to the property floating charge all unattached plant machinery chattels and goods on or in or used in connection with the property or the business or undertaking at the property. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 11/09/1991 | Erstellt am 02. Sept. 1991 Geliefert am 13. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities covenanted to be paid or discharged by the company including costs and interest to the chargee | |
Kurze Angaben F/H k/a 48/48A front street prudhoe northumberland. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 11/09/1991 | Erstellt am 02. Sept. 1991 Geliefert am 13. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities covenanted to be paid or discharged by the company including costs and interest to the chargee | |
Kurze Angaben F/H property k/a bridge house 5 & 6 station road bedlington t/n nd 30312. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge as evidenced by a statutory declaration dated 11/09/91 | Erstellt am 02. Sept. 1991 Geliefert am 13. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities covenanted to be paid or discharged by the company including costs and interest to the chargee | |
Kurze Angaben F/H property k/a 286 & 288 chillingham road, heaton, newcastle upon tyne. T/n TY163202. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture as evidenced by a statutory declaration dated 11/09/91 | Erstellt am 02. Sept. 1991 Geliefert am 13. Sept. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies and liabilities covenanted to be paid or discharged by the company including costs and interest to the chargee | |
Kurze Angaben F/H & l/h property present & future fixed charge goodwill, uncalled capital,stocks floating charge and. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 31. Jan. 1991 Geliefert am 14. Feb. 1991 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H all that ground floor shop at premises k/a 6 in the precinct hadston in the county of northumberland & the proceed of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of legal mortgage | Erstellt am 29. Sept. 1989 Geliefert am 18. Okt. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben 286/288 chillingham road heaton, newcastle upon tyne and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 31. März 1989 Geliefert am 16. Apr. 1981 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/Hold, bridge house, bedlington, northumberland. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 12. Mai 1986 Geliefert am 21. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property k/a 7/7A the broadway darras hall porteland newcastle upon tyne and tyne and the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 12. Mai 1986 Geliefert am 21. Mai 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge on the companys f/h & l/h property and the proceeds of sle thereof fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 18. Dez. 1985 Geliefert am 02. Jan. 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H 286/288 chillingham road, newcastle upon tyne and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 22. Okt. 1982 Geliefert am 22. Okt. 1982 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben L/H property known as 93 95 and 97 park view whitley bay, tyne and wear and/or proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0