SCOTIA PHARMACEUTICALS LIMITED

SCOTIA PHARMACEUTICALS LIMITED

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameSCOTIA PHARMACEUTICALS LIMITED
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformGesellschaft mit beschränkter Haftung
    Unternehmensnummer 01397585
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von SCOTIA PHARMACEUTICALS LIMITED?

    • (1541) /

    Wo befindet sich SCOTIA PHARMACEUTICALS LIMITED?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von SCOTIA PHARMACEUTICALS LIMITED?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    EFAMOL LIMITED31. Dez. 197931. Dez. 1979
    VERRONMAY LIMITED02. Nov. 197802. Nov. 1978

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von SCOTIA PHARMACEUTICALS LIMITED?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis

    Welche sind die letzten Einreichungen für SCOTIA PHARMACEUTICALS LIMITED?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ2

    Das Verfahren zur Zwangslöschung wurde ausgesetzt

    1 SeitenDISS16(SOAS)

    Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die Zwangslöschung

    1 SeitenGAZ1

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 24. Mai 2018

    2 Seiten2.15

    Mitteilung über die Aufhebung des Verwaltungsbeschlusses

    29 Seiten2.19

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 24. Mai 2018

    2 Seiten1.3

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 24. Mai 2018

    2 Seiten2.15

    Mitteilung über den Abschluss des freiwilligen Vergleichs

    29 SeitenCVA4

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2018

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 02. Nov. 2017

    2 Seiten1.3

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Juli 2017

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2017

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Juli 2016

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2016

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Juli 2015

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2015

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Juli 2014

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2014

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 02. Nov. 2013

    2 Seiten1.3

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Juli 2013

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2013

    2 Seiten2.15

    Geänderte Geschäftsanschrift vom * Mitre House 160 Aldersgate Street London EC1A 4DD* am 15. Feb. 2013

    2 SeitenAD01

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Supervisors des freiwilligen Vergleichs bis 02. Nov. 2012

    2 Seiten1.3

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Juli 2012

    2 Seiten2.15

    Einnahmen- und Ausgabenabrechnung des Administrators bis 28. Jan. 2012

    2 Seiten2.15

    Wer sind die Geschäftsführer von SCOTIA PHARMACEUTICALS LIMITED?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SCOTIA HOLDINGS PLC
    40 Tower Hill
    EC3N 4BB London
    Sekretär
    40 Tower Hill
    EC3N 4BB London
    78641200001
    SCOTIA HOLDINGS PLC
    40 Tower Hill
    EC3N 4BB London
    Geschäftsführer
    40 Tower Hill
    EC3N 4BB London
    78641200001
    LAFFERTY, Gerard
    Tempar 4 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Sekretär
    Tempar 4 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    British44542890004
    MARR, Catriona Frances
    167 Malden Road
    KT3 6AA New Malden
    Surrey
    Sekretär
    167 Malden Road
    KT3 6AA New Malden
    Surrey
    British6408230002
    ABADZIS, Pierre
    42 Ailsa Road
    TW1 1QW Twickenham
    Middlesex
    Geschäftsführer
    42 Ailsa Road
    TW1 1QW Twickenham
    Middlesex
    British22631860001
    BLACKWELL, Christopher Paul, Dr
    1 Gibson Grove
    FK15 0NS Dunblane
    Perthshire
    Geschäftsführer
    1 Gibson Grove
    FK15 0NS Dunblane
    Perthshire
    British79770360001
    CLARKSON, Sherri Margaret
    Fernfield
    1 Melville Place
    FK9 4HE Bridge Of Allan
    Geschäftsführer
    Fernfield
    1 Melville Place
    FK9 4HE Bridge Of Allan
    Canadian22631870003
    GRAY, Richard John
    22 Vandyke Close
    RH1 2DS Redhill
    Surrey
    Geschäftsführer
    22 Vandyke Close
    RH1 2DS Redhill
    Surrey
    British22631850003
    HORROBIN, David Frederick, Dr
    50 Kenilworth Road
    FK9 4RS Bridge Of Allan
    Geschäftsführer
    50 Kenilworth Road
    FK9 4RS Bridge Of Allan
    British80992730001
    LAFFERTY, Gerard
    Tempar 4 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    Geschäftsführer
    Tempar 4 Dupplin Terrace
    PH2 7DG Perth
    ScotlandBritish44542890004
    LAPINSKAS, Peter George Whitworth, Dr
    Woodside 26 Deepdene Wood
    RH5 4BQ Dorking
    Surrey
    Geschäftsführer
    Woodside 26 Deepdene Wood
    RH5 4BQ Dorking
    Surrey
    EnglandBritish22631820002
    LAWTHER, William Michael
    Corrienessen House
    Aberfoyle
    FK8 3TQ Stirling
    Scotland
    Geschäftsführer
    Corrienessen House
    Aberfoyle
    FK8 3TQ Stirling
    Scotland
    British78490730002
    MANKU, Mehar Singh
    Sukh Dham
    Heads Nook
    CA4 9AA Carlisle
    Cumbria
    Geschäftsführer
    Sukh Dham
    Heads Nook
    CA4 9AA Carlisle
    Cumbria
    Canadian1395370002
    MORROW, Ian, Sir
    Broadacres
    7 Devils Lane
    CB11 4BB Saffron Walden
    Essex
    Geschäftsführer
    Broadacres
    7 Devils Lane
    CB11 4BB Saffron Walden
    Essex
    British1890700002
    REYNOLDS, Brenda Elizabeth
    Two Beeches
    Pit Farm Road
    GU1 2JH Guildford
    Surrey
    Geschäftsführer
    Two Beeches
    Pit Farm Road
    GU1 2JH Guildford
    Surrey
    British96885590001
    SELKIRK, Alastair Brereton, Doctor
    303 Lanark Road
    EH14 2LL Edinburgh
    Geschäftsführer
    303 Lanark Road
    EH14 2LL Edinburgh
    British59306120002
    STEWART, John Charles Marshall
    Rose Villa
    Hermongers Lane
    RH12 3AH Rudgwick
    West Sussex
    Geschäftsführer
    Rose Villa
    Hermongers Lane
    RH12 3AH Rudgwick
    West Sussex
    British145867290001

    Hat SCOTIA PHARMACEUTICALS LIMITED Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 15. Okt. 1992
    Geliefert am 02. Nov. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the facility documents and the charge
    Kurze Angaben
    (See form 395 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Kleinwort Benson Limitedfor Itself and as Trustee for the Beneficiaries
    Transaktionen
    • 02. Nov. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 11. Mai 1994Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Charge of patents
    Erstellt am 26. März 1992
    Geliefert am 14. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    All the patents described fully in schedule together with all other patents presently belonging to or hereinafter acquired by the company(see form 395 for full details).
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 14. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 18. März 1992
    Geliefert am 02. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    See form 395 ref M514C for full details. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 02. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 20. Juni 1998Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 18. März 1992
    Geliefert am 30. März 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land and buildings on the north side of skellingthorpe road, boultham, lincolnshire title no. LL33339.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 30. März 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 29. Juni 1999Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee and debenture
    Erstellt am 12. Apr. 1991
    Geliefert am 22. Apr. 1991
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from being efamol holdings public limited company to under the terms of a loan agreement dated 12TH april 1991 and this charge. The company to the chargee.
    Kurze Angaben
    (See form 395 ref M89 for full details). Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hambras Bank Limited(As Agent and Trustee for the Bankers).
    Transaktionen
    • 22. Apr. 1991Registrierung einer Belastung
    • 04. Feb. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Composite guarantee & debenture
    Erstellt am 10. Jan. 1989
    Geliefert am 26. Jan. 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    (Please refer to form M395 re M608C for full details).. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 26. Jan. 1989Registrierung einer Belastung
    • 16. Okt. 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Single debenture
    Erstellt am 26. Juni 1986
    Geliefert am 03. Juli 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Including trade fixtures.. Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank Limited
    Transaktionen
    • 03. Juli 1986Registrierung einer Belastung
    • 02. Aug. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage debenture
    Erstellt am 11. Feb. 1985
    Geliefert am 15. Feb. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    A specific equitable charge on the companys f/h & l/h property and or the proceeds of sale fixed and floating charge over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Feb. 1985Registrierung einer Belastung
    • 19. Juni 1992Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1980
    Geliefert am 19. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill debts uncalled capital. Together with all buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Brown Shipley & Co LTD
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1980Registrierung einer Belastung
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1980
    Geliefert am 19. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therin to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill debts uncalled capital. Together with all buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Henry Ansbacher & Co LTD
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1980Registrierung einer Belastung
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1980
    Geliefert am 19. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill debts uncalled capital. Together with all buildings, fixtures, fixed plant, machinery.
    Berechtigte Personen
    • National Westminster Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1980Registrierung einer Belastung
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1980
    Geliefert am 19. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill debts uncalled capital. Together with all buildings, fixtures, fixed plant, machinery.
    Berechtigte Personen
    • Hambros Bank LTD
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1980Registrierung einer Belastung
    Guarangee & debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1980
    Geliefert am 19. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill debts uncalled capital. Together with all buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Barclays Bank PLC
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1980Registrierung einer Belastung
    Guarantee & debenture
    Erstellt am 12. Dez. 1980
    Geliefert am 19. Dez. 1980
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever.
    Kurze Angaben
    Fixed & floating charge over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill debts uncalled capital. Together with all buildings, fixtures, fixed plant & machinery.
    Berechtigte Personen
    • Clydesdale Bank LTD
    Transaktionen
    • 19. Dez. 1980Registrierung einer Belastung

    Hat SCOTIA PHARMACEUTICALS LIMITED Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    29. Jan. 2001Beginn der Verwaltung
    24. Mai 2018Verwaltung entlassen
    Verwaltungsordnung
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Thomas Merchant Burton
    Ernst & Young Llp
    George House
    G2 1RR 50 George Square
    Glasgow
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    George House
    G2 1RR 50 George Square
    Glasgow
    Shagun Sunil Dubey
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    1 More London Place
    SE1 2AF London
    Colin Peter Dempster
    Ernst & Young
    10 George Street
    Edinburgh
    Eh2 2dz
    Praktiker
    Ernst & Young
    10 George Street
    Edinburgh
    Eh2 2dz
    Christopher John Wilkinson Hill
    Ernst & Young
    George House
    G2 1RR 50 George Square
    Glasgow
    Praktiker
    Ernst & Young
    George House
    G2 1RR 50 George Square
    Glasgow
    Andrew James Rodney Wollaston
    Ernst & Young
    George House
    G2 1RR 50 George Square
    Glasgow
    Praktiker
    Ernst & Young
    George House
    G2 1RR 50 George Square
    Glasgow
    2
    DatumTyp
    03. Nov. 2003Datum der Sitzung zur Genehmigung des CVA
    24. Mai 2018Datum des Abschlusses oder der Beendigung des CVA
    Freiwillige Unternehmenssanierung (CVA)
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Shagun Sunil Dubey
    Ernst & Young Llp
    Becket House
    SE1 7EU 1 Lambeth Palace Road
    London
    Praktiker
    Ernst & Young Llp
    Becket House
    SE1 7EU 1 Lambeth Palace Road
    London
    Thomas Merchant Burton
    Becket House
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London
    Praktiker
    Becket House
    1 Lambeth Palace Road
    SE1 7EU London

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0