MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01403501 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Ja |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?
- Ruhende Gesellschaft (99999) / Tätigkeiten extraterritorialer Organisationen und Körperschaften
Wo befindet sich MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Level 12 The Shard, 32 London Bridge Street SE1 9SG London England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauteten die früheren Namen von MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?
| Unternehmensname | Von | Bis |
|---|---|---|
| TWO FLAGS EXCELLENCE LIMITED | 15. Juni 1999 | 15. Juni 1999 |
| TWO FLAGS AVIATION SERVICES LIMITED | 05. Sept. 1996 | 05. Sept. 1996 |
| AMR TWO FLAGS AVIATION SERVICES LIMITED | 19. Apr. 1994 | 19. Apr. 1994 |
| TWO FLAGS LIMITED | 04. Dez. 1978 | 04. Dez. 1978 |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. März 2022 |
Welche sind die letzten Einreichungen für MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation | 1 Seiten | GAZ2 | ||||||||||
Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation | 7 Seiten | LIQ13 | ||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 17 Seiten | 600 | ||||||||||
Abberufung des Liquidators durch Gerichtsbeschluss | 16 Seiten | LIQ10 | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Stephanie Alison Pound am 23. Mai 2023 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 1 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Ernennung eines freiwilligen Liquidators | 3 Seiten | 600 | ||||||||||
Erklärung der Zahlungsfähigkeit | 7 Seiten | LIQ01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. März 2022 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 30. Sept. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2022 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. März 2021 | 16 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mr Jeremy Mark Williams am 19. Juli 2021 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Vorheriger Abrechnungszeitraum verlängert von 30. Dez. 2020 bis 31. März 2021 | 1 Seiten | AA01 | ||||||||||
Ernennung von Mr Jeremy Mark Williams als Direktor am 07. Apr. 2021 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Bestätigungserklärung erstellt am 01. Feb. 2021 ohne Aktualisierungen | 3 Seiten | CS01 | ||||||||||
Change of details for Maclellan International Limited as a person with significant control on 01. Dez. 2020 | 2 Seiten | PSC05 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Capital Tower 91 Waterloo Road London SE1 8RT zum Level 12 the Shard, 32 London Bridge Street London SE1 9SG am 02. Dez. 2020 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Richard John Butler als Geschäftsführer am 30. Nov. 2020 | 1 Seiten | TM01 | ||||||||||
Ernennung von Miss Katherine Woods als Direktor am 30. Nov. 2020 | 2 Seiten | AP01 | ||||||||||
Ernennung von Mitie Company Secretarial Services Limited als Sekretär am 30. Nov. 2020 | 2 Seiten | AP04 | ||||||||||
Beendigung der Bestellung von Stephanie Alison Pound als Sekretär am 30. Nov. 2020 | 1 Seiten | TM02 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2019 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Änderung der Details des Direktors für Mrs Stephanie Alison Pound am 15. März 2020 | 2 Seiten | CH01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2018 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer | ||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MITIE COMPANY SECRETARIAL SERVICES LIMITED | Sekretär | The Shard 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England England |
| 148474450001 | ||||||||||
| POUND, Stephanie Alison | Geschäftsführer | The Shard, 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England | England | British | 213930870003 | |||||||||
| WILLIAMS, Jeremy Mark | Geschäftsführer | The Shard, 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England | England | British | 280831530001 | |||||||||
| WOODS, Katherine | Geschäftsführer | The Shard, 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12 England | United Kingdom | British | 237400250001 | |||||||||
| BLACKBURN, Peter Edward | Sekretär | 1 The Old Orchard CV35 9RW Wellesbourne Warwickshire | British | 75964810001 | ||||||||||
| COOPER, Philip William | Sekretär | 34 Alban Road SG6 2AT Letchworth Hertfordshire | British | 9839440001 | ||||||||||
| FERNLEY, Renee Amy Margaret | Sekretär | 7 Northcroft Road Englefield Green TW20 0DP Egham Surrey | British | 6221020001 | ||||||||||
| GREEN, Kevin Hartley | Sekretär | 15 Manor Farm Close Barton Le Clay MK45 4TB Bedford Bedfordshire | British | 72862750001 | ||||||||||
| MARLETT, Charles David | Sekretär | 5756 Stonegate Road 75209 Dallas Texas Usa | American | 34256160002 | ||||||||||
| POUND, Stephanie Alison | Sekretär | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London | British | 77355850005 | ||||||||||
| PRICE, Mairead Brigid | Sekretär | 17 Beech Road Hollywood B47 5QS Birmingham West Midlands | British | 117736250001 | ||||||||||
| SHIPLEY, Stephen Robert | Sekretär | 69 Wychwood Avenue Knowle B93 9DL Solihull West Midlands | British | 16575040001 | ||||||||||
| ASHDOWN, Simon Trayton | Geschäftsführer | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London | England | British | 117331880001 | |||||||||
| BAKER, Robert Woodward | Geschäftsführer | 17 Lundys Lane 75080 Dallas Texas Usa | Usa | 34900830001 | ||||||||||
| BROOKS, David Robert | Geschäftsführer | 3412 Centenary Avenue Dallas Tx75225 Usa | American | 48194490001 | ||||||||||
| BUTLER, Richard John | Geschäftsführer | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London | England | British | 213849970003 | |||||||||
| CARTY, Donald John | Geschäftsführer | 3907 Gillon Avenue Dallas Texas 75205 Usa | Canadian,American | 34256150001 | ||||||||||
| CLITHEROE, David Maurice | Geschäftsführer | 3 Norman Court Oadby LE2 4UD Leicester | British | 49800090001 | ||||||||||
| COOPER, Philip William | Geschäftsführer | 34 Alban Road SG6 2AT Letchworth Hertfordshire | United Kingdom | British | 9839440001 | |||||||||
| CRANDALL, Robert Lloyd | Geschäftsführer | 5423 Park Lane Dallas Texas 75220 Usa | American | 46751890001 | ||||||||||
| ELLIS, John Leslie | Geschäftsführer | 21 Oakfields Avenue SG3 6NP Knebworth Hertfordshire | England | British | 25380370003 | |||||||||
| FERNLEY, Michael John | Geschäftsführer | 7 Northcroft Road Englefield Green TW20 0DP Egham Surrey | British | 6221030001 | ||||||||||
| FERNLEY, Renee Amy Margaret | Geschäftsführer | 7 Northcroft Road Englefield Green TW20 0DP Egham Surrey | British | 6221020001 | ||||||||||
| GRAVENEY, Mark | Geschäftsführer | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London | British | 126722400001 | ||||||||||
| GUNN, George James | Geschäftsführer | 360 E Randolph £3801 Chicago Il 60601 Usa | American | 48194530001 | ||||||||||
| MELIZAN, Bruce Anthony | Geschäftsführer | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London | United Kingdom | British,Trinidadian | 92905500001 | |||||||||
| METZLER, Thomas Michael | Geschäftsführer | 3918 Fox Glen Drive Irving Texas 75062 FOREIGN Usa | American | 39634340002 | ||||||||||
| PLEDGE, Nicholas Christopher | Geschäftsführer | 31 Bolton Crescent SL4 3JH Windsor Berkshire | England | British | 120621490001 | |||||||||
| POULTER, Michael John | Geschäftsführer | Redwood Lodge Pump Lane North SL7 3RD Marlow Buckinghamshire | British | 23113980001 | ||||||||||
| REHILL, Daljit Singh | Geschäftsführer | 102 Berkeley Avenue TW4 6LB Hounslow Middlesex | British | 46370490001 | ||||||||||
| SIBLEY, Anthony William | Geschäftsführer | Boa Vista Higham Road Higham Gobian SG5 3HR Hitchin Hertfordshire | United Kingdom | British | 13317120001 | |||||||||
| SIBLEY, Roseleen | Geschäftsführer | Boa Vista Higham Road Higham Gobian SG5 3HR Hitchin Hertfordshire | Irish | 7179710001 | ||||||||||
| SPENCER, Bernard William | Geschäftsführer | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London | England | British | 98205010002 | |||||||||
| WATSON, Michael Stuart | Geschäftsführer | Capital Tower 91 Waterloo Road SE1 8RT London | England | British | 188269720001 |
Wer sind die Personen mit maßgeblichem Einfluss bei MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED?
| Name | Benachrichtigt am | Adresse | Aufgehört | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Maclellan International Limited | 06. Apr. 2016 | 32 London Bridge Street SE1 9SG London Level 12. The Shard England | Nein | ||||||||||
| |||||||||||||
Arten der Kontrolle
| |||||||||||||
Hat MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Guarantee & debenture | Erstellt am 14. Okt. 2004 Geliefert am 27. Okt. 2004 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the chargors to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee & debenture | Erstellt am 25. Okt. 2000 Geliefert am 06. Nov. 2000 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or all or any of the other companies named therein to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 20. Apr. 1999 Geliefert am 26. Apr. 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 22. März 1999 Geliefert am 25. März 1999 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Guarantee and debenture | Erstellt am 11. Nov. 1996 Geliefert am 27. Nov. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company and/or excellence PLC to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben .. fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Fixed and floating charge | Erstellt am 22. Okt. 1996 Geliefert am 28. Okt. 1996 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben By way of fixed equitable charge all debts the subject of an invoice discounting agreement and all rights in favour of the company related to such debts and all other amounts and by way of a floating charge such of the moneys which the company may receive in respect of the above amounts as shall for the time being stand released form the fixed charge. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Hat MACLELLAN INTERNATIONAL AIRPORT SERVICES LIMITED Insolvenzverfahren?
| Aktenzeichen | Daten | Typ | Rechtsanwälte | Andere | ||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 |
| Gesellschafter-freiwillige Liquidation |
|
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0