LEISURE TENNIS LIMITED
Überblick
| Unternehmensname | LEISURE TENNIS LIMITED |
|---|---|
| Unternehmensstatus | Aufgelöst |
| Rechtsform | Gesellschaft mit beschränkter Haftung |
| Unternehmensnummer | 01409437 |
| Gerichtsbarkeit | England/Wales |
| Gründungsdatum | |
| Datum der Einstellung |
Zusammenfassung
| Hat Super Secure PSCs | Nein |
|---|---|
| Hat Belastungen | Ja |
| Hat Insolvenzgeschichte | Nein |
| Registrierte Geschäftsadresse ist umstritten | Nein |
Was ist der Zweck von LEISURE TENNIS LIMITED?
- (7499) /
Wo befindet sich LEISURE TENNIS LIMITED?
| Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | 40-44 Coombe Road KT3 4QF New Malden Surrey England |
|---|---|
| Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen Geschäftstelle | Nein |
Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von LEISURE TENNIS LIMITED?
| Letzter Jahresabschluss | |
|---|---|
| Letzter Jahresabschluss erstellt bis | 31. Dez. 2009 |
Welche sind die letzten Einreichungen für LEISURE TENNIS LIMITED?
| Datum | Beschreibung | Dokument | Typ | |||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Letzter Bundesanzeiger aufgelöst durch freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ2(A) | ||||||||||
Erste Bekanntmachung im Bundesanzeiger für die freiwillige Löschung | 1 Seiten | GAZ1(A) | ||||||||||
Antrag auf Löschung der Gesellschaft aus dem Handelsregister | 3 Seiten | DS01 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | SH20 | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | CAP-SS | ||||||||||
Kapitalaufstellung am 17. Dez. 2010
| 5 Seiten | SH19 | ||||||||||
Beschlüsse Resolutions | 2 Seiten | RESOLUTIONS | ||||||||||
| ||||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2009 | 5 Seiten | AA | ||||||||||
Jahresrückblick erstellt bis 20. Juni 2010 mit vollständiger Liste der Aktionäre | 5 Seiten | AR01 | ||||||||||
Geänderte Geschäftsanschrift vom Cannons House 40-44 Coombe Road New Malden Surrey KT3 4QF am 22. Juni 2010 | 1 Seiten | AD01 | ||||||||||
Jahresabschluss für eine ruhende Gesellschaft erstellt bis zum 31. Dez. 2008 | 7 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 12 Seiten | 288a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2007 | 8 Seiten | AA | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 363a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 3 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 288b | ||||||||||
legacy | 2 Seiten | 288a | ||||||||||
legacy | 1 Seiten | 403a | ||||||||||
Jahresabschluss erstellt bis zum 31. Dez. 2006 | 9 Seiten | AA | ||||||||||
Wer sind die Geschäftsführer von LEISURE TENNIS LIMITED?
| Name | Ernennung am | Rücktrittsdatum | Rolle | Adresse | Unternehmensidentifikation | Staatsangehörigkeit | Nationalität | Geburtsdatum | Beruf | Nummer |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| HOLBEN, David George | Sekretär | 49 Sandilands Road Fulham SW6 2BD London | British | 104903050001 | ||||||
| DOYLE, Kevan-Peter | Geschäftsführer | 34 Park Road TW1 2PX Twickenham Middlesex | United Kingdom | British | 78237230007 | |||||
| HYATT, Gregory John | Geschäftsführer | The Firs 27 Crookham Road GU51 5DP Fleet Hampshire | United Kingdom | British | 61663230001 | |||||
| GILES, Alan Patrick | Sekretär | Blake Lodge Bridge Lane SW11 3AD London | American | 30339590002 | ||||||
| OLIVER, Martin Timothy | Sekretär | Flat 2 Chivelston 78 Parkside Wimbledon SW19 5LH London | British | 50764370001 | ||||||
| PALMER, Steven Mark | Sekretär | Nettlecombe Pyle Hill GU22 0SR Woking Surrey | British | 63240980001 | ||||||
| STREETS, Matthew Alexander | Sekretär | 6 Doneraile Street Fulham SW6 6EN London | British | 40530270001 | ||||||
| WISEMAN, David Charles | Sekretär | 53 Dorset Drive HA8 7NT Edgware Middlesex | British | 50807620002 | ||||||
| ANDREW, James Richard Elliott | Geschäftsführer | Henderson Road SW18 3RR London 15 | United Kingdom | British | 139764120001 | |||||
| BECKWITH, Peter Michael | Geschäftsführer | 29 Marryat Road SW19 London | British | 44336530001 | ||||||
| BOTTS, Theodore Paul | Geschäftsführer | 15 Kensington Gate W8 5NA London | Usa | 30900120001 | ||||||
| FISH, Mark Andrew | Geschäftsführer | The Orchard Court Road SL6 8LQ Maidenhead Berkshire | United Kingdom | British | 44086510002 | |||||
| GAY, Philip | Geschäftsführer | 115 Altenburg Gardens SW11 1JQ London | British | 44336430001 | ||||||
| GILES, Alan Patrick | Geschäftsführer | 12 Colestown Street SW11 3EH London | American | 30339590001 | ||||||
| HARRIS, Martin | Geschäftsführer | Levels House BA5 1PF Bleadney Somerset | British | 75882330001 | ||||||
| HAWKINS, Jonathan Francis Whishaw | Geschäftsführer | 24 Formosa Street W9 2QA London | British | 22150090001 | ||||||
| HOLMES, Andrew James | Geschäftsführer | Ivy House Culworth OX17 2AZ Banbury Oxfordshire | British | 3046170001 | ||||||
| JESSOP, Christopher | Geschäftsführer | Shawfield Street SW3 4BD London 8 | United Kingdom | British | 139864830001 | |||||
| MEJIA, Carlos Jaime | Geschäftsführer | 26 Mallord Street SW3 6DU London | Colombian | 30900140001 | ||||||
| MISRA, Arnu Kumar | Geschäftsführer | Hedgerow House 9 Rockwood Road Calverley LS28 5AB Leeds Yorkshire | United Kingdom | British | 227695390001 | |||||
| OLIVER, Martin Timothy | Geschäftsführer | 25 Cranes Drive KT5 8AJ Surbiton Surrey | British | 50764370002 | ||||||
| PALMER, Steven Mark | Geschäftsführer | Nettlecombe Pyle Hill GU22 0SR Woking Surrey | England | British | 63240980001 | |||||
| SOLER, Francisco Angel | Geschäftsführer | Paseo Escalon 5150 FOREIGN San Salvador Elsalvador | El Salvador | Salvadorean | 30900130001 | |||||
| STREETS, Matthew Alexander | Geschäftsführer | 6 Doneraile Street Fulham SW6 6EN London | United Kingdom | British | 40530270001 | |||||
| TEGELAARS, Harm Bartholomew | Geschäftsführer | Farnham House Farnham Lane TN3 0JT Langton Green Kent | Uk | Dutch | 16805470001 | |||||
| WILLIAMS, Christopher | Geschäftsführer | 6 Milner Road KT1 2AU Kingston Upon Thames Surrey | British | 102280630002 | ||||||
| WISEMAN, David Charles | Geschäftsführer | 53 Dorset Drive HA8 7NT Edgware Middlesex | England | British | 50807620002 |
Hat LEISURE TENNIS LIMITED Belastungen?
| Klassifizierung | Daten | Status | Details | |
|---|---|---|---|---|
| Security accession deed to a debenture dated 10 may 2001 between inter alia,health club investments limited (the "parent"),health club investments limited and health club acquisitions limited (the "charging companies") and the royal bank of scotland PLC (the "security agent") (the "debenture") | Erstellt am 03. Juli 2001 Geliefert am 13. Juli 2001 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All money or liabilities due or to become due from any charging company (as defined) to any secured party (as defined) or any other obligor (as defined) in any manner under or in respect of the finance documents (as defined) | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Debenture | Erstellt am 14. Juni 1995 Geliefert am 19. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 14. Juni 1995 Geliefert am 15. Juni 1995 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben F/H property k/a land on the south east side of townmead road, fulham, london t/no. NGL590444. Fixed charge over all buildings and other structures and items fixed to the property and any goodwill relating to the property. Fixed charge over all plant machinery and other chattels attached to the property. Floating charge over all unattached plant machinery chattels and goods used in connection with the property. Assignment of the rental sums and the benefit of all rights and remedies of the company. Fixed charge the proceeds of any claim made under any insurance policy relating to the property.. See the mortgage charge document for full details. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment and charge | Erstellt am 12. März 1992 Geliefert am 30. März 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility letter dated 16THDECENBER 1991 | |
Kurze Angaben Its right title and interest in and to the assigned agreements (see form 395 forfull details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment | Erstellt am 29. Jan. 1992 Geliefert am 18. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the facility letter or any guarantee or security as defined | |
Kurze Angaben All right title and interest in and to the bovis agreement and the accounts (see doc ref M122 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 29. Jan. 1992 Geliefert am 18. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to the terms of a facility letter dated 16TH december 1991 | |
Kurze Angaben (See form 395 for full details). A specific equitable charge over all freehold and leasehold properties and/or the proceeds of sale thereof fixed and floating charges over undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts and the benefits of any licences. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Deed of assignment and charge | Erstellt am 29. Jan. 1992 Geliefert am 18. Feb. 1992 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever pursuant to a facility letter dated 16THDECEMBER 1991 | |
Kurze Angaben Right title and interest in and to the construction contract dated 25TH november 1991 between the company and conder uklimited (see form 395 for full details). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal mortgage | Erstellt am 31. Jan. 1989 Geliefert am 07. Feb. 1989 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Property k/a the land on the south east side of townmead road fulham london SW6 title no: ngl 590444. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 01. Aug. 1988 Geliefert am 03. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben London the s/e side of townmead road fulham, l/b of hammersmith & fulham t/n ngl 590444 (for full details see form 395). floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Mortgage debenture | Erstellt am 01. Aug. 1988 Geliefert am 03. Aug. 1988 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever | |
Kurze Angaben Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital (for full details see form 395). | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Legal charge | Erstellt am 03. Apr. 1987 Geliefert am 07. Apr. 1987 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag £2,820,000 due from the company to the chargee. | |
Kurze Angaben Land at townmead, fulham forming part of t/no. 425439 & ngl 457486. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
| Charge of cash deposits | Erstellt am 09. Juni 1986 Geliefert am 11. Juni 1986 | Vollständig erfüllt | Gesicherter Betrag All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever not exceeding £130,000 | |
Kurze Angaben A cash deposit in the sum of £130,000. | ||||
Berechtigte Personen
| ||||
Transaktionen
| ||||
Datenquelle
- UK Companies House
Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet. - Lizenz: CC0