WYNCOTE GROUP PLC

  • Überblick
  • Zusammenfassung
  • Zweck
  • Adresse
  • Frühere Namen
  • Jahresabschlüsse
  • Einreichungen
  • Geschäftsführung
  • Belastungen
  • Insolvenz
  • Datenquelle
  • Überblick

    UnternehmensnameWYNCOTE GROUP PLC
    UnternehmensstatusAufgelöst
    RechtsformAktiengesellschaft
    Unternehmensnummer 01409911
    GerichtsbarkeitEngland/Wales
    Gründungsdatum
    Datum der Einstellung

    Zusammenfassung

    Hat Super Secure PSCsNein
    Hat BelastungenJa
    Hat InsolvenzgeschichteJa
    Registrierte Geschäftsadresse ist umstrittenNein

    Was ist der Zweck von WYNCOTE GROUP PLC?

    • (7011) /
    • (7415) /

    Wo befindet sich WYNCOTE GROUP PLC?

    Adresse der eingetragenen Geschäftstelle
    6th Floor 3 Hardman Street
    M3 3AT Manchester
    Nicht zustellbare Adresse der eingetragenen GeschäftstelleNein

    Wie lauteten die früheren Namen von WYNCOTE GROUP PLC?

    Frühere Unternehmensnamen
    UnternehmensnameVonBis
    WYNCOTE DEVELOPMENTS PLC31. Dez. 197931. Dez. 1979
    PAZBOURNE LIMITED17. Jan. 197917. Jan. 1979

    Wie lauten die letzten Jahresabschlüsse von WYNCOTE GROUP PLC?

    Letzter Jahresabschluss
    Letzter Jahresabschluss erstellt bis31. März 2003

    Welche sind die letzten Einreichungen für WYNCOTE GROUP PLC?

    Einreichungen
    DatumBeschreibungDokumentTyp

    Letzte Veröffentlichung im Amtsblatt aufgelöst nach Liquidation

    1 SeitenGAZ2

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 19. Dez. 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Dez. 2012

    5 Seiten4.68

    Rückgabe der Schlussversammlung in einer freiwilligen Gesellschafterliquidation

    3 Seiten4.71

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Juni 2012

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Dez. 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Juni 2011

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Dez. 2010

    5 Seiten4.68

    Beendigung der Bestellung von Graeme Jackson als Geschäftsführer

    1 SeitenTM01

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Juni 2010

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Dez. 2009

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Juni 2009

    5 Seiten4.68

    legacy

    1 Seiten287

    Insolvenzgerichtsbeschluss

    Court order insolvency:replacement of liquidator
    8 SeitenLIQ MISC OC

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Dez. 2008

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren bis 14. Dez. 2008

    5 Seiten4.68

    Verschiedenes

    S/S cert. Release of liquidator
    1 SeitenMISC

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Verschiedenes

    C/O replacement of liquidator
    3 SeitenMISC

    Hinweis auf die Einstellung der Tätigkeit als freiwilliger Liquidator

    1 Seiten4.40

    Ernennung eines freiwilligen Liquidators

    1 Seiten600

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Einnahmen- und Ausgabenrechnung der Liquidatoren

    5 Seiten4.68

    Wer sind die Geschäftsführer von WYNCOTE GROUP PLC?

    Geschäftsführung
    NameErnennung amRücktrittsdatumRolleAdresseUnternehmensidentifikationStaatsangehörigkeitNationalitätGeburtsdatumBerufNummer
    SUTHERLAND, John Alexander
    55a Parson Street
    Hendon
    NW4 1QT London
    Sekretär
    55a Parson Street
    Hendon
    NW4 1QT London
    British13759780001
    ANKERS, Neil Murray
    The Beeches Main Road
    Huxley
    CH4 9AJ Chester
    Cheshire
    Geschäftsführer
    The Beeches Main Road
    Huxley
    CH4 9AJ Chester
    Cheshire
    British4216160001
    PETERS, David John
    Culverden Norlington Lane
    Ringmer
    BN8 5SH Lewes
    East Sussex
    Sekretär
    Culverden Norlington Lane
    Ringmer
    BN8 5SH Lewes
    East Sussex
    British11207420003
    BARON, Christopher Paul
    7 The Drive
    BN3 3JS Hove
    East Sussex
    Geschäftsführer
    7 The Drive
    BN3 3JS Hove
    East Sussex
    British61874280001
    DEVETTA, Martin
    Linden
    Regents Walk
    SL5 9JQ Ascot
    Berks
    Geschäftsführer
    Linden
    Regents Walk
    SL5 9JQ Ascot
    Berks
    British12850370001
    FARMER, John Alan
    La Hure La Rue De La Motte
    St Martin
    GY4 6ER Guernsey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    La Hure La Rue De La Motte
    St Martin
    GY4 6ER Guernsey
    Channel Islands
    British11207400002
    GILBERT, Christopher John
    1 Cedar Chase
    Cross Lane, Findon
    BN14 0US Worthing
    West Sussex
    Geschäftsführer
    1 Cedar Chase
    Cross Lane, Findon
    BN14 0US Worthing
    West Sussex
    EnglandBritish109988000001
    JACKSON, Graeme
    121 Mount Street
    W1Y 5HB London
    Geschäftsführer
    121 Mount Street
    W1Y 5HB London
    EnglandBritish65426870003
    JOHNSON, Andrew Lawrence, Mr.
    Twenty Pence Cottage Twenty
    Pence Road Wilburton
    CB6 3PX Ely
    Cambridgeshire
    Geschäftsführer
    Twenty Pence Cottage Twenty
    Pence Road Wilburton
    CB6 3PX Ely
    Cambridgeshire
    EnglandBritish17468640001
    O BRIEN, Conor John Anthony
    Gorsefield House
    Newtown Common
    RG20 9BE Newbury
    Berkshire
    Geschäftsführer
    Gorsefield House
    Newtown Common
    RG20 9BE Newbury
    Berkshire
    British72690550002
    PETERS, David John
    Culverden Norlington Lane
    Ringmer
    BN8 5SH Lewes
    East Sussex
    Geschäftsführer
    Culverden Norlington Lane
    Ringmer
    BN8 5SH Lewes
    East Sussex
    United KingdomBritish11207420003
    TILLARD, Richard Peregrine
    "Southam"
    South Chailey
    BN8 4QJ Lewes
    East Sussex
    Geschäftsführer
    "Southam"
    South Chailey
    BN8 4QJ Lewes
    East Sussex
    EnglandBritish65037090002
    UPTON, Richard
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    Geschäftsführer
    Le Grouet
    La Rue Du Grouet
    JE3 8HL St Brelade
    Jersey
    Channel Islands
    United KingdomBritish46440870005

    Hat WYNCOTE GROUP PLC Belastungen?

    Belastungen
    KlassifizierungDatenStatusDetails
    Debenture
    Erstellt am 24. Jan. 1997
    Geliefert am 28. Jan. 1997
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery. See the mortgage charge document for full details.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 28. Jan. 1997Registrierung einer Belastung (395)
    Legal charge
    Erstellt am 07. Jan. 1994
    Geliefert am 15. Jan. 1994
    Ausstehend
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    The kings head london road albourne hassocks west sussex.
    Berechtigte Personen
    • The Governor and Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 15. Jan. 1994Registrierung einer Belastung (395)
    Charge
    Erstellt am 10. Apr. 1992
    Geliefert am 15. Apr. 1992
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from thecompany to the chargee on any account whatsoever supplemental to the principal charge dated 27/11/84
    Kurze Angaben
    First fixed charge on all goodwill and uncalled capital all patents trade marks (see form 395).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 15. Apr. 1992Registrierung einer Belastung (395)
    • 18. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Legal charge
    Erstellt am 23. März 1989
    Geliefert am 25. März 1989
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    128 queens road brighton east sussex.
    Berechtigte Personen
    • Governor & Company of the Bank of Scotland
    Transaktionen
    • 25. März 1989Registrierung einer Belastung
    • 23. Apr. 1993Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 25. Feb. 1988
    Geliefert am 01. März 1988
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land k/a commerce way industrial estate lancing adir w sussex floating charge on all the undertaking and all property and assets present and future including goodwill.
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 01. März 1988Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 25. Juli 1986
    Geliefert am 26. Juli 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    L/H land & bldgs on the south side of crowhurst rd hollingbury brighton (title no esx 106675).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 26. Juli 1986Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 23. Jan. 1986
    Geliefert am 25. Jan. 1986
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee not exceeding £60,000 on account no 01551590
    Kurze Angaben
    Part of property k/a 21 goring road, worthing, west sussex title no: wsx 92154.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 25. Jan. 1986Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 13. Aug. 1985
    Geliefert am 22. Aug. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land off moulescoomb way brighton title no esx 106695 the right title & interest of the company in and to the proceeds of sale thereof.
    Berechtigte Personen
    • Yardbay Limited
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 13. Aug. 1985
    Geliefert am 22. Aug. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    L/H 12 crowhurst road brighton & the benefit of all construction contract performance bonds etc (see doc M43).
    Berechtigte Personen
    • Yardbay Limited
    Transaktionen
    • 22. Aug. 1985Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 15. März 1985
    Geliefert am 18. März 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    By way of legal mortgage the l/h property known as 12 crowhurst road, brighton.
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 18. März 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 28. Jan. 1985
    Geliefert am 07. Feb. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £360,000
    Kurze Angaben
    Cold store, holland road hove, title no sx 29952.
    Berechtigte Personen
    • Russgaile Limited
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 28. Jan. 1985
    Geliefert am 07. Feb. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £360,000
    Kurze Angaben
    Land at crowhurst road, hallingbury brighton east sussex.
    Berechtigte Personen
    • Russgaile Limited
    Transaktionen
    • 07. Feb. 1985Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 11. Jan. 1985
    Geliefert am 17. Jan. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee under the terms of the counter indemnity and all monies due or to become due from the company and/or yardbay limited to the chargee under the terms of the charge
    Kurze Angaben
    Land on the north westside of moulescoomb way brighton east sussex a bank account & all monies standing to the credit in the names of the company & yardbay LTD at midland bank PLC jersey in acc no 71320173 the benefit of an agreement for lease dated 21 dec 1984.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific International Leasing (Europe) Inc
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1985Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 31. Dez. 1984
    Geliefert am 17. Jan. 1985
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee pursuant to a guarantee dated 31-12-84
    Kurze Angaben
    The benefit of an agreement dated 17/9/84 made between simplex (power centre) limited the company as amended by a supplemental agreement dated 21/12/84 between the said parties & tcb limited & international general electric (usa) limited.
    Berechtigte Personen
    • Security Pacific International Leasing (Europe) Inc
    Transaktionen
    • 17. Jan. 1985Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 14. Dez. 1984
    Geliefert am 24. Dez. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property on east side of holland rd hove e sussex (title no sx 29952) floating charge over undertaking and all property and assets present and future (please see doc M36).
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 24. Dez. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 27. Nov. 1984
    Geliefert am 05. Dez. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Fixed and floating charges over the undertaking and all property and assets present and future including goodwill bookdebts uncalled capital buildings fixtures fixed plant and machinery.
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 05. Dez. 1984Registrierung einer Belastung
    • 10. Apr. 1997Erklärung zur vollständigen oder teilweisen Erfüllung einer Belastung (403a)
    Mortgage
    Erstellt am 17. Sept. 1984
    Geliefert am 25. Sept. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £240,000 and all other monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H land & factory buildings in or near moulesecoomb way brighton east sussex please see doc M30.
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 25. Sept. 1984Registrierung einer Belastung
    Mortgage
    Erstellt am 06. Aug. 1984
    Geliefert am 08. Aug. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    F/H property k/a unit 1 lady bee industrial estate southwick title no wsx 80885 f/h property k/a unit 2 lady bee industrial estate southwick title no wsx 80886 floating charge on undertaking and all property and assets present and future by way of assignment to tcb the goodwill and connection of the companys business please see doc M29.
    Berechtigte Personen
    • Tcb Limited
    Transaktionen
    • 08. Aug. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 30. März 1984
    Geliefert am 04. Apr. 1984
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Units land 2 lady bee industrial estate (being part of the land in title no wsx 51810).
    Berechtigte Personen
    • Midland Bank PLC
    Transaktionen
    • 04. Apr. 1984Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Juli 1983
    Geliefert am 08. Juli 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Nos 93/96 church street and 26/30 tichbourne street brighton (k/a canhams warehouse church street brighton) title no esx 84940 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company Bankers
    Transaktionen
    • 08. Juli 1983Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 07. Juli 1983
    Geliefert am 08. Juli 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Nos 20,21,22 and 23 tichbourne street, brighton title no esx 84941 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company Bankers
    Transaktionen
    • 08. Juli 1983Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Mai 1983
    Geliefert am 10. Mai 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    Land to the south east of old shoreham road, hove, east sussex title no esx 80772 (part) and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company Bankers
    Transaktionen
    • 10. Mai 1983Registrierung einer Belastung
    Legal mortgage
    Erstellt am 09. Mai 1983
    Geliefert am 10. Mai 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    33 duke street brighton east sussex title no sx 154898 and/or the proceeds of sale thereof. Floating charge over all moveable plant machinery implements utensils furniture and equipment.
    Berechtigte Personen
    • Coutts & Company Bankers
    Transaktionen
    • 10. Mai 1983Registrierung einer Belastung
    Legal charge
    Erstellt am 24. März 1983
    Geliefert am 06. Apr. 1983
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    All monies due or to become due from the company to the chargee on any account whatsoever
    Kurze Angaben
    26-30 tichbourne street and 93-96 church street and 20,21,22 and 23 tichbourne street brighton sussex together with all buildings and all fixtures whatsoever now or at any time hereafter affixed or attached to the property or any part thereof other than trade machinery as defined by section 5 of the bills of sale act 1878 as described in conveyances dated 20 nov 1946, 9 feb 1965 and 24 feb 1964.
    Berechtigte Personen
    • Dunbar and Company Limited
    Transaktionen
    • 06. Apr. 1983Registrierung einer Belastung
    Charge
    Erstellt am 10. Nov. 1982
    Geliefert am 12. Nov. 1982
    Vollständig erfüllt
    Gesicherter Betrag
    £90,000 & all other monies due or to become due from the company to the chargee
    Kurze Angaben
    33 duke street brighton title no sx 154898 land to the south of old shoreham road hove title no sx 128170.
    Berechtigte Personen
    • Reed Stenhouse Investment Services Limited
    Transaktionen
    • 12. Nov. 1982Registrierung einer Belastung

    Hat WYNCOTE GROUP PLC Insolvenzverfahren?

    AktenzeichenDatenTypRechtsanwälteAndere
    1
    DatumTyp
    15. Dez. 2004Beginn der Liquidation
    04. Apr. 2013Aufgelöst am
    Gesellschafter-freiwillige Liquidation
    NameRolleAdresseErnennung amAufgehört am
    Dermot Justin Power
    Bdo Stoy Hayward
    Commercial Buildings
    M2 1BD 11-15 Cross Street
    Manchester
    Praktiker
    Bdo Stoy Hayward
    Commercial Buildings
    M2 1BD 11-15 Cross Street
    Manchester
    David Swaden
    Bdo Stoy Hayward
    Commercial Buildings
    M2 1BD 11-15 Cross Street
    Manchester
    Praktiker
    Bdo Stoy Hayward
    Commercial Buildings
    M2 1BD 11-15 Cross Street
    Manchester
    Matthew Dunham
    Commercial Buildings 11-15 Cross Street
    M2 1BD Manchester
    Praktiker
    Commercial Buildings 11-15 Cross Street
    M2 1BD Manchester
    Patrick Alexander Lannagan
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester
    Praktiker
    3 Hardman Street
    Spinningfields
    M3 3AT Manchester

    Datenquelle

    • UK Companies House
      Das offizielle Register für Unternehmen im Vereinigten Königreich, das öffentlichen Zugang zu Unternehmensinformationen wie Namen, Adressen, Direktoren und Finanzberichten bietet.
    • Lizenz: CC0